PCV HP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPCV HP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03296331
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PCV HP LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe PCV HP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    KPMG LLP
    15 Canada Square Canary Wharf
    E14 5GL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PCV HP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FREEHOLD PORTFOLIOS HP LIMITED24 déc. 199624 déc. 1996

    Quels sont les derniers comptes de PCV HP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour PCV HP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 22 sept. 2018

    6 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 22 sept. 2017

    6 pagesLIQ03

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:secretary of state's release of liquidator
    1 pagesLIQ MISC

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 22 sept. 2016

    4 pages4.68

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order insolvency:court order - removal/ replacement of liquidator
    30 pagesLIQ MISC OC

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 22 sept. 2015

    4 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB à 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL le 12 avr. 2015

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Cavendish House 18 Cavendish Square London W1G 0PJ à 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB le 16 oct. 2014

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    7 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 23 sept. 2014

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 oct. 2013

    État du capital au 25 oct. 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2012

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nicholas Mark Leslau le 17 sept. 2012

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2011

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2010

    9 pagesAA

    Nomination de Mr David Leonard Grose en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de PCV HP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GUMM, Sandra Louise
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    Secrétaire
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    Australian57113450003
    GROSE, David Leonard
    Cavendish Square
    W1G 0PJ London
    Cavendish House 18
    Administrateur
    Cavendish Square
    W1G 0PJ London
    Cavendish House 18
    United KingdomBritish120479020002
    GUMM, Sandra Louise
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    Administrateur
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    EnglandAustralian57113450003
    LESLAU, Nicholas Mark
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    Administrateur
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    United KingdomBritish6815470021
    MOUSLEY, Emily Ann
    Flat C, 1
    Cranley Gardens, Muswell Hill
    N10 3AA London
    Administrateur
    Flat C, 1
    Cranley Gardens, Muswell Hill
    N10 3AA London
    United KingdomBritish155262770001
    LINEOBTAIN LIMITED
    Mountcliff House
    154 Brent Street
    NW4 2DR London
    Secrétaire
    Mountcliff House
    154 Brent Street
    NW4 2DR London
    87536870003
    BRADY, James Michael
    1 Cromwell Close
    AL4 9YE St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    1 Cromwell Close
    AL4 9YE St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish3769730001
    BURROWES, David William
    60 Westwater Way
    OX11 7TY Didcot
    Oxfordshire
    Administrateur
    60 Westwater Way
    OX11 7TY Didcot
    Oxfordshire
    United KingdomBritish100504300001
    EAST, Stephen John
    White Ladies
    Birch Hill Shirley Hills
    CR0 5HT Surrey
    Administrateur
    White Ladies
    Birch Hill Shirley Hills
    CR0 5HT Surrey
    EnglandBritish108586450001
    EVANS, Alasdair David
    8 Copsem Lane
    KT10 9EU Esher
    Treaton Mill
    Surrey
    Administrateur
    8 Copsem Lane
    KT10 9EU Esher
    Treaton Mill
    Surrey
    United KingdomBritish130019430001
    HARROLD, Richard Anthony
    Hill House Farm
    Brandon Parva
    NR9 4DL Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Hill House Farm
    Brandon Parva
    NR9 4DL Norwich
    Norfolk
    British33048780001
    LEWIS, Gavin Andrew
    10 Penners Gardens
    KT6 6JW Surbiton
    Surrey
    Administrateur
    10 Penners Gardens
    KT6 6JW Surbiton
    Surrey
    British93017010002
    RITBLAT, James William Jeremy
    24 St Petersburgh Place
    W2 4LB London
    Administrateur
    24 St Petersburgh Place
    W2 4LB London
    EnglandBritish38424950003
    WAGMAN, Colin Barry
    North Lodge
    25 Ringwood Avenue
    N2 9NT London
    Administrateur
    North Lodge
    25 Ringwood Avenue
    N2 9NT London
    United KingdomBritish39329840001
    WARE, Robert Thomas Ernest
    Woodley Lodge
    Duffield Road
    RG5 4RL Woodley
    Berkshire
    Administrateur
    Woodley Lodge
    Duffield Road
    RG5 4RL Woodley
    Berkshire
    United KingdomBritish4779170003
    FP FINANCIAL LDC
    Caledonian House
    Mary Street
    Georgetown
    Grand Cayman
    Cayman Islands
    Administrateur
    Caledonian House
    Mary Street
    Georgetown
    Grand Cayman
    Cayman Islands
    49335910001

    PCV HP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Supplemental debenture
    Créé le 28 mars 2003
    Livré le 15 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All shares held by the company and/or any nominee on it's behalf and all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft London Branch,(As Agent and Trustee for the Finance Parties)
    Transactions
    • 15 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 30 juil. 2001
    Livré le 02 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to each finance party under each finance document (all terms as defined)
    Brèves mentions
    The f/h property k/a 73 and 75 high street,rhyl title absolute under t/n WA493457 for further details of all property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft as Agent and Trustee Tothe Finance Parties (The Agent)
    Transactions
    • 02 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture between the company (formerly known as freehold portfolios hp limited) each chargor and the security trustee
    Créé le 09 févr. 2000
    Livré le 21 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities whather actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor to a). Each senior finance party under each senior finance document; or b). Each mezzanine finance party under each mezzanine finance document except for any obligation which, if it were so included, would result in the debenture contravening section 151 of the companies act 1985.
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutchen Bank, London Branch(As Agent and Trustee for the Senior Finance Parties and the Mezzanine Finance Parties)
    Transactions
    • 21 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment
    Créé le 22 juin 1999
    Livré le 08 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from touchdown co.limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of touchdown co.limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to the chargee as trustee for itself and the other lenders ("trustee") or the trustee, norwich union mortgage finance limited any company which is or becomes a holding company of any such company of subsidiary or associate of any such company or holding company which lends or has lent to, or is at any time owed monies by, any group member ("lenders") or for or in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lenders on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Assigned by way of charge all the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due owing or incurred to the company under the occupational lease/s in respect of: 53 high street newcastle under lyme,64 high street and black swan yard andover,53/55 high street goldaming,2/3 west street farnham,41 fore street trowbridge.for further details of property charged please refer to form 395.other than sums due to the company by way of insurance rent service charge or any vat payable to the company thereon including the right to receive the same and the full benefit of any guarantee or security and any proceeds of the forgoing.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgages (Life) Limited
    Transactions
    • 08 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of legal charge
    Créé le 22 juin 1999
    Livré le 08 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from touchdown co.limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of touchdown co.limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to the chargee as trustee for itself and the other lenders ("trustee") or the trustee, norwich union mortgage finance limited any company which is or becomes a holding company of any such company of subsidiary or associate of any such company or holding company which lends or has lent to, or is at any time owed monies by, any group member ("lenders") or for or in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lenders on any account whatsoever
    Brèves mentions
    53 high street newcastle under lyme-SF260136;53/55 high street godalming-SY287174;2/3 west street farnham-SY149465 and SY494929 for further details of property charged please refer to form 395.together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) and fitting thereon and all improvements and additions thereto and all easements rights and licences appurtenant thereto, all monies deposited with the trustee on the terms set out in schedule 6 to the deed, floating charge the whole of the property, assets, rights and revenues including the uncalled share capital (if any).
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgages (Life) Limited
    Transactions
    • 08 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental deed
    Créé le 12 janv. 1999
    Livré le 27 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to the legal charge dated 4TH february 1997
    Brèves mentions
    41 fore street trowbridge wiltshire WT145469,11 exchange walk nottingham NT304339,8 high street banbury t/n ON132306 and other properties with all buildings erection fixtures fittings underleases and agreement please refer to form 395 for details of further chrged properties and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgages (General) Limitedas Trustee for Itself and Any Other Lender or Any Lender
    Transactions
    • 27 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental deed
    Créé le 31 oct. 1997
    Livré le 19 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for itself and any other lender or any lender supplemental to the legal charge dated 4TH february 1997
    Brèves mentions
    F/H land being 48/50 south street romford egl 207769 with all buildings erections and fixtures (inc, trade fixtures) fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgages (General) Limited
    Transactions
    • 19 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment and release
    Créé le 31 oct. 1997
    Livré le 19 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for itself and any other lender or any lender supplemental to the legal charge dated 4TH february 1997
    Brèves mentions
    The rents arising in respect of 48/50 south street romford egl 207769.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgages (General) Limited
    Transactions
    • 19 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignation of rents
    Créé le 17 févr. 1997
    Livré le 26 févr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any lender (as defined) or for or in respect of which the company may be liable to the chargee or any lender on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The whole right title and interest in the assigned rights being all the rights titles benefits and interests of the company to the rents including the rights to receive the same and the full benefit of any guarantee or security for the performance thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage (General) Limitedas Trustee for Itself and the Other Lenders ("the Trustee")
    Transactions
    • 26 févr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of legal charge
    Créé le 04 févr. 1997
    Livré le 20 févr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The properties being 76/76A high street, newmarket-SKJ154736 and the other properties described on the schedule attached to the form M395 with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants' fixtures) and fittings thereon, rights, licences, leases and a floating charge over all property, assets, rights and revenues including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgages (General) Limited
    Transactions
    • 20 févr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 janv. 1998Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 27 mars 1999Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 08 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment by way of charge
    Créé le 04 févr. 1997
    Livré le 20 févr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By clause 2 of the assignment all rights, titles, benefits and interests to all monies incurred to the company under occupational lease/s in respect of 76/76A high street, newmarket-SKJ154736 and the other properties described in the schedule attached to the form M395. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgages (General) Limited
    Transactions
    • 20 févr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 janv. 1998Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 27 mars 1999Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 08 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on 13TH february 1997
    Créé le 03 févr. 1997
    Livré le 25 févr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and whole those shop premises with ancillary storage and office accomodation on basement ground and first floors in the burgh of falkirk and county of stirling now generally known as numbers one hundred and eighteen to one hundred and twenty high street falkirk t/n stg 10222.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgages (General) Limitedas Trustee for Itself and Others
    Transactions
    • 25 févr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    PCV HP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    01 févr. 2019Dissolved on
    23 sept. 2014Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Mark Jeremy Orton
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    practitioner
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Allan Watson Graham
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0