PARKWOOD SINCLAIR INSURANCE BROKERS LIMITED

PARKWOOD SINCLAIR INSURANCE BROKERS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPARKWOOD SINCLAIR INSURANCE BROKERS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03300403
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PARKWOOD SINCLAIR INSURANCE BROKERS LIMITED ?

    • Assurance non-vie (65120) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe PARKWOOD SINCLAIR INSURANCE BROKERS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hardwick House
    Prospect Place
    SN1 3LJ Swindon
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PARKWOOD SINCLAIR INSURANCE BROKERS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PARKWOOD SINCLAIR LIMITED09 janv. 199709 janv. 1997

    Quels sont les derniers comptes de PARKWOOD SINCLAIR INSURANCE BROKERS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2015

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour PARKWOOD SINCLAIR INSURANCE BROKERS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour PARKWOOD SINCLAIR INSURANCE BROKERS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2015

    7 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 30 mars 2015

    • Capital: GBP 1.00
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Phillipa Jane Sherman en tant que directeur le 02 mars 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 janv. 2015

    État du capital au 19 janv. 2015

    • Capital: GBP 6,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014

    7 pagesAA

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 janv. 2014

    État du capital au 15 janv. 2014

    • Capital: GBP 6,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2013

    4 pagesAA

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    2 pagesAD02

    Nomination de Mr Brian John Clements en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Peake Company Secretaries Limited en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Carlo Domenica Marelli le 17 déc. 2012

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2012

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2010

    12 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de PARKWOOD SINCLAIR INSURANCE BROKERS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CLEMENTS, Brian John
    Boundary Way
    HP2 7YU Hemel Hempstead
    Hemel One
    Hertfordshire
    England
    Secrétaire
    Boundary Way
    HP2 7YU Hemel Hempstead
    Hemel One
    Hertfordshire
    England
    176883870001
    BRAY, Matthew David
    The Green
    LU7 0RJ Cheddington
    1a
    Bedfordshire
    Administrateur
    The Green
    LU7 0RJ Cheddington
    1a
    Bedfordshire
    EnglandBritish146906310001
    MARELLI, Carlo
    Bedford Avenue
    EN5 2ES Barnet
    69
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Bedford Avenue
    EN5 2ES Barnet
    69
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish327740810001
    MCMAHON, Andrew Neil Mcintyre
    39 Lynwood Grove
    BR6 0BD Orpington
    Kent
    Secrétaire
    39 Lynwood Grove
    BR6 0BD Orpington
    Kent
    British75598460002
    STEBBING, David Colin
    134 Priests Lane
    CM15 8HN Shenfield
    Essex
    Secrétaire
    134 Priests Lane
    CM15 8HN Shenfield
    Essex
    British48368000001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secrétaire désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    PEAKE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Prospect Place
    SN1 3LJ Swindon
    Hardwick House
    Wiltshire
    Secrétaire
    Prospect Place
    SN1 3LJ Swindon
    Hardwick House
    Wiltshire
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement01887672
    55731680011
    PRIMARY GROUP SERVICES LIMITED
    10 King William Street
    EC4N 7TW London
    Secrétaire
    10 King William Street
    EC4N 7TW London
    107712310001
    BATTLE, David Charles
    1 Bakers Close
    RH7 6HF Lingfield
    Surrey
    Administrateur
    1 Bakers Close
    RH7 6HF Lingfield
    Surrey
    UkBritish111477590001
    BEAUMONT, Peter Stuart
    Badgers Hollow
    Rowhills
    GU9 9AU Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Badgers Hollow
    Rowhills
    GU9 9AU Farnham
    Surrey
    British78770280001
    COOMBER, Karen Maria
    Moorhams Avenue
    Hatch Warren
    RG22 4YG Basingstoke
    7
    Hampshire
    Administrateur
    Moorhams Avenue
    Hatch Warren
    RG22 4YG Basingstoke
    7
    Hampshire
    EnglandBritish100159270003
    EDMANDS, David James Rosewall
    16 Kings Chase
    TN24 0LQ Ashford
    Kent
    Administrateur
    16 Kings Chase
    TN24 0LQ Ashford
    Kent
    United KingdomBritish118042260001
    GILES, Stephen
    99 Hawthorns
    Charvil
    RG10 9TT Reading
    Berkshire
    Administrateur
    99 Hawthorns
    Charvil
    RG10 9TT Reading
    Berkshire
    EnglandBritish108158380001
    HODES, Jonathan
    81 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1LX London
    Administrateur
    81 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1LX London
    British79523100001
    LISTER, Martin Ernest
    677 Galleywood Road
    CM2 8BT Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    677 Galleywood Road
    CM2 8BT Chelmsford
    Essex
    EnglandBritish48368080001
    MCKEOWN, Ronan Jeremy
    Valley Barn, Sandhurst Lane
    Sandhurst
    GL2 9NR Gloucester
    Gloucestershire
    Administrateur
    Valley Barn, Sandhurst Lane
    Sandhurst
    GL2 9NR Gloucester
    Gloucestershire
    United KingdomBritish108155570001
    MCMAHON, Andrew Neil Mcintyre
    39 Lynwood Grove
    BR6 0BD Orpington
    Kent
    Administrateur
    39 Lynwood Grove
    BR6 0BD Orpington
    Kent
    EnglandBritish75598460002
    PIPER, Ian Kenneth
    44 Cromwell Avenue
    CM12 0AE Billericay
    Essex
    Administrateur
    44 Cromwell Avenue
    CM12 0AE Billericay
    Essex
    British8074420004
    SCREEN, Robert Charles
    Lye Hill Farm
    Compton Dando
    BS39 4LG Bristol
    Avon
    Administrateur
    Lye Hill Farm
    Compton Dando
    BS39 4LG Bristol
    Avon
    United KingdomBritish92544740001
    SHERMAN, Phillipa Jane
    Penny Croft
    AL5 2PB Harpenden
    22
    Hertfordshire
    Administrateur
    Penny Croft
    AL5 2PB Harpenden
    22
    Hertfordshire
    United KingdomBritish147080420001
    STEBBING, David Colin
    134 Priests Lane
    CM15 8HN Shenfield
    Essex
    Administrateur
    134 Priests Lane
    CM15 8HN Shenfield
    Essex
    British48368000001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Administrateur désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    PARKWOOD SINCLAIR INSURANCE BROKERS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A composite debenture
    Créé le 14 nov. 2008
    Livré le 18 nov. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each charging company to the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for and on Behalf of the Secured Parties
    Transactions
    • 18 nov. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 30 janv. 2007
    Livré le 15 févr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    (For details of properties charged please refer to the form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse,London Branch (Security Agent)
    Transactions
    • 15 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 19 juin 1998
    Livré le 15 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The freehold property known as 29 kings road brentwood title number EX276194. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 15 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0