AURORA UK ALPHA PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAURORA UK ALPHA PLC
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 03300814
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AURORA UK ALPHA PLC ?

    • Activités des sociétés d'investissement mobilier (64301) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe AURORA UK ALPHA PLC ?

    Adresse du siège social
    25 Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AURORA UK ALPHA PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    AURORA INVESTMENT TRUST PLC07 févr. 199707 févr. 1997
    SAVETOP PUBLIC LIMITED COMPANY10 janv. 199710 janv. 1997

    Quels sont les derniers comptes de AURORA UK ALPHA PLC ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour AURORA UK ALPHA PLC ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au21 janv. 2027
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation04 févr. 2027
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au21 janv. 2026
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour AURORA UK ALPHA PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 1,164,087.5
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    14 avr. 2026Clarification HMRC - CONFIRMATION RECEIVED THAT APPROPRIATE DUTY THAT HAS BEEN PAID ON THIS TRANSACTION

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 1,129,706
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    05 févr. 2026Clarification HMRC - CONFIRMATION RECEIVED THAT APPRORIATE DUTY THAT HAS BEEN PAID ON HIS TRANSACTION

    Déclaration de confirmation établie le 21 janv. 2026 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 1,124,706
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    20 janv. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate Stamp Duty has been paid on this transaction.

    Nomination de Mr Alexander Stephen Denny en tant qu'administrateur le 01 janv. 2026

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Clive Stevenson en tant que directeur le 31 déc. 2025

    1 pagesTM01

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 1,094,706
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    02 janv. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate Stamp Duty has been paid on this transaction.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 980,847.25
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    09 déc. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 1,059,706
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    09 déc. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 900,847.25
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    02 déc. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 862,147.75
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    21 nov. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 783,769
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    17 nov. 2025Clarification HMRC - CONFIRMATION RECIEVED THAT APPRORITE DUTY THAT HAS BEEN PAID ON THIS TRANSACTION.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 738,769
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    10 nov. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 684,823.25
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    24 oct. 2025Clarification HMRC - CONFIRMATION RECEIVED THAT APPROPRIATE DUTY HAS BEEN PAID ON THIS TRANSACTION

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 566,932
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    07 oct. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 449,915.75
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    15 sept. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 217,798.25
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    18 août 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 150,298.25
    4 pagesSH03

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    capital

    Résolutions

    Agm notice 11/06/2025
    RES13
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Deuxième dépôt d'un bilan du capital suite à une émission d'actions au 29 nov. 2024

    • Capital: GBP 28,665,459.50
    12 pagesRP04SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2024

    107 pagesAA

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Link Group Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL United Kingdom à Mufg Corporate Markets Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL

    1 pagesAD02

    Déclaration de confirmation établie le 21 janv. 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Annulation d'actions par une SA. État du capital au 15 janv. 2025

    • Capital: GBP 28,643,185.50
    4 pagesSH07

    État du capital après une attribution d'actions au 29 nov. 2024

    • Capital: GBP 28,665,459.5
    7 pagesSH01
    Annotations
    DateAnnotation
    28 mai 2025Clarification A second filed SH01 was registered on 28/05/25.

    Qui sont les dirigeants de AURORA UK ALPHA PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LLP, Frostrow Capital
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    England
    Secrétaire
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    England
    300571710001
    BUCKLEY, Farah Adiba
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    England
    Administrateur
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    England
    EnglandBritish281415060001
    DENNY, Alexander Stephen
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    England
    Administrateur
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    England
    EnglandBritish320946480002
    ROBATHAN, Rachael, Lady
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    England
    Administrateur
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    England
    United KingdomBritish201518400001
    WALKER, Lucy Harriet
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    England
    Administrateur
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    England
    United KingdomBritish235621140001
    CAVENDISH ADMINISTRATION LIMITED
    2 Puddle Dock
    EC4V 3DB London
    Mermaid House
    England
    Secrétaire
    2 Puddle Dock
    EC4V 3DB London
    Mermaid House
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement02840515
    54772090001
    CMH SECRETARIES LTD
    Sceptre Court 40 Tower Hill
    EC3N 4BB London
    Secrétaire
    Sceptre Court 40 Tower Hill
    EC3N 4BB London
    41863710001
    SANNE FUND SERVICES (UK) LIMITED
    125 London Wall
    EC2Y 5AS London
    6th Floor
    England
    Secrétaire
    125 London Wall
    EC2Y 5AS London
    6th Floor
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement9879916
    206308610002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ADAMS, Brian Roger
    Hill House
    Church Lane Debpen
    CB11 3LD Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    Hill House
    Church Lane Debpen
    CB11 3LD Saffron Walden
    Essex
    British34843120001
    ARTHUR, Terence Gordon
    23 St Marys Street
    PE9 2DG Stamford
    Lincs
    Administrateur
    23 St Marys Street
    PE9 2DG Stamford
    Lincs
    British14289720001
    BARSTOW, Michael James
    48 Redan Street
    W14 0AB London
    Administrateur
    48 Redan Street
    W14 0AB London
    EnglandBritish29122910001
    CHAPPLE, Tristan John
    2 Puddle Dock
    EC4V 3DB London
    Mermaid House
    England
    Administrateur
    2 Puddle Dock
    EC4V 3DB London
    Mermaid House
    England
    EnglandBritish204667430001
    FLIGHT, Howard Emerson, Lord
    London Wall
    EC2Y 5AS London
    6th Floor, 125
    England
    Administrateur
    London Wall
    EC2Y 5AS London
    6th Floor, 125
    England
    EnglandBritish71333400002
    GAUNT, Paul
    90 Newmarket Road
    NR2 2LB Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    90 Newmarket Road
    NR2 2LB Norwich
    Norfolk
    British45788750002
    HAMMOND CHAMBERS, Robert Alexander
    3 Liberton Tower Lane
    EH16 6TQ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    3 Liberton Tower Lane
    EH16 6TQ Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish86215110001
    HEATHCOAT AMORY, Michael Fitzgerald
    2 Montrose Court
    Exhibition Road
    SW7 2QH London
    Administrateur
    2 Montrose Court
    Exhibition Road
    SW7 2QH London
    UkBritish44246540007
    HUNTER, David Haig
    39 Dovehouse Street
    SW3 6JY London
    Administrateur
    39 Dovehouse Street
    SW3 6JY London
    United KingdomBritish29433770002
    MARTIN, Richard Macintyre
    2 Puddle Dock
    EC4V 3DB London
    Mermaid House
    England
    Administrateur
    2 Puddle Dock
    EC4V 3DB London
    Mermaid House
    England
    ScotlandBritish671750003
    NELSON, James Jonathan, The Hon
    London Wall
    EC2Y 5AS London
    6th Floor, 125
    England
    Administrateur
    London Wall
    EC2Y 5AS London
    6th Floor, 125
    England
    United KingdomBritish113284780001
    ROBINSON, Richard Edwin Winwood
    Sandings Farm Chapel Leigh
    Lydeard St Lawrence
    TA4 3RD Taunton
    Somerset
    Administrateur
    Sandings Farm Chapel Leigh
    Lydeard St Lawrence
    TA4 3RD Taunton
    Somerset
    United KingdomBritish201823830001
    STEVENSON, David Clive
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    England
    Administrateur
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    England
    United KingdomBritish72686590005
    STUTTAFORD, William Royden, Sir
    Moulshams Manor
    Great Wigborough
    CO5 7RL Colchester
    Essex
    Administrateur
    Moulshams Manor
    Great Wigborough
    CO5 7RL Colchester
    Essex
    British6071220001
    TATTERS, Steven David
    2 Puddle Dock
    EC4V 3DB London
    Mermaid House
    England
    Administrateur
    2 Puddle Dock
    EC4V 3DB London
    Mermaid House
    England
    EnglandBritish101633200001
    VAUGHAN, Margaret Helen
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    England
    Administrateur
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    England
    WalesBritish298968130002
    CMH DIRECTORS LIMITED
    Sceptre Court 40 Tower Hill
    EC3N 4BB London
    Administrateur
    Sceptre Court 40 Tower Hill
    EC3N 4BB London
    41863750001
    CMH SECRETARIES LTD
    Sceptre Court 40 Tower Hill
    EC3N 4BB London
    Administrateur
    Sceptre Court 40 Tower Hill
    EC3N 4BB London
    41863710001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Administrateur désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0