CHAPELWOOD HOMES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCHAPELWOOD HOMES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03303786
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CHAPELWOOD HOMES LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe CHAPELWOOD HOMES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Berry & Co Sterling House
    7 Ashford Road
    ME14 5BJ Maidstone
    Kent
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CHAPELWOOD HOMES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TILSDEN BARNS LIMITED17 janv. 199717 janv. 1997

    Quels sont les derniers comptes de CHAPELWOOD HOMES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour CHAPELWOOD HOMES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 oct. 2022

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 févr. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de 7 Clarendon Place King Street Maidstone ME14 1BQ England à Berry & Co Sterling House 7 Ashford Road Maidstone Kent ME14 5BJ le 31 mai 2022

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 oct. 2021

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 févr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 oct. 2020

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 févr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de Boundary Frith 147a Forest Road Tunbridge Wells Kent TN2 5EX à 7 Clarendon Place King Street Maidstone ME14 1BQ le 23 févr. 2021

    1 pagesAD01

    Satisfaction de la charge 033037860022 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 23 févr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 oct. 2019

    7 pagesAA

    Comptes d'exonération totale établis au 31 oct. 2018

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 févr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 oct. 2017

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 févr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 033037860021 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2016

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 févr. 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Inscription de la charge 033037860022, créée le 21 oct. 2016

    8 pagesMR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2015

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 mars 2016

    État du capital au 07 mars 2016

    • Capital: GBP 4
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2014

    7 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de CHAPELWOOD HOMES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HOLLANDS, Russell
    Sterling House
    7 Ashford Road
    ME14 5BJ Maidstone
    Berry & Co
    Kent
    England
    Secrétaire
    Sterling House
    7 Ashford Road
    ME14 5BJ Maidstone
    Berry & Co
    Kent
    England
    British82081780004
    HOLLANDS, Janet Elizabeth
    Sterling House
    7 Ashford Road
    ME14 5BJ Maidstone
    Berry & Co
    Kent
    England
    Administrateur
    Sterling House
    7 Ashford Road
    ME14 5BJ Maidstone
    Berry & Co
    Kent
    England
    EnglandBritishFinance Director61438100008
    HOLLANDS, Russell Vincent
    Sterling House
    7 Ashford Road
    ME14 5BJ Maidstone
    Berry & Co
    Kent
    England
    Administrateur
    Sterling House
    7 Ashford Road
    ME14 5BJ Maidstone
    Berry & Co
    Kent
    England
    EnglandBritishCompany Director82081780008
    CARTER, Michael Charles
    Church View Capel Manor
    Horsmonden
    TN12 8BG Tonbridge
    Kent
    Secrétaire
    Church View Capel Manor
    Horsmonden
    TN12 8BG Tonbridge
    Kent
    BritishSurveyor50123520001
    GLOVER, Janet Elizabeth
    Walnut Tree House Maidstone Road
    TN12 7LW Matfield
    Kent
    Secrétaire
    Walnut Tree House Maidstone Road
    TN12 7LW Matfield
    Kent
    British61438100001
    TOMS, Maria
    44 Cerne Road
    DA12 4BW Gravesend
    Kent
    Secrétaire
    44 Cerne Road
    DA12 4BW Gravesend
    Kent
    British55280570001
    ARM SECRETARIES LIMITED
    Somers
    Mounts Hill
    TN17 4ET Benenden
    Kent
    Secrétaire désigné
    Somers
    Mounts Hill
    TN17 4ET Benenden
    Kent
    900006820001
    CARTER, Michael Charles
    Church View Capel Manor
    Horsmonden
    TN12 8BG Tonbridge
    Kent
    Administrateur
    Church View Capel Manor
    Horsmonden
    TN12 8BG Tonbridge
    Kent
    BritishConstruction50123520001
    HOLLANDS, Russell
    5 Nettlestead Court
    Nettlestead
    ME18 5HA Maidstone
    Kent
    Administrateur
    5 Nettlestead Court
    Nettlestead
    ME18 5HA Maidstone
    Kent
    BritishConstruction82081780001
    MILNE, Alan Robert
    Somers
    Mounts Hill
    TN17 4ET Benenden
    Kent
    Administrateur désigné
    Somers
    Mounts Hill
    TN17 4ET Benenden
    Kent
    British900006810001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CHAPELWOOD HOMES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Russell Vincent Hollands
    Sterling House
    7 Ashford Road
    ME14 5BJ Maidstone
    Berry & Co
    Kent
    England
    06 avr. 2016
    Sterling House
    7 Ashford Road
    ME14 5BJ Maidstone
    Berry & Co
    Kent
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    Mrs Janet Elizabeth Hollands
    Sterling House
    7 Ashford Road
    ME14 5BJ Maidstone
    Berry & Co
    Kent
    England
    06 avr. 2016
    Sterling House
    7 Ashford Road
    ME14 5BJ Maidstone
    Berry & Co
    Kent
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.

    CHAPELWOOD HOMES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 21 oct. 2016
    Livré le 24 oct. 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Land at manor nurseries, eridge road, crowborough kent TN6 2SS and TN6 2SR.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Company
    Transactions
    • 24 oct. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 08 janv. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 28 nov. 2014
    Livré le 03 déc. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Keymer road, burgess hill, west sussex RH15 0AN registered under title no. WSX327272.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Company
    Transactions
    • 03 déc. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 oct. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 19 avr. 2011
    Livré le 23 avr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land to the rear of 7 willow vale chislehurst kent and land providing access via 36 empress drive chislehurst kent, being part of the land registered under t/no SGL614362 and part of the land registered under t/no SGL144370; by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Company
    Transactions
    • 23 avr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 20 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 19 avr. 2011
    Livré le 20 avr. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Coutts & Company
    Transactions
    • 20 avr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Direct and third party legal charge
    Créé le 25 avr. 2008
    Livré le 14 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company & astindale properties limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The land at rear of 123, 125, 127, 129 and 131 blackbrook lane and land at 10 and 15 newhams close bickley see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 déc. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 03 mai 2007
    Livré le 11 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    285 285A and 287 main road sidcup kent. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 31 juil. 2006
    Livré le 18 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    115 wansunt road, bexley. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Direct and third party legal charge (trustee and beneficiary)
    Créé le 28 févr. 2006
    Livré le 02 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the north west side of broadwater down t/n K621999. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 02 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 08 avr. 2005
    Livré le 12 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    64 craven road orpington kent. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge of securities (UK)
    Créé le 30 sept. 2004
    Livré le 08 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge any stocks shares bonds or warrants or securities (certificated or uncertificated) which are from time to time named in any schedule supplied by or on behalf of the company to the bank by reference to the charge of securities or in respect of which title or the relevant account entries is/are held in the name of or to the order of the bank or its nominee or in respect of which the relevant certificates or other title documents are deposited with or held to the order of the bank or its nominee together with all income derived from and rights attaching to the same.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 21 nov. 2003
    Livré le 22 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land adjoining greenmount white post lane cobham kent. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 14 mars 2003
    Livré le 18 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property k/a land at the rear of 219 hadlow road, tonbridge, kent. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Direct and third party legal charge
    Créé le 14 févr. 2003
    Livré le 04 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Station house cridge road beckenham kent t/n SGL637047 and all covenants and rights the proceeds of insurance.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge of securities (UK)
    Créé le 14 févr. 2003
    Livré le 04 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any stocks shares bonds warrants or securites issued in respect of remerwood limited with all income derived therefrom.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage deed
    Créé le 07 juin 2002
    Livré le 27 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold land adjoining and forming part of hulse orchard common lane wilmington kent; part k 327850. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 27 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 21 mars 2002
    Livré le 03 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Clagget house biddenden road smarden kent t/no;-K283293. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 20 août 2001
    Livré le 21 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a land adjoining 1 frank woolley road tonbridge kent t/n K46423. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 21 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 09 mai 2001
    Livré le 17 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a development plot at the rear of 32 to 34 dry hill park road tonbridge kent t/no: K29650. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage deed
    Créé le 22 sept. 2000
    Livré le 26 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold property known as 7 and 9 maude rd,hextable,swanley kent BR8 7SJ. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 26 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 06 oct. 1999
    Livré le 08 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land adjoining 22 manor close wilmington kent t/no K60240. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 08 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 09 juil. 1999
    Livré le 15 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 55 old hadlow road tonbridge kent (including land to the rear) t/no: K489883. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 15 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 04 août 1997
    Livré le 12 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land adjacent (plot 1) to streets end/little streets end trottiscliffe kent (freehold). With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 12 août 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0