STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03311644 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED ?
| Adresse du siège social | 2-3 Pavilion Buildings BN1 1EE Brighton East Sussex |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 16 pages | 4.71 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 mars 2017 | 15 pages | 4.68 | ||||||||||
Statuts | 26 pages | MA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Venture House 27/29 Glasshouse Street London W1B 5DF à 2-3 Pavilion Buildings Brighton East Sussex BN1 1EE le 19 avr. 2016 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Nomination de Mr Peter John Sharpe Turner en tant qu'administrateur le 04 mars 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Sarah Jean Webb en tant que directeur le 04 mars 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Carol Gillian Williams en tant que directeur le 04 mars 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Garnett Wade en tant que directeur le 04 mars 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard James Turner en tant que directeur le 04 mars 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Peter John Sharpe Turner en tant que directeur le 04 mars 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Kevin Spruce en tant que directeur le 04 mars 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Stephen Skelton en tant que directeur le 04 mars 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Clive Richardson en tant que directeur le 04 mars 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stephen Norton Ray en tant que directeur le 04 mars 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard William Antranik Pyne en tant que directeur le 04 mars 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Neale Todd Plant en tant que directeur le 04 mars 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Niral Harshadbhai Patel en tant que directeur le 04 mars 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Robert Fredric Victor Perry en tant que directeur le 04 mars 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Niall Mcguinness en tant que directeur le 04 mars 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Haydon Lee Murton en tant que directeur le 04 mars 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Scanlan Mcfadden en tant que directeur le 04 mars 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHOLEFIELD, Andrew | Secrétaire | Pavilion Buildings BN1 1EE Brighton 2-3 East Sussex | 182004020001 | |||||||
| CLARK, Martin Robert | Administrateur | Pavilion Buildings BN1 1EE Brighton 2-3 East Sussex | England | British | 60233030002 | |||||
| GODFREY, Adam Barnaby | Administrateur | Pavilion Buildings BN1 1EE Brighton 2-3 East Sussex | United Kingdom | British | 52957710002 | |||||
| STAPLETON, Richard Harvey | Administrateur | Pavilion Buildings BN1 1EE Brighton 2-3 East Sussex | United Kingdom | British | 52691090001 | |||||
| TURNER, Peter John Sharpe | Administrateur | Pavilion Buildings BN1 1EE Brighton 2-3 East Sussex | England | British | 59460040001 | |||||
| DAGWELL, Robert Shawn | Secrétaire | 61 Copse Avenue Layhams Road BR4 9HN West Wickham Kent | British | 148874200001 | ||||||
| POLLARD, Remi Constant Chenery | Secrétaire | 6 Babmaes Street London SW1Y 6HD | British | 52691060001 | ||||||
| M W DOUGLAS & COMPANY LIMITED | Secrétaire désigné | Regent House 316 Beulah Hill SE19 3HP London | 900007890001 | |||||||
| ALLEN-SHALLESS, Trudi Jane | Administrateur | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | England | British | 21506920002 | |||||
| ASBURY, Ian | Administrateur | North Bank House Cross Hill Road OX17 3EQ West Adderbury Oxfordshire | British | 93810120001 | ||||||
| BARKER, Neil Stewart | Administrateur | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | United Kingdom | British | 127956210002 | |||||
| BRADBEER, Nicholas Charles | Administrateur | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | United Kingdom | British | 71855470002 | |||||
| BRADLEY SMITH, Robert Charles | Administrateur | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | United Kingdom | British | 82523240002 | |||||
| CANNING, Spencer George Stratford De Redcliffe, Hon | Administrateur | 1 Church Street Little Bedwyn SN8 3JQ Marlborough Wiltshire | United Kingdom | British | 37931560001 | |||||
| CANTWELL, Philip Joseph | Administrateur | 8 Oak Ridge West End GU24 9PJ Woking Surrey | British | 66803840001 | ||||||
| CLARK, Vanessa Elizabeth | Administrateur | 11 Annandale Road Chiswick W4 2HE London | England | British | 56357200002 | |||||
| CLEVERTON, John Neil | Administrateur | Maycroft Muddles Green BN21 4UP Chiddingly East Sussex | United Kingdom | British | 8500140003 | |||||
| COLDBREATH, Peter Stuart | Administrateur | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | United Kingdom | British | 86987380002 | |||||
| COOMBER, Ian Frederick | Administrateur | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | England | British | 150632140001 | |||||
| COTTELL, Peter Michael | Administrateur | 6 Troymede RH17 6LU Haywards Heath West Sussex | England | British | 115306040001 | |||||
| COX, Howard Ashley | Administrateur | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | United Kingdom | British | 123098020001 | |||||
| DAGWELL, Robert Shawn | Administrateur | 61 Copse Avenue Layhams Road BR4 9HN West Wickham Kent | British | 148874200001 | ||||||
| DAVIES, John Simon | Administrateur | 9 Hyde Park Crescent W2 2PY London | England | British | 10482150004 | |||||
| DICKMAN, Jonathan Saul | Administrateur | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | United Kingdom | British | 110260430001 | |||||
| ENGLISH, Greville John Reginald | Administrateur | Glebe Cottage 31 Lower Street RH20 2BH Pulborough West Sussex | British | 59459880004 | ||||||
| EVANS, Nigel John Wilson | Administrateur | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | England | British | 59459500001 | |||||
| FLETCHER, Trevor Peter | Administrateur | 37 Newbolt Avenue SM3 8ED Cheam Surrey | British | 95383350001 | ||||||
| FORD, Nigel Kevin | Administrateur | 67 Stamford Green Road KT18 7SR Epsom Surrey | British | 59460170002 | ||||||
| GREENWOOD, Timothy Ian | Administrateur | 46 Bonehurst Road RH6 8QG Horley Surrey | United Kingdom | British | 74487050002 | |||||
| HADDEN, David George | Administrateur | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | England | British | 62211360001 | |||||
| HAMMOND, John Philip Arthur | Administrateur | The Bothy Tandridge Court Tandridge Lane RH8 9NJ Oxted | England | British | 52957650002 | |||||
| HARDWICKE, Timothy Robert | Administrateur | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | United Kingdom | British | 98537020002 | |||||
| HEARD, Robert William | Administrateur | Brook Cottage Wilton SN8 3SS Marlborough Wiltshire | British | 72313470001 | ||||||
| HITCH, Nicholas Charles | Administrateur | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | Uk | British | 60750750002 | |||||
| HUNT, Simon Russell | Administrateur | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | Uk | British | 110260330001 |
STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 06 janv. 2012 Livré le 12 janv. 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Rent deposit deed | Créé le 29 juin 1999 Livré le 03 juil. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti £44,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions The rent deposit and the deposit balance with full guarantee as security for the performance of the obligations of the tenant under the lease. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 02 févr. 1999 Livré le 04 févr. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 28 avr. 1997 Livré le 30 avr. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an assets purchase agreement dated 28TH april 1997 | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0