MILLCROFT INVESTMENTS LIMITED

MILLCROFT INVESTMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMILLCROFT INVESTMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03312415
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MILLCROFT INVESTMENTS LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières
    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe MILLCROFT INVESTMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    284 Clifton Drive South
    FY8 1LH Lytham St. Annes
    Lancashire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de MILLCROFT INVESTMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 févr. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour MILLCROFT INVESTMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de compte final avant dissolution

    14 pagesWU15

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    11 pagesWU07

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    11 pagesWU07

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    12 pagesWU07

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    11 pagesWU07

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    11 pagesWU07

    Changement d'adresse du siège social de Hamilton House 4a the Avenue London E4 9LD à 284 Clifton Drive South Lytham St. Annes Lancashire FY8 1LH le 14 juin 2017

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur

    3 pagesWU04

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    2 pagesCOCOMP

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 janv. 2016

    État du capital au 24 janv. 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Nomination de Mr David Trejo en tant qu'administrateur le 21 janv. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Simon Bester en tant que secrétaire le 21 janv. 2016

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Vernon Leonard Rupesinghe en tant que directeur le 21 janv. 2016

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 28 févr. 2015

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 mars 2015

    État du capital au 06 mars 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 28 févr. 2014

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 avr. 2014

    État du capital au 15 avr. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 28 févr. 2013

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 28 févr. 2012

    4 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 28 févr. 2011

    4 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de MILLCROFT INVESTMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TREJO, David, Mr.
    c/o Compass International S.R.O.
    Zamocka
    81101 Bratislava
    30
    Slovakia
    Administrateur
    c/o Compass International S.R.O.
    Zamocka
    81101 Bratislava
    30
    Slovakia
    MexicoMexicanDirector203467030001
    BESTER, Simon
    Mapesbury Road
    NW2 4HS London
    33
    Secrétaire
    Mapesbury Road
    NW2 4HS London
    33
    British137774360001
    DE RUN, Dinah Rose Marion
    42 Percival Gardens
    RM6 5RJ Chadwell Heath
    Essex
    Secrétaire
    42 Percival Gardens
    RM6 5RJ Chadwell Heath
    Essex
    British52839450001
    SUTCLIFFE, Neil Ross
    55 Avon Road
    Hale
    WA15 0LB Altrincham
    Cheshire
    Secrétaire
    55 Avon Road
    Hale
    WA15 0LB Altrincham
    Cheshire
    BritishSolicitor59181680001
    WALKER, Amanda Janine
    58 Coolhurst Road
    N5 8EU London
    Secrétaire
    58 Coolhurst Road
    N5 8EU London
    British88888960003
    WELAN, Ranil
    78 Pembroke House
    Hallfield Estate
    W2 6HG Bayswater, London
    Secrétaire
    78 Pembroke House
    Hallfield Estate
    W2 6HG Bayswater, London
    BritishDirector59181710001
    AA COMPANY SERVICES LIMITED
    First Floor Offices 8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    Secrétaire désigné
    First Floor Offices 8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    900002630001
    RUPESINGHE, Vernon Leonard
    33 Mapesbury Road
    NW2 4HS London
    Administrateur
    33 Mapesbury Road
    NW2 4HS London
    United KingdomBritishDirector136926270002
    WELAN, Ranil
    78 Pembroke House
    Hallfield Estate
    W2 6HG Bayswater, London
    Administrateur
    78 Pembroke House
    Hallfield Estate
    W2 6HG Bayswater, London
    BritishDirector59181710001
    BUYVIEW LTD
    1st Floor Offices
    8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    Administrateur désigné
    1st Floor Offices
    8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    900002620001

    MILLCROFT INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 13 sept. 2000
    Livré le 19 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the borrowers present and future undertakings and assets whatever and wherever.
    Personnes ayant droit
    • Woolwich PLC
    Transactions
    • 19 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 13 sept. 2000
    Livré le 19 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the mortgage or any offer or on any account whatsoever
    Brèves mentions
    2 sussex place london W2 t/no.NGL685215.
    Personnes ayant droit
    • Woolwich PLC
    Transactions
    • 19 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 avr. 1999
    Livré le 27 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All l/h property k/a flat 5,67 kensington gardens square,london SW5.. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 avr. 1999
    Livré le 27 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All l/h property k/a flat 2,67 kensington gardens square,london SW5.. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 avr. 1999
    Livré le 27 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All l/h property k/a flat 1,67 kensington gardens square,london SW5.. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 08 janv. 1999
    Livré le 16 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 1/1A 44 clarincarde gardens london W2. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 16 juin 1998
    Livré le 23 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 2 sussex place london-NGL685215. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 mai 1998
    Livré le 21 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Flat 11 108-132 westbourne terrace london W2 t/no;-NGL711889. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 janv. 1998
    Livré le 29 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage flat 3, 193 sussex gardens london W2 t/n-NGL434517.. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 27 nov. 1997
    Livré le 02 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Amenity rights. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 27 nov. 1997
    Livré le 03 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a flat 2, 56 st stephens gardens W2 5NJ t/no: NGL493934. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 août 1997
    Livré le 23 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold property known as flat 13, 86 westbourne terrace, london W2 title number NGL119930 by way of fixed charge all buildings and other structures; goodwill of any business, plant, machinery and other items; an assignment of rental sums together with the benefit of all rights and remedies; proceeds of any claim of insurance. Floating charge over all unattached plant, machinery, chattels and goods.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 août 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 21 août 1997
    Livré le 21 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage over all the f/h property k/a 7 devonshire terrace,hyde park,london W2. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 août 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 juil. 1997
    Livré le 14 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a all that garden flat no.3 Surrendale place london W9 2QW fixed charge all buildings and other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property, assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies, fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property, floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 juil. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security over a deposit account
    Créé le 21 mai 1997
    Livré le 05 juin 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company whether as principal debtor, co-obligant, guarantor or otherwise to the chargee in any manner of way under the terms of this security over a deposit account
    Brèves mentions
    All right title and interest in and to the secured account which means account in the name of millcroft investments limited held with the bank of scotland together with all moneys now or in future held in the secured account and all interest which may become due and payable on those moneys.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 juin 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 21 mai 1997
    Livré le 27 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Flat 1 90 ladbroke grove london W11 t/no;-NGL225916 together with goodwill and proceeds of any insurance. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 mai 1997
    Livré le 27 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    MILLCROFT INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    23 sept. 2022Conclusion of winding up
    02 déc. 2015Petition date
    06 mars 2023Due to be dissolved on
    25 janv. 2016Commencement of winding up
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    practitioner
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    James Richard Duckworth
    Freeman Rich
    284 Clifton Drive South
    FY8 1LH Lytham St Annes
    Lancashire
    practitioner
    Freeman Rich
    284 Clifton Drive South
    FY8 1LH Lytham St Annes
    Lancashire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0