ADVANTAGE INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED

ADVANTAGE INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéADVANTAGE INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03312480
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ADVANTAGE INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED ?

    • (5190) /

    Où se situe ADVANTAGE INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o BRIDGESTONES LIMITED
    125-127 Union Street
    OL1 1TE Oldham
    Lancs
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ADVANTAGE INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2008

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour ADVANTAGE INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour ADVANTAGE INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    13 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 juil. 2015

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 janv. 2015

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 juil. 2014

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 janv. 2014

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 juil. 2013

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 janv. 2013

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 juil. 2012

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 janv. 2012

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 juil. 2011

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 janv. 2011

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 juil. 2010

    5 pages4.68

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    8 pages4.20

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation

    LRESEX

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    legacy

    1 pages287

    legacy

    9 pages363a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    5 pages395

    legacy

    1 pages288b

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01
    capital

    Résolutions

    Finance agreement 11/12/2008
    RES13

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2008

    6 pagesAA

    legacy

    5 pages363a

    Qui sont les dirigeants de ADVANTAGE INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BURNS, Sarah Jane
    Regent Street
    OL10 3BX Heywood
    32
    Lancashire
    Secrétaire
    Regent Street
    OL10 3BX Heywood
    32
    Lancashire
    British133014510001
    BURNS, Sarah Jane
    Regent Street
    OL10 3BX Heywood
    32
    Lancashire
    Administrateur
    Regent Street
    OL10 3BX Heywood
    32
    Lancashire
    United KingdomBritish133014510001
    PEARSON, Joanne Elizabeth
    Firthcliffe Drive
    Leeds Road
    WF15 6HR Liversedge
    55
    West Yorkshire
    Administrateur
    Firthcliffe Drive
    Leeds Road
    WF15 6HR Liversedge
    55
    West Yorkshire
    British133014500001
    BAKER, Anne-Marie
    Birchinley Hall Farm
    Wild House Lane
    OL16 3TW Milnrow
    Rochdale
    Secrétaire
    Birchinley Hall Farm
    Wild House Lane
    OL16 3TW Milnrow
    Rochdale
    British54812080005
    STRUL, Sharon Frances Anne
    3 Heaton Court
    Manchester Road
    BL9 9QN Bury
    Lancashire
    Secrétaire
    3 Heaton Court
    Manchester Road
    BL9 9QN Bury
    Lancashire
    British51362540001
    PARAMOUNT COMPANY SEARCHES LIMITED
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    Secrétaire désigné
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    900001530001
    BAKER, Anne-Marie
    Birchinley Hall Farm
    Wild House Lane
    OL16 3TW Milnrow
    Rochdale
    Administrateur
    Birchinley Hall Farm
    Wild House Lane
    OL16 3TW Milnrow
    Rochdale
    United KingdomBritish54812080005
    STRUL, Michael Paul
    74 Rishworth Palace
    Rishworth Mill Lane
    HX6 4RZ Sowerby Bridge
    Administrateur
    74 Rishworth Palace
    Rishworth Mill Lane
    HX6 4RZ Sowerby Bridge
    United KingdomBritish89385370001
    PARAMOUNT PROPERTIES (UK) LIMITED
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    Administrateur désigné
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    900001520001

    ADVANTAGE INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 09 déc. 2008
    Livré le 19 déc. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 19 déc. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 12 nov. 2007
    Livré le 15 nov. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 15 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 22 févr. 2007
    Livré le 03 mars 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of assignment
    Créé le 12 déc. 2000
    Livré le 13 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a facility letter dated 4 september 1998 to finance purchase order numbers 6228/16229/16230/16231 and 16232 dated 13 november 2000
    Brèves mentions
    The entire benefit of purchase order numbers 16228/16229/16230/16231 and 16232 dated 13 november 2000 and the debtor monies falling due under purchase order numbers 16228/16229/16230/16231/ and 16232 dated 13 november together with all rights of the assignor to sue or take action in respect of the breach of the obligations contained in such contract.
    Personnes ayant droit
    • Davenham Trade Finance Limited
    Transactions
    • 13 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment
    Créé le 04 avr. 2000
    Livré le 05 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Under a facility letter dated 4 september 1998 to finance purchase order number 0000000817 dated 2ND march 2000
    Brèves mentions
    The entire benefit of purchase order number 0000000817 dated 2ND march 2000 and the debtor monies falling due under purchase order together with all rights of the assignor to sue or take action in respect of the breach of the obligations contained in such contract.
    Personnes ayant droit
    • Davenham Trade Finance Limited
    Transactions
    • 05 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment
    Créé le 21 oct. 1999
    Livré le 22 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a facility letter dated 4 september 1998
    Brèves mentions
    The benefit of purchase order number 2087 dated 27 september 1998 and all monies due thereunder.
    Personnes ayant droit
    • Davenham Trade Finance Limited
    Transactions
    • 22 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment
    Créé le 18 mai 1999
    Livré le 19 mai 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a facility letter dated 4TH september 1998 to finance purchase order number 2076 dated 27TH april 1999
    Brèves mentions
    The entire benefit of purchase order number 2076 dated 27TH april 1999. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Davenham Trade Finance Limited
    Transactions
    • 19 mai 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment
    Créé le 15 avr. 1999
    Livré le 16 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a facility letter dated 4TH september 1998 to finance purchase order number 2075 dated 26TH march 1999 (as defined)
    Brèves mentions
    The entire benefit of purchase order no 2075 dated 26/3/99 and debtor monies due thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Davenham Trade Finance Limited
    Transactions
    • 16 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment
    Créé le 03 déc. 1998
    Livré le 04 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a facility letter dated 4 september 1998 to finance purchase order numbers Z97723, Z97734, Z97741, Z97711, Z97732, Z97680 dated 30 november 1998
    Brèves mentions
    The entire benefit of purchase order numbers Z97723, Z97734, Z97741, Z97711, Z97732, Z97680 dated 30 november 1998 and the debtor monies falling due under purchase order together with all rights of the assignor to sue or take action in respect of the breach of the obligations contained in such contract.
    Personnes ayant droit
    • Davenham Trade Finance Limited
    Transactions
    • 04 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment
    Créé le 04 nov. 1998
    Livré le 05 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a facility letter dated 4TH september 1998 to finance purchase order number 59 dated 19TH october 1998
    Brèves mentions
    The entire benefit of purchase order no 59 dated 19/10/98 with all related rights thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Davenham Trade Finance Limited
    Transactions
    • 05 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 mars 1997
    Livré le 22 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 22 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    ADVANTAGE INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 juil. 2009Commencement of winding up
    01 mars 2016Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Jonathan Guy Lord
    Bridgestones
    125/127 Union Street
    OL1 1TE Oldham
    Lancashire
    practitioner
    Bridgestones
    125/127 Union Street
    OL1 1TE Oldham
    Lancashire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0