VANTAGE DISTRIBUTION LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéVANTAGE DISTRIBUTION LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03314092
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de VANTAGE DISTRIBUTION LTD ?

    • Commerce de gros de produits de radio, télévision et appareils électroménagers (autres que les disques, cassettes, CD et cassettes vidéo et l'équipement utilisé pour les jouer) (46439) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe VANTAGE DISTRIBUTION LTD ?

    Adresse du siège social
    Town Wall House
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Essex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de VANTAGE DISTRIBUTION LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    REGENERSIS DISTRIBUTION LTD06 juin 200806 juin 2008
    INTEC DISTRIBUTION LIMITED10 août 199810 août 1998
    BETA BUSINESS LIMITED06 févr. 199706 févr. 1997

    Quels sont les derniers comptes de VANTAGE DISTRIBUTION LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour VANTAGE DISTRIBUTION LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    14 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 sept. 2017

    13 pagesLIQ03

    Modification des coordonnées du secrétaire Lorraine Young Company Secretaries Limited le 22 déc. 2016

    1 pagesCH04

    Changement d'adresse du siège social de 6th Floor 60 Gracechurch Street London EC3V 0HR United Kingdom à Town Wall House Balkerne Hill Colchester Essex CO3 3AD le 26 oct. 2016

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 30 sept. 2016

    LRESSP

    Changement d'adresse du siège social de 190 High Street Tonbridge Kent TN9 1BE à 6th Floor 60 Gracechurch Street London EC3V 0HR le 02 sept. 2016

    1 pagesAD01

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    2 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 30 juin 2015

    15 pagesAA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed regenersis distribution LTD\certificate issued on 24/03/16
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name24 mars 2016

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 mars 2016

    État du capital au 02 mars 2016

    • Capital: GBP 50,000
    • Capital: USD 500
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jog Dhody le 17 nov. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jog Dhody le 23 juin 2015

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2014

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 mars 2015

    État du capital au 05 mars 2015

    • Capital: GBP 50,000
    • Capital: USD 500
    SH01

    Cessation de la nomination de Wayne Patrick Hellewell en tant que directeur le 31 oct. 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Simon Julian Harper en tant que directeur le 31 oct. 2014

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jog Dhody le 01 févr. 2015

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de 4Th Floor 32 Wigmore Street London W1U 2RP à 190 High Street Tonbridge Kent TN9 1BE le 10 févr. 2015

    1 pagesAD01

    Nomination de Lorraine Young Company Secretaries Limited en tant que secrétaire le 01 oct. 2014

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Prism Cosec Limited en tant que secrétaire le 01 oct. 2014

    1 pagesTM02

    Qui sont les dirigeants de VANTAGE DISTRIBUTION LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LORRAINE YOUNG COMPANY SECRETARIES LIMITED
    6th Floor
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    Shakespeare Martineau Llp
    United Kingdom
    Secrétaire
    6th Floor
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    Shakespeare Martineau Llp
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement07873246
    165261700001
    DHODY, Jog
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Town Wall House
    Essex
    Administrateur
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Town Wall House
    Essex
    EnglandBritishChartered Accountant104269910005
    BRYANT, Adrian
    6 Pheasants Way
    WD3 2ES Rickmansworth
    Hertfordshire
    Secrétaire
    6 Pheasants Way
    WD3 2ES Rickmansworth
    Hertfordshire
    British38711040002
    CHALK, Karen Jane
    49 Deerhurst Close
    TW13 7HS Feltham
    Middlesex
    Secrétaire
    49 Deerhurst Close
    TW13 7HS Feltham
    Middlesex
    British46464420002
    TEMPLE, John Nicholas
    Windfalls Highfield Road
    West Moors
    BH22 0NA Ferndown
    Dorset
    Secrétaire
    Windfalls Highfield Road
    West Moors
    BH22 0NA Ferndown
    Dorset
    British84493950001
    WEATHERALL, Sally
    4 Elm Place
    Old Witney Road Eynsham
    OX29 4BD Witney
    Oxfordshire
    Secrétaire
    4 Elm Place
    Old Witney Road Eynsham
    OX29 4BD Witney
    Oxfordshire
    152389680001
    PRISM COSEC LIMITED
    10 Margaret Street
    W1W 8RL London
    Prism Cosec
    United Kingdom
    Secrétaire
    10 Margaret Street
    W1W 8RL London
    Prism Cosec
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement05533248
    116519070002
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Secrétaire désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    BRYANT, Adrian
    6 Pheasants Way
    WD3 2ES Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    6 Pheasants Way
    WD3 2ES Rickmansworth
    Hertfordshire
    EnglandBritishAccountant38711040002
    CROCKER, Arthur Rupert
    35 Palmerston Road
    Wimbledon
    SW19 1PG London
    Administrateur
    35 Palmerston Road
    Wimbledon
    SW19 1PG London
    EnglandBritishAccountant79797070001
    HARPER, Simon Julian
    High Street
    TN9 1BE Tonbridge
    190
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    High Street
    TN9 1BE Tonbridge
    190
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Operating Officer108485480003
    HELLEWELL, Wayne Patrick
    High Street
    TN9 1BE Tonbridge
    190
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    High Street
    TN9 1BE Tonbridge
    190
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishOperations Director Uk & Sweden185877540001
    KELHAM, David William
    4 Elm Place
    Old Witney Road Eynsham
    OX29 4BD Witney
    Oxfordshire
    Administrateur
    4 Elm Place
    Old Witney Road Eynsham
    OX29 4BD Witney
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector87146390001
    KELHAM, David William
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    Administrateur
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    EnglandBritishDirector87146390001
    LEE, Andrew Stephen
    Floor
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    4th
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    4th
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director159105430001
    RAMIS, Hayrettin
    1 Park Gate Avenue
    EN4 0NN Hadley Wood
    Hertfordshire
    Administrateur
    1 Park Gate Avenue
    EN4 0NN Hadley Wood
    Hertfordshire
    BritishEngineer22403690003
    SHIELDS, Stephen Andrew
    32 The Broadway
    Thorp Bay
    SS1 3HJ Southend On Sea
    Essex
    Administrateur
    32 The Broadway
    Thorp Bay
    SS1 3HJ Southend On Sea
    Essex
    United KingdomBritishDirector107406090001
    STOKES, Gary Martin
    16a Fiery Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LG Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    16a Fiery Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LG Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritishChief Executive71396660002
    TANSINI, Sergio
    4 Elm Place
    Old Witney Road Eynsham
    OX29 4BD Witney
    Oxfordshire
    Administrateur
    4 Elm Place
    Old Witney Road Eynsham
    OX29 4BD Witney
    Oxfordshire
    ScotlandItalianManaging Director106858140001
    WILSON, Jeremy Michael Charles
    Hinchingbrooke
    Huntingdon
    PE29 6FN Cambridgeshire
    Kingfisher Way
    United Kingdom
    Administrateur
    Hinchingbrooke
    Huntingdon
    PE29 6FN Cambridgeshire
    Kingfisher Way
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector151756520001
    WOODWARD, Kathleen
    Kaadan High Easter Road
    Leaden Roding
    CM6 1QF Dunmow
    Essex
    Administrateur
    Kaadan High Easter Road
    Leaden Roding
    CM6 1QF Dunmow
    Essex
    BritishDirector107405790001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Administrateur désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    VANTAGE DISTRIBUTION LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed charge on non-vesting debts and floating charge
    Créé le 04 janv. 2013
    Livré le 09 janv. 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all debts and all export debts purportedly assigned to the security holder pursuant to the debt purchase agreement. All associated rights relating to any non-vesting domestic debts and non-vesting export debts. By way of first fixed charge the excluded proceeds and by way of first floating charge all present and future assets undertaking and all other property and assets see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transactions
    • 09 janv. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 07 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal assignment of contract monies
    Créé le 21 déc. 2012
    Livré le 03 janv. 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and any security party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any credit balance due to the company under an agreement for the purchase of debts the benefit of all the other provisions of the contract and all securities see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC as Security Agent for the Secured Parties
    Transactions
    • 03 janv. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 07 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 12 mai 2011
    Livré le 20 mai 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the secured party on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC (As Security Agent)
    Transactions
    • 20 mai 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 07 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 18 sept. 2007
    Livré le 27 sept. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kbc Bank Nv, as Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transactions
    • 27 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mai 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 21 févr. 2007
    Livré le 09 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kbc Bank Nv as Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transactions
    • 09 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mai 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 29 juil. 2005
    Livré le 10 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    All assets debenture
    Créé le 22 juil. 2005
    Livré le 23 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 23 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 27 févr. 2004
    Livré le 16 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or intec cellular services limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 16 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 août 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 27 févr. 2004
    Livré le 16 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 16 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 août 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    VANTAGE DISTRIBUTION LTD a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    30 sept. 2016Commencement of winding up
    17 mars 2020Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Howard Toone
    Cvr Global Llp New Fetter Place West
    55 Fetter Lane
    EC4A 1AA London
    practitioner
    Cvr Global Llp New Fetter Place West
    55 Fetter Lane
    EC4A 1AA London
    Lee De'Ath
    Town Wall House Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    practitioner
    Town Wall House Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0