DISCFIND LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDISCFIND LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03315136
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DISCFIND LIMITED ?

    • Location et exploitation de biens immobiliers des sociétés de logement (68201) / Activités immobilières

    Où se situe DISCFIND LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Quadrant House, Floor 6
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de DISCFIND LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour DISCFIND LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2012

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 avr. 2013

    État du capital au 08 avr. 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    legacy

    3 pagesMG04

    legacy

    3 pagesMG04

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2011

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2010

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Patrick Colvin en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Patrick Colvin en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2009

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Michael Robert Goldberger le 15 déc. 2009

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael Robert Goldberger le 15 déc. 2009

    2 pagesCH01

    legacy

    1 pages287

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2008

    14 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2007

    16 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages287

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2006

    16 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de DISCFIND LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GOLDBERGER, Michael Robert
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Quadrant House, Floor 6
    United Kingdom
    Secrétaire
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Quadrant House, Floor 6
    United Kingdom
    British77295560002
    GOLDBERGER, Michael Robert
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Quadrant House, Floor 6
    United Kingdom
    Administrateur
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Quadrant House, Floor 6
    United Kingdom
    United KingdomBritish77295560002
    PEARLMAN, David Alan
    Sheldon Avenue
    Highgate
    N6 4JT London
    26
    Administrateur
    Sheldon Avenue
    Highgate
    N6 4JT London
    26
    United KingdomBritish35550120001
    COLVIN, Patrick
    Great Oaks
    Hutton
    CM13 1AZ Brentwood
    19
    Essex
    Secrétaire
    Great Oaks
    Hutton
    CM13 1AZ Brentwood
    19
    Essex
    British5954030001
    CRICKMORE, Nicola Jane
    Brelston Court Barn
    HR9 6HF Marstow
    Herefordshire
    Secrétaire
    Brelston Court Barn
    HR9 6HF Marstow
    Herefordshire
    British115328860001
    HUGGINS, Brian John
    169 Timberlog Lane
    SS14 1PJ Basildon
    Essex
    Secrétaire
    169 Timberlog Lane
    SS14 1PJ Basildon
    Essex
    British63149960001
    NEEDHAM, Ivan Arthur
    45 Shearwater
    New Barn
    DA3 7NL Longfield
    Kent
    Secrétaire
    45 Shearwater
    New Barn
    DA3 7NL Longfield
    Kent
    British3471370001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secrétaire désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    WALGATE SERVICES LIMITED
    25 North Row
    W1K 6DJ London
    Secrétaire
    25 North Row
    W1K 6DJ London
    59142480001
    CARLTON PORTER, Robert William
    4 Laggan House
    College Road
    BA1 5RY Bath
    Avon
    Administrateur
    4 Laggan House
    College Road
    BA1 5RY Bath
    Avon
    United KingdomBritish67566540006
    COLVIN, Patrick
    Great Oaks
    Hutton
    CM13 1AZ Brentwood
    19
    Essex
    Administrateur
    Great Oaks
    Hutton
    CM13 1AZ Brentwood
    19
    Essex
    EnglandBritish5954030001
    CRICKMORE, Nicola Jane
    Brelston Court Barn
    HR9 6HF Marstow
    Herefordshire
    Administrateur
    Brelston Court Barn
    HR9 6HF Marstow
    Herefordshire
    United KingdomBritish115328860001
    GADSDEN, Eric John Spencer
    Hawridge Place
    Hawridge
    HP5 2UG Chesham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Hawridge Place
    Hawridge
    HP5 2UG Chesham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish13515270003
    JOHNSON, Simon Harcourt
    14 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    Administrateur
    14 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    British37681220001
    LANDAU, Ervin
    78 Harley House
    Marylebone Road
    NW1 5HN London
    Administrateur
    78 Harley House
    Marylebone Road
    NW1 5HN London
    United KingdomBritish91134410001
    LEWIN, Peter Harry
    1 Wolsey Road
    Moor Park
    HA6 2HN Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    1 Wolsey Road
    Moor Park
    HA6 2HN Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish2652710001
    MULDOON, John Gerard
    16 Carbery Avenue
    BH6 3LF Bournemouth
    Dorset
    Administrateur
    16 Carbery Avenue
    BH6 3LF Bournemouth
    Dorset
    EnglandBritish94510780001
    SZERKOWSKI, Joram
    87 Campden Street
    W8 7EN London
    Administrateur
    87 Campden Street
    W8 7EN London
    German53915690001
    TOMLINSON, Brian
    18 Picadilly Court
    Queens Promenade
    IM2 4NS Douglas
    Isle Of Man
    Administrateur
    18 Picadilly Court
    Queens Promenade
    IM2 4NS Douglas
    Isle Of Man
    British75490660002
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Administrateur désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    DISCFIND LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 07 juil. 2006
    Livré le 25 juil. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    65-73 (odd) the parade high street watford t/no HD184726, 1 marlborough place and 119 and 120 church street brighton t/no ESX194404, westbury court moulton park northampton t/no NN132570. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Halifax PLC
    Transactions
    • 25 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 janv. 2013Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    Debenture
    Créé le 25 mars 2002
    Livré le 08 avr. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    65-73 (odd) the parade high street watford t/n HD184726, blenheim house being 1 marlborough place and 119-120 church street brighton and hove t/n ESX194404 and westbury court moulton park (2-3 moulton park) northampton t/n NN132570. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 janv. 2013Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    Debenture
    Créé le 27 mai 1999
    Livré le 07 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold property k/a stoke abbott court chapel road worthing west sussex t/n WSX22624, 1 marlbrough place and 119 church street brighton east sussex t/n ESX194404 for further properties please refer yo form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Halifax PLC
    Transactions
    • 07 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juin 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge of deposit
    Créé le 19 mars 1999
    Livré le 06 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All rights title benefit and interest to and in all sums of money held on time deposit ref 351924 and any substitue and replacement account please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Halifax PLC
    Transactions
    • 06 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juin 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 28 févr. 1997
    Livré le 03 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H properties at angel gate city road l/b of islington k/a units 17/18 & unit 24 t/no's ngl 717397 NGL717394 and the proceeds of sale thereof. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Halifax Building Society
    Transactions
    • 03 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juin 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0