ZURICH FINANCIAL SERVICES (UKISA) GROUP SERVICES LIMITED

ZURICH FINANCIAL SERVICES (UKISA) GROUP SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéZURICH FINANCIAL SERVICES (UKISA) GROUP SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03315205
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ZURICH FINANCIAL SERVICES (UKISA) GROUP SERVICES LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe ZURICH FINANCIAL SERVICES (UKISA) GROUP SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Crichleys Llp Beaver House
    Hythe Bridge Street
    OX1 2EP Oxford
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ZURICH FINANCIAL SERVICES (UKISA) GROUP SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BRITISH AMERICAN FINANCIAL SERVICES IT AND GROUP SERVICES LIMITED13 mars 199713 mars 1997
    UNIQUEBLOCK LIMITED07 févr. 199707 févr. 1997

    Quels sont les derniers comptes de ZURICH FINANCIAL SERVICES (UKISA) GROUP SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour ZURICH FINANCIAL SERVICES (UKISA) GROUP SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    11 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de Critchleys Beaver House 23-28 Hythe Bridge Street Oxford OX1 2EP United Kingdom à Crichleys Llp Beaver House Hythe Bridge Street Oxford OX1 2EP le 19 oct. 2018

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 26 sept. 2018

    LRESSP

    Changement d'adresse du siège social de The Grange Bishops Cleeve Cheltenham Gloucestershire GL52 8XX à Critchleys Beaver House 23-28 Hythe Bridge Street Oxford OX1 2EP le 05 oct. 2018

    1 pagesAD01

    Nomination de Mrs Charlotte Denise Murphy en tant qu'administrateur le 01 mai 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Victoria Louise De Temple en tant que directeur le 01 mai 2018

    1 pagesTM01

    Notification de Zurich Financial Services (Ukisa) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC02

    Déclaration de confirmation établie le 02 avr. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    6 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy James Grant le 21 août 2017

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Victoria Louise De Temple le 13 nov. 2017

    2 pagesCH01

    Nomination de Mrs Victoria Louise De Temple en tant qu'administrateur le 13 nov. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de James Douglas Sutherland en tant que directeur le 20 oct. 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Timothy James Grant en tant qu'administrateur le 30 mai 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jonathan Vaughan-Williams en tant que directeur le 28 avr. 2017

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 02 avr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    6 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 avr. 2016

    État du capital au 25 avr. 2016

    • Capital: GBP 4,650,002
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 avr. 2015

    État du capital au 07 avr. 2015

    • Capital: GBP 4,650,002
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 avr. 2014

    État du capital au 14 avr. 2014

    • Capital: GBP 4,650,002
    SH01

    Qui sont les dirigeants de ZURICH FINANCIAL SERVICES (UKISA) GROUP SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ZURICH CORPORATE SECRETARY (UK) LIMITED
    Bishops Cleeve
    GL52 8XX Cheltenham
    The Grange
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Bishops Cleeve
    GL52 8XX Cheltenham
    The Grange
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement1437979
    184776530001
    GRANT, Timothy James
    3000 Parkway
    Whiteley
    PO15 7JZ Fareham
    The Zurich Centre
    England
    England
    Administrateur
    3000 Parkway
    Whiteley
    PO15 7JZ Fareham
    The Zurich Centre
    England
    England
    United KingdomBritish106395820002
    MURPHY, Charlotte Denise
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    Tricentre One
    England
    England
    Administrateur
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    Tricentre One
    England
    England
    United KingdomBritish246238460001
    BLUNDELL, Ann Claire
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    Tricentre One
    England
    England
    Secrétaire
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    Tricentre One
    England
    England
    178515490001
    HOWE, Peter Charles
    Englishcombe
    10 Butts Road Chiseldon
    SN4 0NW Swindon
    Wiltshire
    Secrétaire
    Englishcombe
    10 Butts Road Chiseldon
    SN4 0NW Swindon
    Wiltshire
    British34162240003
    KNOTT, Amanda Louise
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    Tricentre One
    England
    Secrétaire
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    Tricentre One
    England
    British116644060004
    LOWE, Nigel
    Tall Trees
    65 High View
    HA5 3PE Pinner
    Middlesex
    Secrétaire
    Tall Trees
    65 High View
    HA5 3PE Pinner
    Middlesex
    British104309680001
    MEACHAM, Jayne Michelle
    Uk Life Centre
    Station Road
    SN1 1EL Swindon
    Wiltshire
    Secrétaire
    Uk Life Centre
    Station Road
    SN1 1EL Swindon
    Wiltshire
    British117273030002
    OLISA HOLDING, Lily
    17 Elcombe Farm
    SN4 9QL Swindon
    Wiltshire
    Secrétaire
    17 Elcombe Farm
    SN4 9QL Swindon
    Wiltshire
    British91928570001
    RITCHIE, Ian
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    Tricentre One
    England
    England
    Secrétaire
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    Tricentre One
    England
    England
    178515570001
    ROGERS, Helen Frances Leigh
    Station Road
    SN1 1EL Swindon
    Uk Life Centre
    Wiltshire
    Secrétaire
    Station Road
    SN1 1EL Swindon
    Uk Life Centre
    Wiltshire
    British112889520003
    ROSS, Corina Katherine
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    Tricentre One
    England
    Secrétaire
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    Tricentre One
    England
    British158186100001
    WILTSHIRE, James Anthony
    Wellington House
    Stroud Road
    GL6 6UT Painswick
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Wellington House
    Stroud Road
    GL6 6UT Painswick
    Gloucestershire
    British461140002
    WOODWARD, Derek Richard
    Meadow Road
    KT21 1QR Ashstead
    The Cedars
    Surrey
    Secrétaire
    Meadow Road
    KT21 1QR Ashstead
    The Cedars
    Surrey
    British130889660002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ATTWOOD, Vyvyan James
    Cockroost Farmhouse
    Stonehill Charlton
    SN16 9DX Malmesbury
    Wiltshire
    Administrateur
    Cockroost Farmhouse
    Stonehill Charlton
    SN16 9DX Malmesbury
    Wiltshire
    EnglandBritish106774900002
    CARRIE, David Ross
    Carlton House
    Pittville Circus Road
    GL52 2PZ Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Carlton House
    Pittville Circus Road
    GL52 2PZ Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandUnited Kingdom55711250001
    DE TEMPLE, Victoria Louise
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    Tricentre One
    England
    England
    Administrateur
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    Tricentre One
    England
    England
    United KingdomBritish287474690001
    EVANS, Michael Robert
    8 Little Lancarridge
    GL2 8EN Highnham
    Gloucestershire
    Administrateur
    8 Little Lancarridge
    GL2 8EN Highnham
    Gloucestershire
    British72798390001
    EVANS, Neil James
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    Tricentre One
    England
    Administrateur
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    Tricentre One
    England
    United KingdomBritish261073090001
    HANKS, Brian Paul
    1 Lancaster Drive
    Little Rissington
    GL54 2QZ Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    1 Lancaster Drive
    Little Rissington
    GL54 2QZ Cheltenham
    Gloucestershire
    British60770390002
    HARRIS, Michael
    10 New Meadow Copse
    Peatmoor
    SN5 5AQ Swindon
    Administrateur
    10 New Meadow Copse
    Peatmoor
    SN5 5AQ Swindon
    British62394990001
    JAMES, Ian Humphries
    55 The Willows
    Highworth
    SN6 7PH Swindon
    Administrateur
    55 The Willows
    Highworth
    SN6 7PH Swindon
    British27415830001
    JONES, Martin Ewart
    Brook Cottage
    Sandy Pluck Lane Bentham
    GL51 4UB Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Brook Cottage
    Sandy Pluck Lane Bentham
    GL51 4UB Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish76080710001
    LOWE, Nigel
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    Tricentre One
    England
    Administrateur
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    Tricentre One
    England
    United KingdomBritish104309680003
    MARSH, John
    4 Manse Gardens
    GL51 5PG Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    4 Manse Gardens
    GL51 5PG Cheltenham
    Gloucestershire
    British51797870001
    SEWARD, Ian Graham
    The Limes Town Pond Lane
    Southmoor
    OX13 5HS Abingdon
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Limes Town Pond Lane
    Southmoor
    OX13 5HS Abingdon
    Oxfordshire
    British21934200001
    SMITH, Andrew Mark
    Grove Cottage 15 The Strand
    Attenborough
    NG9 6AU Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Grove Cottage 15 The Strand
    Attenborough
    NG9 6AU Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish26977900001
    SMITH, Philip
    Bremhill House
    Bremhill
    SN11 9HN Calne
    Wiltshire
    Administrateur
    Bremhill House
    Bremhill
    SN11 9HN Calne
    Wiltshire
    United KingdomBritish59960140002
    SUTHERLAND, James Douglas
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    Tricentre One
    United Kingdom
    Administrateur
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    Tricentre One
    United Kingdom
    EnglandBritish179456360001
    TAYLOR, Michael John Kirkham
    Copperfield House
    Little Somerford
    SN15 5JW Chippenham
    Wiltshire
    Administrateur
    Copperfield House
    Little Somerford
    SN15 5JW Chippenham
    Wiltshire
    British76168000004
    VAUGHAN-WILLIAMS, Jonathan
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    Tricentre One
    England
    England
    Administrateur
    New Bridge Square
    SN1 1HN Swindon
    Tricentre One
    England
    England
    United KingdomBritish179491810001
    WALLACE, Andrew
    Orchard House Silver Street
    SN6 8JF Bourton
    Oxfordshire
    Administrateur
    Orchard House Silver Street
    SN6 8JF Bourton
    Oxfordshire
    British14093130001
    WHITE, Dennis William
    Toat Farm
    Bashurst Hill
    RH13 7PB Itchingfield
    West Sussex
    Administrateur
    Toat Farm
    Bashurst Hill
    RH13 7PB Itchingfield
    West Sussex
    British11042250003
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ZURICH FINANCIAL SERVICES (UKISA) GROUP SERVICES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Bishops Cleeve
    GL52 8XX Cheltenham
    The Grange
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Bishops Cleeve
    GL52 8XX Cheltenham
    The Grange
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement1860680
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Bishops Cleeve
    GL52 8XX Cheltenham
    The Grange
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Bishops Cleeve
    GL52 8XX Cheltenham
    The Grange
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement1860680
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    ZURICH FINANCIAL SERVICES (UKISA) GROUP SERVICES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    26 sept. 2018Commencement of winding up
    05 déc. 2019Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Milan Vuceljic
    Beaver House 23-38 Hythe Bridge Street
    OX1 2EP Oxford
    Oxfordshire
    practitioner
    Beaver House 23-38 Hythe Bridge Street
    OX1 2EP Oxford
    Oxfordshire
    Lawrence John King
    Critchleys Beaver House
    23-38 Hythe Bridge Street
    OX1 2EP Oxford
    Oxfordshire
    practitioner
    Critchleys Beaver House
    23-38 Hythe Bridge Street
    OX1 2EP Oxford
    Oxfordshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0