SIGNS AND LABELS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSIGNS AND LABELS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03318384
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SIGNS AND LABELS LIMITED ?

    • (7415) /

    Où se situe SIGNS AND LABELS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Douglas Bruce House
    Corrie Way
    SK6 2RR Bredbury Park Industrial Estate
    Bredbury Stockport
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SIGNS AND LABELS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SIGNS & LABELS GROUP LIMITED26 mars 199826 mars 1998
    MARPLACE (NUMBER 405) LIMITED14 févr. 199714 févr. 1997

    Quels sont les derniers comptes de SIGNS AND LABELS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2006

    Quels sont les derniers dépôts pour SIGNS AND LABELS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Dépôt d'insolvabilité

    INSOLVENCY:sos cert release of liquidator
    1 pagesLIQ MISC

    Dépôt d'insolvabilité

    INSOLVENCY:Form 4.40 g g Bates ceasing to act
    1 pagesLIQ MISC

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order INSOLVENCY:Replacement of Liquidator p j Windatt Replaces gg Bates 15/12/2009
    13 pagesLIQ MISC OC

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 22 oct. 2009

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 22 avr. 2009

    5 pages4.68

    Déclaration de solvabilité

    9 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 23 avr. 2008

    LRESSP

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2006

    21 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages88(2)R

    legacy

    2 pages88(2)R

    legacy

    9 pages363s

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2005

    23 pagesAA

    legacy

    1 pages244

    legacy

    9 pages363s

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Conv shares 27/06/05
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Comptes consolidés établis au 04 déc. 2004

    27 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de SIGNS AND LABELS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JACKSON, John Paul
    4 Knightwood Glade
    Chandlers Ford
    SO53 4JA Eastleigh
    Hampshire
    Secrétaire
    4 Knightwood Glade
    Chandlers Ford
    SO53 4JA Eastleigh
    Hampshire
    British122350180001
    FELMER, Thomas James
    Hilly Lane
    Saukville
    8821
    Wisconsine
    United States
    Administrateur
    Hilly Lane
    Saukville
    8821
    Wisconsine
    United States
    United States Of AmericaAmerican128854080001
    JAEHNERT, Frank Michael
    W68n1068 Kensington Avenue
    53012 Cedarburg
    Wisconsin
    Usa
    Administrateur
    W68n1068 Kensington Avenue
    53012 Cedarburg
    Wisconsin
    Usa
    United States Of AmericaUsa68305240001
    SEPHTON, Peter Charles
    The Coach House
    Severnstoke Bank
    WR8 9JG Severnstoke
    Worcestershire
    Administrateur
    The Coach House
    Severnstoke Bank
    WR8 9JG Severnstoke
    Worcestershire
    United KingdomBritish59319040003
    WALSHAM, Andrew Stuart
    15 Elm Road
    SN7 7EJ Faringdon
    Oxfordshire
    Administrateur
    15 Elm Road
    SN7 7EJ Faringdon
    Oxfordshire
    United KingdomBritish33682210002
    BRANDWOOD, Christopher Mark
    Oak House Oak Road
    Mottram St Andrew
    SK10 4RA Macclesfield
    Cheshire
    Secrétaire
    Oak House Oak Road
    Mottram St Andrew
    SK10 4RA Macclesfield
    Cheshire
    British46508870001
    HIGHAM, Maria Gabrielle
    Eastcote 25 Delahays Road
    WA15 8DS Hale
    Cheshire
    Secrétaire
    Eastcote 25 Delahays Road
    WA15 8DS Hale
    Cheshire
    British56630460001
    ASHLEY, Desmond Owen
    Holly Barn Holly Tree Walk
    Claybrooke Magna
    LE17 5DZ Lutterworth
    Leicestershire
    Administrateur
    Holly Barn Holly Tree Walk
    Claybrooke Magna
    LE17 5DZ Lutterworth
    Leicestershire
    EnglandUnited Kingdom53386540002
    FITZGERALD, David Sean
    1 Greenmount Gardens
    Greenmount
    BL8 4HN Bury
    Lancashire
    Administrateur
    1 Greenmount Gardens
    Greenmount
    BL8 4HN Bury
    Lancashire
    British61196400001
    HIGHAM, Maria Gabrielle
    Eastcote 25 Delahays Road
    WA15 8DS Hale
    Cheshire
    Administrateur
    Eastcote 25 Delahays Road
    WA15 8DS Hale
    Cheshire
    British56630460001
    HYAMS, Anthony Michael
    8 Bonville Chase
    WA14 4QA Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    8 Bonville Chase
    WA14 4QA Altrincham
    Cheshire
    British56167340004
    MACDONALD, Iain Archibald
    7 Hermitage Gardens
    EH10 6DL Edinburgh
    Administrateur
    7 Hermitage Gardens
    EH10 6DL Edinburgh
    ScotlandBritish3614100004
    MATHIESON, David
    10920 North Elizabeth Court
    Mequon
    Wisconsin 53097
    Usa
    Administrateur
    10920 North Elizabeth Court
    Mequon
    Wisconsin 53097
    Usa
    British106586110001
    PADBERG, Mark Walter
    Thatchways
    Knobfield
    RH5 6RJ Abinger Hamer
    Surrey
    Administrateur
    Thatchways
    Knobfield
    RH5 6RJ Abinger Hamer
    Surrey
    British89261420001
    ROCHE, Susan Louise
    Rose Farm
    Astley Moss
    M29 7LX Manchester
    Administrateur
    Rose Farm
    Astley Moss
    M29 7LX Manchester
    Usa96243330001
    SCHOLES, Jeremy Hacking
    11 Gleneagles Drive
    Brockhall Village
    BB6 8BF Old Langho
    Lancashire
    Administrateur
    11 Gleneagles Drive
    Brockhall Village
    BB6 8BF Old Langho
    Lancashire
    EnglandBritish108377220001
    STOREY, Richard George
    49 Kennerley Road
    SK2 6EU Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    49 Kennerley Road
    SK2 6EU Stockport
    Cheshire
    British11628330002

    SIGNS AND LABELS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed and floating charge
    Créé le 08 déc. 2003
    Livré le 09 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly known as signs and labels group limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transactions
    • 09 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of life policy
    Créé le 07 oct. 2002
    Acquis le 28 nov. 2003
    Livré le 22 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Policy number jlt 18433 dated 8 may 2002 for £250,000 over the life of maria gabrielle higham. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 déc. 2003Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 13 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 10 mai 2002
    Acquis le 28 nov. 2003
    Livré le 22 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transactions
    • 22 déc. 2003Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 13 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of life policy
    Créé le 21 oct. 1997
    Acquis le 28 nov. 2003
    Livré le 22 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Policy number RNF000401 52A with sun alliance and london insurance company limited in the life of richard storey. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 déc. 2003Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 13 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 10 juil. 1997
    Acquis le 26 nov. 2003
    Livré le 22 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 déc. 2003Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 13 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 10 juil. 1997
    Livré le 16 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fittings fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 16 juil. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    SIGNS AND LABELS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    26 avr. 2010Dissolved on
    23 avr. 2008Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Peter John Windatt
    Suite 1c Oak House Woodlands Business Park
    Linford Wood West
    MK14 6EY Milton Keynes
    practitioner
    Suite 1c Oak House Woodlands Business Park
    Linford Wood West
    MK14 6EY Milton Keynes
    Gavin Geoffrey Bates
    Suite 1c Oak House Woodlands Business Park
    Linford Wood West
    MK14 6EY Milton Keynes
    practitioner
    Suite 1c Oak House Woodlands Business Park
    Linford Wood West
    MK14 6EY Milton Keynes

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0