REMOTE DIAGNOSTIC TECHNOLOGIES LIMITED

REMOTE DIAGNOSTIC TECHNOLOGIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéREMOTE DIAGNOSTIC TECHNOLOGIES LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03321782
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de REMOTE DIAGNOSTIC TECHNOLOGIES LIMITED ?

    • fabrication d'équipements d'irradiation, électromédicaux et électrothérapeutiques (26600) / Industries manufacturières

    Où se situe REMOTE DIAGNOSTIC TECHNOLOGIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Ascent 1 Aerospace Boulevard
    GU14 6XW Farnborough
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de REMOTE DIAGNOSTIC TECHNOLOGIES LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour REMOTE DIAGNOSTIC TECHNOLOGIES LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au13 mai 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation27 mai 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au13 mai 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour REMOTE DIAGNOSTIC TECHNOLOGIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Nomination de Mr Ryan Landon en tant qu'administrateur le 31 déc. 2025

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mark Leftwich en tant que directeur le 31 déc. 2025

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Wilhelmus Gerardus Antonius Van Namen en tant que directeur le 31 déc. 2025

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Louise Helen Best en tant que directeur le 31 déc. 2025

    1 pagesTM01

    Nomination de Ms Elana Matt en tant qu'administrateur le 31 déc. 2025

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Xiaojun Zheng en tant qu'administrateur le 31 déc. 2025

    2 pagesAP01

    Inscription de la charge 033217820007, créée le 31 déc. 2025

    38 pagesMR01

    Inscription de la charge 033217820008, créée le 31 déc. 2025

    38 pagesMR01

    Cessation de la nomination de Louise Helen Best en tant que secrétaire le 31 déc. 2025

    1 pagesTM02

    Nomination de Ms Elana Matt en tant que secrétaire le 31 déc. 2025

    2 pagesAP03

    Statuts

    23 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduce share prem a/c 18/12/2025
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    État du capital au 19 déc. 2025

    • Capital: GBP 273.218
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reducation of share premium account 18/12/2025
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Notification de Heartstream Holding Company, Llc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 oct. 2025

    2 pagesPSC02

    Cessation de Koninklijke Philips N.V. en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 oct. 2025

    1 pagesPSC07

    État du capital après une attribution d'actions au 18 nov. 2025

    • Capital: GBP 273.219
    3 pagesSH01

    replacement-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date

    3 pagesRP01CS01

    replacement-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date

    3 pagesRP01CS01

    legacy

    4 pagesRP01SH01

    État du capital après une attribution d'actions au 27 oct. 2025

    • Capital: GBP 273.217
    4 pagesSH01
    Annotations
    DateAnnotation
    29 oct. 2025Replaced A replacement SH01 was registered on 29/10/2025 as the original contained an error

    Déclaration de confirmation établie le 13 mai 2025 avec mises à jour

    6 pagesCS01
    Annotations
    DateAnnotation
    03 nov. 2025Replaced A replacement CS01 (Statement of Capital and Shareholder Information) was registered 03/11/2025 as the original contained an error.

    Qui sont les dirigeants de REMOTE DIAGNOSTIC TECHNOLOGIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MATT, Elana
    Bothell Everett Highway
    Bothell
    22100
    Wa 98021-8431
    United States
    Secrétaire
    Bothell Everett Highway
    Bothell
    22100
    Wa 98021-8431
    United States
    343881920001
    LANDON, Ryan
    Bothell Everett Highway
    Bothell
    22100
    Wa 98021-8431
    United States
    Administrateur
    Bothell Everett Highway
    Bothell
    22100
    Wa 98021-8431
    United States
    United StatesAmerican344417000001
    MATT, Elana
    Bothell Everett Highway
    Bothell
    22100
    Wa 98021-8431
    United States
    Administrateur
    Bothell Everett Highway
    Bothell
    22100
    Wa 98021-8431
    United States
    United StatesAmerican343987930001
    ZHENG, Xiaojun
    Bothell Everett Highway
    Bothell
    22100
    Wa 98021-8431
    United States
    Administrateur
    Bothell Everett Highway
    Bothell
    22100
    Wa 98021-8431
    United States
    United StatesChinese343987700001
    BEST, Louise Helen
    Aerospace Boulevard
    GU14 6XW Farnborough
    Ascent 1
    England
    Secrétaire
    Aerospace Boulevard
    GU14 6XW Farnborough
    Ascent 1
    England
    247425430001
    MITCHELL, Paul James
    Tramway Close
    Chichester
    2
    West Sussex
    United Kingdom
    Secrétaire
    Tramway Close
    Chichester
    2
    West Sussex
    United Kingdom
    197303350001
    MURPHY, Catherine
    21 Abingdon Mansions
    Pater Street
    W8 6AB London
    Secrétaire
    21 Abingdon Mansions
    Pater Street
    W8 6AB London
    British57468430001
    MURPHY, Graham Francis
    77 Telegraph Lane
    Four Marks
    GU34 5AW Alton
    Starfield Cottage
    Hampshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    77 Telegraph Lane
    Four Marks
    GU34 5AW Alton
    Starfield Cottage
    Hampshire
    United Kingdom
    British51739070003
    MURPHY, Graham Francis
    Home Bungalow Lyeway Lane
    Ropley
    SO24 0DW Alresford
    Hampshire
    Secrétaire
    Home Bungalow Lyeway Lane
    Ropley
    SO24 0DW Alresford
    Hampshire
    British51739070001
    WHITAKER, Anne Michelle
    3 Tennyson Avenue
    Four Oaks
    B74 4YG Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secrétaire
    3 Tennyson Avenue
    Four Oaks
    B74 4YG Sutton Coldfield
    West Midlands
    British38436390001
    BEST, Louise Helen
    Aerospace Boulevard
    GU14 6XW Farnborough
    Ascent 1
    England
    Administrateur
    Aerospace Boulevard
    GU14 6XW Farnborough
    Ascent 1
    England
    EnglandBritish234847550001
    BLAGBROUGH, Paul Hampden
    Charnwood
    Horsell Park
    GU21 4LY Woking
    Surrey
    Administrateur
    Charnwood
    Horsell Park
    GU21 4LY Woking
    Surrey
    EnglandBritish2806800001
    DE CONINCK SMITH, Niels Harald
    Ashwood Park
    Ashwood Way
    RG23 8BG Basingstoke
    Pavilion C2
    Hampshire
    England
    Administrateur
    Ashwood Park
    Ashwood Way
    RG23 8BG Basingstoke
    Pavilion C2
    Hampshire
    England
    EnglandBritish180687670002
    LEFTWICH, Mark
    Aerospace Boulevard
    GU14 6XW Farnborough
    Ascent 1
    England
    Administrateur
    Aerospace Boulevard
    GU14 6XW Farnborough
    Ascent 1
    England
    EnglandBritish294380020001
    MESHER, Neil Anthony
    Aerospace Boulevard
    GU14 6XW Farnborough
    Ascent 1
    England
    Administrateur
    Aerospace Boulevard
    GU14 6XW Farnborough
    Ascent 1
    England
    EnglandBritish172236530001
    MITCHELL, Paul James
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    Philips Centre
    Surrey
    England
    Administrateur
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    Philips Centre
    Surrey
    England
    United KingdomBritish296229800001
    MITCHELL, Paul James
    Tramway Close
    Chichester
    2
    West Sussex
    United Kingdom
    Administrateur
    Tramway Close
    Chichester
    2
    West Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritish197320560001
    MURPHY, Catherine
    Ashwood Park
    Ashwood Way
    RG23 8BG Basingstoke
    Pavilion C2
    Hampshire
    England
    Administrateur
    Ashwood Park
    Ashwood Way
    RG23 8BG Basingstoke
    Pavilion C2
    Hampshire
    England
    EnglandBritish57468430001
    MURPHY, Catherine
    21 Abingdon Mansions
    Pater Street
    W8 6AB London
    Administrateur
    21 Abingdon Mansions
    Pater Street
    W8 6AB London
    EnglandBritish57468430001
    MURPHY, Dilys Anne, Dr
    Watmore Cottage
    Part Lane Riseley
    RG7 1RU Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Watmore Cottage
    Part Lane Riseley
    RG7 1RU Reading
    Berkshire
    EnglandBritish31009170001
    MURPHY, Graham Francis
    77 Telegraph Lane
    Four Marks
    GU34 5AW Alton
    Starfield Cottage
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    77 Telegraph Lane
    Four Marks
    GU34 5AW Alton
    Starfield Cottage
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish51739070003
    TRANTER, Graham
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    Philips Centre
    Surrey
    England
    Administrateur
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    Philips Centre
    Surrey
    England
    United KingdomBritish110536940001
    VAN NAMEN, Wilhelmus Gerardus Antonius
    Aerospace Boulevard
    GU14 6XW Farnborough
    Ascent 1
    England
    Administrateur
    Aerospace Boulevard
    GU14 6XW Farnborough
    Ascent 1
    England
    NetherlandsDutch262023630001
    WHITAKER, Anne Michelle
    3 Tennyson Avenue
    Four Oaks
    B74 4YG Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    3 Tennyson Avenue
    Four Oaks
    B74 4YG Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritish38436390001
    WHITAKER, Robert Alston
    3 Tennyson Avenue
    Four Oaks
    B74 4YG Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    3 Tennyson Avenue
    Four Oaks
    B74 4YG Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish37434920001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur REMOTE DIAGNOSTIC TECHNOLOGIES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Heartstream Holding Company, Llc
    Bothell Everett Highway
    Bothell
    22100
    Wa 98021-8431
    United States
    31 oct. 2025
    Bothell Everett Highway
    Bothell
    22100
    Wa 98021-8431
    United States
    Non
    Forme juridiqueLimited Liability Company
    Pays d'enregistrementUnited States
    Autorité légaleUs State Of Washington
    Lieu d'enregistrementWashington Secretary Of State
    Numéro d'enregistrement10081737
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Koninklijke Philips N.V.
    Campus 5
    5656AE Eindhoven
    High Tech
    Netherlands
    06 juin 2018
    Campus 5
    5656AE Eindhoven
    High Tech
    Netherlands
    Oui
    Forme juridiqueNaamloze Vennootschap
    Pays d'enregistrementNetherlands
    Autorité légaleNetherlands
    Lieu d'enregistrementNetherlands Chamber Of Commerce (Eindhoven)
    Numéro d'enregistrement17001910
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Mr Graham Murphy
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    Philips Centre
    Surrey
    England
    06 avr. 2016
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    Philips Centre
    Surrey
    England
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0