ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03324967 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED ?
| Adresse du siège social | Bridgeway House Bridgeway CV37 6YX Stratford-Upon-Avon Warwickshire England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Cessation de Atlas Hotels (Group 4 Property 2) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 déc. 2019 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Notification de London and Regional Group Hotel Holdings Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 déc. 2019 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 16 févr. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 7 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Adrian Paul Bradley en tant qu'administrateur le 19 mars 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 16 févr. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 30 sept. 2018 au 31 déc. 2018 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2017 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 16 févr. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Keith Ian Griffiths en tant que directeur le 05 janv. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Sean Joseph Lowe en tant qu'administrateur le 05 janv. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 033249670006 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2016 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 16 févr. 2017 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de No.1 London Bridge London SE1 9BG England à Quadrant House, Floor 6 4 Thomas More Square London E1W 1YW | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Période comptable actuelle raccourcie du 31 déc. 2016 au 30 sept. 2016 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 5 pages | AA | ||||||||||
Satisfaction de la charge 033249670005 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 18 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Inscription de la charge 033249670006, créée le 21 juin 2016 | 89 pages | MR01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 17 Dominion Street London EC2M 2EF à Bridgeway House Bridgeway Stratford-upon-Avon Warwickshire CV37 6YX le 29 juin 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Shaun Robinson en tant que directeur le 21 juin 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADLEY, Adrian Paul | Administrateur | Baker Street W1U 8EW London 55 United Kingdom | United Kingdom | British | 90379240002 | |||||
| LOWE, Sean Joseph | Administrateur | Bridgeway CV37 6YX Stratford-Upon-Avon Bridgeway House Warwickshire England | United Kingdom | British | 195752560001 | |||||
| INGRAM HILL, Sarah | Secrétaire | Monks Hollow Alton Priors SN8 4JX Marlborough Wiltshire | British | 59327230001 | ||||||
| MCCOLL, Fraser Robert | Secrétaire | Broom Cottage 1 Lodge Lane TN16 1RH Westerham Kent | British | 70649620002 | ||||||
| PENDRILL, Richard William | Secrétaire | Boscobel Sweetwater Lane Wormley GU8 5SS Godalming Surrey | British | 5919770001 | ||||||
| WARWICK, Timothy James | Secrétaire | Plas Y Coed 3 Cwrt Y Cadno St Fagans CF5 4PJ Cardiff Wales | British | 65745040001 | ||||||
| BEACH SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 100 Fetter Lane EC4A 1BN London | 900002710001 | |||||||
| MAWLAW SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Bishopsgate EC2M 3AF London 201 | 39182980003 | |||||||
| BARNES, Robert Digby Phillips | Administrateur | Brampton Chase Summerhouse Road GU7 1PY Godalming Surrey | United Kingdom | British | 59539070002 | |||||
| BELL, Alastair Marshall | Administrateur | 8 Thackeray Close Wimbledon SW19 4JL London | England | British | 87778630001 | |||||
| COUTURIER, Philippe | Administrateur | Dominion Street EC2M 2EF London 17 United Kingdom | England | French | 185748330001 | |||||
| DARLING, Mervyn | Administrateur | St James's House Charlotte Street M1 4DZ Manchester Allied Irish Bank United Kingdom | United Kingdom | Irish | 147824160001 | |||||
| DE BURETEL DE CHASSEY, Marc Frederic Marie | Administrateur | 19 Furlong Road N7 8LS London | French | 110966050002 | ||||||
| DESSOKY, Usama | Administrateur | 5 Rudgwick Terrace 20 Avenue Road NW8 6BR London | England | British | 85181940001 | |||||
| DODD, Angus Alexander | Administrateur | 13 Redgrave Road SW15 1PX London | British | 110965490001 | ||||||
| DUNN, Barrie | Administrateur | B316 Peninsula Apartments 4 Praed Street W2 1JE London | United Kingdom | British | 109512300001 | |||||
| EDDIS, Christopher Frederick | Administrateur | 102 Portland Road Holland Park W11 4LX London | United Kingdom | British | 59311260003 | |||||
| GILLESPIE, Brendan | Administrateur | Express By Holiday Inn Birmingham Nec Bickenhill Parkway B40 1QA Birmingham Central Office United Kingdom | British | 129902710001 | ||||||
| GRAUERS, Clifford Eric | Administrateur | Express By Holiday Inn Birmingham Nec Bickenhill Parkway B40 1QA Birmingham Central Office United Kingdom | England | British | 60557140001 | |||||
| GRAY, Robert Edward | Administrateur | Dominion Street EC2M 2EF London 17 | United Kingdom | British | 188584900001 | |||||
| GRIFFITHS, Keith Ian | Administrateur | Bridgeway CV37 6YX Stratford-Upon-Avon Bridgeway House Warwickshire England | United Kingdom | British | 77782610002 | |||||
| HILL, Timothy Ingram | Administrateur | Monks Hollow Alton Priors SN8 4JX Marlborough Wiltshire | British | 57283990001 | ||||||
| HORTHY, Sharif Istvan | Administrateur | 43 St Annes Crescent BN7 1SD Lewes East Sussex | England | British | 59598440001 | |||||
| INGRAM HILL, Sarah | Administrateur | Monks Hollow Alton Priors SN8 4JX Marlborough Wiltshire | British | 59327230001 | ||||||
| KINGSMILL, Robert Martin | Administrateur | Express By Holiday Inn Birmingham Nec Bickenhill Parkway B40 1QA Birmingham Central Office | United Kingdom | British | 139337530001 | |||||
| MCKEVITT, Richard | Administrateur | Nightingales Lane HP8 4SF Chalfont St. Giles Tyhurst Buckinghamshire | United Kingdom | British | 142295770001 | |||||
| MERCHANT, David John | Administrateur | 9 Fairmile Court KT11 2DS Cobham Surrey | England | British | 102844250001 | |||||
| MITCHELL, Stephen David | Administrateur | Great Portland Street W1W 5LS London 179 | England | British | 95336510001 | |||||
| MORAR, Neal | Administrateur | Dominion Street EC2M 2EF London 17 United Kingdom | England | British | 173110500001 | |||||
| MYERS, David Paul | Administrateur | Great Portland Street W1W 5LS London 179 England | England | British | 142171370001 | |||||
| NOBLE, David | Administrateur | Great Portland Street W1W 5LS London 179-185 | England | British | 127359410001 | |||||
| ROBINSON, Shaun | Administrateur | Bridgeway CV37 6YX Stratford-Upon-Avon Bridgeway House Warwickshire England | United Kingdom | British | 101627760001 | |||||
| STOCKTON, Richard | Administrateur | Dominion Street EC2M 2EF London 17 | United Kingdom | British | 173676030001 | |||||
| WHITBY, Peter James | Administrateur | Great Portland Street W1W 5LS London 179-185 | England | English | 76096790002 | |||||
| CROFT NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | 100 Fetter Lane EC4A 1BN London | 900002700001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London And Regional Group Hotel Holdings Ltd | 12 déc. 2019 | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Atlas Hotels (Group 4 Property 2) Limited | 06 avr. 2016 | Dominion Street EC2M 2EF London 17 England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 21 juin 2016 Livré le 30 juin 2016 | Totalement satisfaite | ||
Brève description The freehold and leasehold interests in holiday inn express stafford, stafford south, acton court, acton gate, stafford, ST18 9AP with title numbers SF384424 and SF381471 and SF525024 and, where the context so requires, includes the buildings on the property. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 17 déc. 2014 Livré le 19 déc. 2014 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 12 oct. 2007 Livré le 19 oct. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The properties listed in schedule 2 of T. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 23 nov. 2005 Livré le 05 déc. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Land lying on the west side of redbridge lane mursling southampton t/no HP581790,land lying to the north of hyde road gorton manchester t/no GM821643,land at harbledown canterbury t/no K787140 (for details of further properties charged plea. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 08 mai 2003 Livré le 13 mai 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from ingram hotels limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All that l/h property k/a express by holiday inn stafford south acton court acton gate stafford t/n SF381471 together with the f/h land lying to the west of stafford road acton gate t/n SF384424. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 08 mai 2003 Livré le 13 mai 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0