ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED

ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03324967
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Bridgeway House
    Bridgeway
    CV37 6YX Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MORETHANHOTELS (STAFFORD) LIMITED25 nov. 200525 nov. 2005
    FOREMOST HOTELS (STAFFORD) LIMITED30 mai 200330 mai 2003
    INGRAM (STAFFORD) LIMITED09 juil. 199809 juil. 1998
    ROADCHEF (STAFFORD) LIMITED23 avr. 199723 avr. 1997
    BEALAW (430) LIMITED27 févr. 199727 févr. 1997

    Quels sont les derniers comptes de ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Cessation de Atlas Hotels (Group 4 Property 2) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 déc. 2019

    1 pagesPSC07

    Notification de London and Regional Group Hotel Holdings Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 déc. 2019

    2 pagesPSC02

    Déclaration de confirmation établie le 16 févr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    7 pagesAA

    Nomination de Mr Adrian Paul Bradley en tant qu'administrateur le 19 mars 2019

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 16 févr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Période comptable précédente prolongée du 30 sept. 2018 au 31 déc. 2018

    1 pagesAA01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2017

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 16 févr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Keith Ian Griffiths en tant que directeur le 05 janv. 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Sean Joseph Lowe en tant qu'administrateur le 05 janv. 2018

    2 pagesAP01

    Satisfaction de la charge 033249670006 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2016

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 16 févr. 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de No.1 London Bridge London SE1 9BG England à Quadrant House, Floor 6 4 Thomas More Square London E1W 1YW

    1 pagesAD02

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 déc. 2016 au 30 sept. 2016

    1 pagesAA01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    5 pagesAA

    Satisfaction de la charge 033249670005 en totalité

    1 pagesMR04

    Résolutions

    Resolutions
    18 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Inscription de la charge 033249670006, créée le 21 juin 2016

    89 pagesMR01

    Changement d'adresse du siège social de 17 Dominion Street London EC2M 2EF à Bridgeway House Bridgeway Stratford-upon-Avon Warwickshire CV37 6YX le 29 juin 2016

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Shaun Robinson en tant que directeur le 21 juin 2016

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BRADLEY, Adrian Paul
    Baker Street
    W1U 8EW London
    55
    United Kingdom
    Administrateur
    Baker Street
    W1U 8EW London
    55
    United Kingdom
    United KingdomBritish90379240002
    LOWE, Sean Joseph
    Bridgeway
    CV37 6YX Stratford-Upon-Avon
    Bridgeway House
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    Bridgeway
    CV37 6YX Stratford-Upon-Avon
    Bridgeway House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish195752560001
    INGRAM HILL, Sarah
    Monks Hollow Alton Priors
    SN8 4JX Marlborough
    Wiltshire
    Secrétaire
    Monks Hollow Alton Priors
    SN8 4JX Marlborough
    Wiltshire
    British59327230001
    MCCOLL, Fraser Robert
    Broom Cottage
    1 Lodge Lane
    TN16 1RH Westerham
    Kent
    Secrétaire
    Broom Cottage
    1 Lodge Lane
    TN16 1RH Westerham
    Kent
    British70649620002
    PENDRILL, Richard William
    Boscobel Sweetwater Lane
    Wormley
    GU8 5SS Godalming
    Surrey
    Secrétaire
    Boscobel Sweetwater Lane
    Wormley
    GU8 5SS Godalming
    Surrey
    British5919770001
    WARWICK, Timothy James
    Plas Y Coed 3 Cwrt Y Cadno
    St Fagans
    CF5 4PJ Cardiff
    Wales
    Secrétaire
    Plas Y Coed 3 Cwrt Y Cadno
    St Fagans
    CF5 4PJ Cardiff
    Wales
    British65745040001
    BEACH SECRETARIES LIMITED
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    Secrétaire désigné
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    900002710001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    Secrétaire
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    39182980003
    BARNES, Robert Digby Phillips
    Brampton Chase
    Summerhouse Road
    GU7 1PY Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Brampton Chase
    Summerhouse Road
    GU7 1PY Godalming
    Surrey
    United KingdomBritish59539070002
    BELL, Alastair Marshall
    8 Thackeray Close
    Wimbledon
    SW19 4JL London
    Administrateur
    8 Thackeray Close
    Wimbledon
    SW19 4JL London
    EnglandBritish87778630001
    COUTURIER, Philippe
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    Administrateur
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    EnglandFrench185748330001
    DARLING, Mervyn
    St James's House
    Charlotte Street
    M1 4DZ Manchester
    Allied Irish Bank
    United Kingdom
    Administrateur
    St James's House
    Charlotte Street
    M1 4DZ Manchester
    Allied Irish Bank
    United Kingdom
    United KingdomIrish147824160001
    DE BURETEL DE CHASSEY, Marc Frederic Marie
    19 Furlong Road
    N7 8LS London
    Administrateur
    19 Furlong Road
    N7 8LS London
    French110966050002
    DESSOKY, Usama
    5 Rudgwick Terrace
    20 Avenue Road
    NW8 6BR London
    Administrateur
    5 Rudgwick Terrace
    20 Avenue Road
    NW8 6BR London
    EnglandBritish85181940001
    DODD, Angus Alexander
    13 Redgrave Road
    SW15 1PX London
    Administrateur
    13 Redgrave Road
    SW15 1PX London
    British110965490001
    DUNN, Barrie
    B316 Peninsula Apartments
    4 Praed Street
    W2 1JE London
    Administrateur
    B316 Peninsula Apartments
    4 Praed Street
    W2 1JE London
    United KingdomBritish109512300001
    EDDIS, Christopher Frederick
    102 Portland Road
    Holland Park
    W11 4LX London
    Administrateur
    102 Portland Road
    Holland Park
    W11 4LX London
    United KingdomBritish59311260003
    GILLESPIE, Brendan
    Express By Holiday Inn Birmingham Nec
    Bickenhill Parkway
    B40 1QA Birmingham
    Central Office
    United Kingdom
    Administrateur
    Express By Holiday Inn Birmingham Nec
    Bickenhill Parkway
    B40 1QA Birmingham
    Central Office
    United Kingdom
    British129902710001
    GRAUERS, Clifford Eric
    Express By Holiday Inn Birmingham Nec
    Bickenhill Parkway
    B40 1QA Birmingham
    Central Office
    United Kingdom
    Administrateur
    Express By Holiday Inn Birmingham Nec
    Bickenhill Parkway
    B40 1QA Birmingham
    Central Office
    United Kingdom
    EnglandBritish60557140001
    GRAY, Robert Edward
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    Administrateur
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United KingdomBritish188584900001
    GRIFFITHS, Keith Ian
    Bridgeway
    CV37 6YX Stratford-Upon-Avon
    Bridgeway House
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    Bridgeway
    CV37 6YX Stratford-Upon-Avon
    Bridgeway House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish77782610002
    HILL, Timothy Ingram
    Monks Hollow
    Alton Priors
    SN8 4JX Marlborough
    Wiltshire
    Administrateur
    Monks Hollow
    Alton Priors
    SN8 4JX Marlborough
    Wiltshire
    British57283990001
    HORTHY, Sharif Istvan
    43 St Annes Crescent
    BN7 1SD Lewes
    East Sussex
    Administrateur
    43 St Annes Crescent
    BN7 1SD Lewes
    East Sussex
    EnglandBritish59598440001
    INGRAM HILL, Sarah
    Monks Hollow Alton Priors
    SN8 4JX Marlborough
    Wiltshire
    Administrateur
    Monks Hollow Alton Priors
    SN8 4JX Marlborough
    Wiltshire
    British59327230001
    KINGSMILL, Robert Martin
    Express By Holiday Inn Birmingham Nec
    Bickenhill Parkway
    B40 1QA Birmingham
    Central Office
    Administrateur
    Express By Holiday Inn Birmingham Nec
    Bickenhill Parkway
    B40 1QA Birmingham
    Central Office
    United KingdomBritish139337530001
    MCKEVITT, Richard
    Nightingales Lane
    HP8 4SF Chalfont St. Giles
    Tyhurst
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Nightingales Lane
    HP8 4SF Chalfont St. Giles
    Tyhurst
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish142295770001
    MERCHANT, David John
    9 Fairmile Court
    KT11 2DS Cobham
    Surrey
    Administrateur
    9 Fairmile Court
    KT11 2DS Cobham
    Surrey
    EnglandBritish102844250001
    MITCHELL, Stephen David
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    Administrateur
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    EnglandBritish95336510001
    MORAR, Neal
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    Administrateur
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritish173110500001
    MYERS, David Paul
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    Administrateur
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    EnglandBritish142171370001
    NOBLE, David
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179-185
    Administrateur
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179-185
    EnglandBritish127359410001
    ROBINSON, Shaun
    Bridgeway
    CV37 6YX Stratford-Upon-Avon
    Bridgeway House
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    Bridgeway
    CV37 6YX Stratford-Upon-Avon
    Bridgeway House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish101627760001
    STOCKTON, Richard
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    Administrateur
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United KingdomBritish173676030001
    WHITBY, Peter James
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179-185
    Administrateur
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179-185
    EnglandEnglish76096790002
    CROFT NOMINEES LIMITED
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    Administrateur désigné
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    900002700001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Quadrant House, Floor 6
    United Kingdom
    12 déc. 2019
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Quadrant House, Floor 6
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement11393145
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    06 avr. 2016
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    Oui
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03328699
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 21 juin 2016
    Livré le 30 juin 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    The freehold and leasehold interests in holiday inn express stafford, stafford south, acton court, acton gate, stafford, ST18 9AP with title numbers SF384424 and SF381471 and SF525024 and, where the context so requires, includes the buildings on the property.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transactions
    • 30 juin 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 08 nov. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 17 déc. 2014
    Livré le 19 déc. 2014
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Transactions
    • 19 déc. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 07 juil. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 12 oct. 2007
    Livré le 19 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The properties listed in schedule 2 of T. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Finance Parties (Security Trustee)
    Transactions
    • 19 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 avr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 23 nov. 2005
    Livré le 05 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Land lying on the west side of redbridge lane mursling southampton t/no HP581790,land lying to the north of hyde road gorton manchester t/no GM821643,land at harbledown canterbury t/no K787140 (for details of further properties charged plea. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mars 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 23 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 08 mai 2003
    Livré le 13 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from ingram hotels limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that l/h property k/a express by holiday inn stafford south acton court acton gate stafford t/n SF381471 together with the f/h land lying to the west of stafford road acton gate t/n SF384424. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 mai 2003
    Livré le 13 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0