BLU INVESTMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBLU INVESTMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03325064
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BLU INVESTMENTS LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe BLU INVESTMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BLU INVESTMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PCO 169 LIMITED21 févr. 199721 févr. 1997

    Quels sont les derniers comptes de BLU INVESTMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour BLU INVESTMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    legacy

    1 pages652a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    6 pages363a

    legacy

    1 pages353

    Comptes annuels établis au 31 mars 2007

    19 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de BLU INVESTMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    Secrétaire
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    British32809000002
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    Administrateur
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director1898090001
    PAILEX CORPORATE SERVICES LIMITED
    First Floor Bouverie House
    154 Fleet Street
    EC4A 2DQ London
    Secrétaire désigné
    First Floor Bouverie House
    154 Fleet Street
    EC4A 2DQ London
    900013000001
    ADAM, Shenol
    13 Beech Drive
    N2 9NX London
    Administrateur
    13 Beech Drive
    N2 9NX London
    BritishCompany Director2068480001
    BARNES, Eric Malcolm
    148 Chapel Lane
    Ravenshead
    NG15 9DJ Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    148 Chapel Lane
    Ravenshead
    NG15 9DJ Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director20256100002
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    Administrateur
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    United KingdomBritishHead Of Finance58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    Administrateur
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    EnglandBritishChartered Accountant32809050004
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Administrateur
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritishChartered Surveyor152497530001
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    Administrateur
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    United KingdomBritishChartered Secretary32809000002
    BURY, David Gordon
    The Viking Wing
    Thurland Castle Tunstall
    LA6 2QR Lancaster
    Lancashire
    Administrateur
    The Viking Wing
    Thurland Castle Tunstall
    LA6 2QR Lancaster
    Lancashire
    United KingdomBritishCompany Director114282510002
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Administrateur
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Secretary78691990003
    GUNSTON, Michael Ian
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    Administrateur
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor3079890002
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Administrateur
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    BritishChief Executive51688320001
    HINCHLEY, David
    20 Leconfield Garth
    Follifoot
    HG3 1NF Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    20 Leconfield Garth
    Follifoot
    HG3 1NF Harrogate
    North Yorkshire
    BritishManagement Accountant21091680001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Administrateur
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritishCompany Director82020730004
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Administrateur
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    BritishChartered Accountant3079600001
    MORRIS, David
    4 Greenmount Drive
    Greenmount
    BL8 4HA Bury
    Lancashire
    Administrateur
    4 Greenmount Drive
    Greenmount
    BL8 4HA Bury
    Lancashire
    BritishCompany Sec3442030001
    PELTZ, Daniel
    9 Cavendish Avenue
    St Johns Wood
    NW8 9JD London
    Administrateur
    9 Cavendish Avenue
    St Johns Wood
    NW8 9JD London
    United KingdomBritishCompany Director34366280004
    RITBLAT, John, Sir
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    Administrateur
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    EnglandBritishChairman And Managing Director41694870001
    RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    Administrateur
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    United KingdomBritishCompany Director35758050004
    RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    Administrateur
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    United KingdomBritishDirector35758050004
    ROBERTS, Graham Charles
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    Administrateur
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    EnglandBritishChartered Accountant79807180002
    ROBERTS, Timothy Andrew
    Lorne House
    Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Lorne House
    Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Surveyor63986410003
    ROSEFIELD, Stephen Michael
    154 Fleet Street
    1st Floor, Bouverie House
    EC4A 2DQ London
    Administrateur
    154 Fleet Street
    1st Floor, Bouverie House
    EC4A 2DQ London
    BritishSolicitor51560380002
    TYLER, David Alan
    6 Ernle Road
    Wimbledon
    SW20 0HJ London
    Administrateur
    6 Ernle Road
    Wimbledon
    SW20 0HJ London
    BritishCompany Director51860290001
    WEBB, Nigel Mark
    Beech Lodge
    53 Crouch Hall Lane Redbourn
    AL3 7EU St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    Beech Lodge
    53 Crouch Hall Lane Redbourn
    AL3 7EU St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Surveyor58059360001
    WESTON SMITH, John Harry
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    Administrateur
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    EnglandBritishChartered Secretary13547380001

    BLU INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Third supplemental trust deed supplemental to a trust deed dated 31 march 1998 (the principal trust deed),as defined,and securing the £100,000,000 6 > per cent.first mortgage debenture bonds 2011 and £200,000,000 6 > per cent. First mortgage debenture bonds due 2020 of the company (the bonds) and the first supplemental trust deed dated 13 april 1999 (as defined)
    Créé le 30 mars 2001
    Livré le 10 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The payment of the principal of,premium (if any) and all other moneys due or to become due from bl universal PLC to the chargee under or pursuant to the trust deed
    Brèves mentions
    All rights,title and interest in the leasehold and freehold premises known as (I) 23/25 english st,carlisle; (ii) 35 high st,chelmsford; (iii) 41 oxford st,kidderminster plus other properties listed. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Exchange Trust Company Limited,as Trustee for the Holders of Thebonds
    Transactions
    • 10 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juin 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 18 nov. 1998
    Livré le 04 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The payment of the principal of,premium (if any) and interest on the bonds,and any further bonds and all other moneys covenanted to be paid by bl universal PLC to the chargee under or pursuant to the trust deed
    Brèves mentions
    The premises at 20 donegall place,belfast comprised in and held under lease dated 1 august 1929.
    Personnes ayant droit
    • Royal Exchange Trust Company Limited (The "Trustee")
    Transactions
    • 04 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2006Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 19 juin 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 19 mai 1998
    Livré le 21 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The payment of the principal of premium (if any) and interest on the original bonds (as defined) and all further bonds (as defined) and all monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the mortgage
    Brèves mentions
    F/H premises comprising part of the arches retail park connswater belfast; l/h premises forming part of the arches retail park connswater belfast; l/h premises situate at albertbridge road belfast.
    Personnes ayant droit
    • Royal Exchange Trust Company Limited ("the Trustee")
    Transactions
    • 21 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juin 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage in relation to a trust deed dated 31ST march 1998 constituting and securing £100,000,000 6 3/4 per cent. First mortgage debenture bonds due 2011 and £200,000,000 6 3/4 per cent. First mortgage debenture bonds due 2020 (with authority to issue further first mortgage debenture bonds or notes) (the bonds)
    Créé le 31 mars 1998
    Livré le 18 avr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The payment of the principal of, premium (if any) and interest on the original bonds and all further bonds and all other moneys covenanted to be paid by the company to the chargee (the trustee) under or pursuant to the mortgage
    Brèves mentions
    F/H and l/h premises k/a connswater shopping centre belfast.
    Personnes ayant droit
    • Royal Exchange Trust Company Limited
    Transactions
    • 18 avr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juin 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Trust deed dated 31ST march 1998 constituting and securing £100,000,000 6 3/4 per cent. First mortgage debenture bonds due 2011 and £200,000,000 6 3/4 per cent. First mortgage debenture bonds due 2020 (with authority to issue further first mortgage debenture bonds or notes)
    Créé le 31 mars 1998
    Livré le 16 avr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The payment of the principal of, the premium (if any) and interest on the bonds and all other moneys covenanted to be paid by bl universal PLC to the trustee under or pursuant to the trust deed
    Brèves mentions
    Various properties as specified on form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Exchange Trust Company Limited(As Trustee for the Holders of the Bonds)
    Transactions
    • 16 avr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 août 2005Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 16 août 2005Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 19 juin 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0