KESTREL FM LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKESTREL FM LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03326134
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KESTREL FM LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe KESTREL FM LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Media House Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de KESTREL FM LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour KESTREL FM LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Période comptable précédente prolongée du 30 sept. 2020 au 31 déc. 2020

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 28 févr. 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2019

    7 pagesAA

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 01 oct. 2020

    • Capital: GBP 1.00
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share premium account cancelled 15/09/2020
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Statuts

    11 pagesMA

    Déclaration de confirmation établie le 29 févr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Diedre Ann Ford le 31 janv. 2019

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 28 févr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des détails de Celador Radio Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 févr. 2019

    2 pagesPSC05

    Cessation de Celador Entertainment Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 janv. 2019

    1 pagesPSC07

    Notification de Celador Radio Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 janv. 2019

    2 pagesPSC02

    Cessation de la nomination de Paul Adrian Smith en tant que directeur le 31 janv. 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Bauer Group Secretariat Limited en tant que secrétaire le 31 janv. 2019

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Paul Michael Charman en tant que directeur le 31 janv. 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Sarah Jane Vickery en tant qu'administrateur le 31 janv. 2019

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Paul Anthony Keenan en tant qu'administrateur le 31 janv. 2019

    2 pagesAP01

    Nomination de Diedre Ann Ford en tant qu'administrateur le 31 janv. 2019

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Celador Radio Roman Landing Kingsway Southampton Hampshire SO14 1BN England à Media House Peterborough Business Park Lynch Wood Peterborough PE2 6EA le 15 févr. 2019

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de KESTREL FM LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BAUER GROUP SECRETARIAT LIMITED
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement00944753
    159023720001
    FORD, Deidre Ann
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Administrateur
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    EnglandBritish255749500002
    KEENAN, Paul Anthony
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Administrateur
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    EnglandBritish39692770004
    VICKERY, Sarah Jane
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Administrateur
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    United KingdomBritish119137220002
    CHESTER, Brian Robert
    Millstone
    39 Windmill Field
    GU20 6QD Windlesham
    Surrey
    Secrétaire
    Millstone
    39 Windmill Field
    GU20 6QD Windlesham
    Surrey
    British68831100001
    CHRISTMAS, Colin Roy George
    College Place
    Alfred Road
    GU9 8JE Farnham
    4
    Surrey
    England
    Secrétaire
    College Place
    Alfred Road
    GU9 8JE Farnham
    4
    Surrey
    England
    British1678140002
    EUSTACE, Timothy
    7 Gardiner Close
    OX14 3YA Abingdon
    Oxfordshire
    Secrétaire
    7 Gardiner Close
    OX14 3YA Abingdon
    Oxfordshire
    British5555740001
    JOHNSON, Mark Alasdair Smith
    Long Acre
    WC2E 9LG London
    39
    United Kingdom
    Secrétaire
    Long Acre
    WC2E 9LG London
    39
    United Kingdom
    171903190001
    ROCHE, John Philip
    Wheathold Farm
    Ramsdell
    RG26 5SA Tadley
    Hampshire
    Secrétaire
    Wheathold Farm
    Ramsdell
    RG26 5SA Tadley
    Hampshire
    British30692560001
    YATES, Susan Ruth
    7 Woodbourne
    GU9 9EF Farnham
    Surrey
    Secrétaire
    7 Woodbourne
    GU9 9EF Farnham
    Surrey
    British55952690003
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secrétaire désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    ALLEN, Donald Gordon
    5 Heathrow Copse
    Baughurst
    RG26 5JG Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    5 Heathrow Copse
    Baughurst
    RG26 5JG Basingstoke
    Hampshire
    British38741630001
    ALLEN, Paul
    9 Alderney Avenue
    Hatch Warren
    RG22 4UA Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    9 Alderney Avenue
    Hatch Warren
    RG22 4UA Basingstoke
    Hampshire
    British81730010002
    AVIS, Richard Joseph Andrew
    8 Pamber Heath Road
    Pamber Heath
    RG26 3TQ Tadley
    Hampshire
    Administrateur
    8 Pamber Heath Road
    Pamber Heath
    RG26 3TQ Tadley
    Hampshire
    EnglandBritish53550320001
    BAKER, John
    1 Pound Cottages
    Stroud Green
    RG14 7JH Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    1 Pound Cottages
    Stroud Green
    RG14 7JH Newbury
    Berkshire
    British122288220001
    CHAPMAN, Kimberlee Ann
    29 Queens Road
    Caversham
    RG4 8DN Reading
    Berkshire
    Administrateur
    29 Queens Road
    Caversham
    RG4 8DN Reading
    Berkshire
    British68903800001
    CHARMAN, Paul Michael
    c/o P Charman
    Celador Radio Ltd
    Festival Place
    RG21 7LJ Basingstoke
    Suite 2 Paddington House
    England
    Administrateur
    c/o P Charman
    Celador Radio Ltd
    Festival Place
    RG21 7LJ Basingstoke
    Suite 2 Paddington House
    England
    EnglandBritish226735460001
    CHESTER, Brian Robert
    Millstone
    39 Windmill Field
    GU20 6QD Windlesham
    Surrey
    Administrateur
    Millstone
    39 Windmill Field
    GU20 6QD Windlesham
    Surrey
    EnglandBritish68831100001
    CHRISTMAS, Colin Roy George
    College Place
    Alfred Road
    GU9 8JE Farnham
    4
    Surrey
    England
    Administrateur
    College Place
    Alfred Road
    GU9 8JE Farnham
    4
    Surrey
    England
    EnglandBritish1678140002
    CRAIG, Andrew Timms
    West Barn
    Manor Lane Oare
    RG18 9SB Hermitage
    Berkshire
    Administrateur
    West Barn
    Manor Lane Oare
    RG18 9SB Hermitage
    Berkshire
    EnglandBritish34714840003
    CRAIG, Wendy Diane, Mrs.
    Coniston Drive
    GU9 0DA Farnham
    6
    Surrey
    Administrateur
    Coniston Drive
    GU9 0DA Farnham
    6
    Surrey
    United KingdomBritish57867210001
    DOEL, Brian Gilroy
    Little Court
    PL20 6EF Yelverton
    Devon
    Administrateur
    Little Court
    PL20 6EF Yelverton
    Devon
    EnglandBritish107694860001
    FAGAN, Florence Mary
    Deane Hill House
    Deane
    RG25 3AX Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    Deane Hill House
    Deane
    RG25 3AX Basingstoke
    Hampshire
    EnglandBritish18789240001
    FUSSEY, Stephen Frederick
    Frimley 4 Cedar Close
    RG26 3SL Tadley
    Hampshire
    Administrateur
    Frimley 4 Cedar Close
    RG26 3SL Tadley
    Hampshire
    British53550330001
    HAROLD, Michael Victor
    The Maltings
    Mapledurwell
    RG25 2LJ Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    The Maltings
    Mapledurwell
    RG25 2LJ Basingstoke
    Hampshire
    British51992990001
    HAWKSLEY, Andrew
    c/o Celador Radio
    Kingsway
    SO14 1BN Southampton
    Romans Landing
    England
    Administrateur
    c/o Celador Radio
    Kingsway
    SO14 1BN Southampton
    Romans Landing
    England
    EnglandBritish244980330001
    HOLMES, Ronald
    Ivy House
    Mapledurwell
    RG25 2LG Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    Ivy House
    Mapledurwell
    RG25 2LG Basingstoke
    Hampshire
    EnglandBritish26355080001
    HUGHES, Lawrence Edward
    Hilltops 3 Tadley Hill
    Tadley
    RG26 6PN Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    Hilltops 3 Tadley Hill
    Tadley
    RG26 6PN Basingstoke
    Hampshire
    British48194990001
    JOHNSON, Mark Alasdair Smith
    Long Acre
    WC2E 9LG London
    39
    United Kingdom
    Administrateur
    Long Acre
    WC2E 9LG London
    39
    United Kingdom
    United KingdomBritish79195840006
    MANNING, Richard Denley John
    39 Ash Lane
    BA5 2LR Wells
    Somerset
    Administrateur
    39 Ash Lane
    BA5 2LR Wells
    Somerset
    United KingdomBritish77961690001
    POTTERELL, Clive Ronald
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    Administrateur
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    EnglandBritish3182530002
    REEVE, Nigel John
    Links Farmhouse Ayleswade Lane
    Biddenden
    TN27 8LE Ashford
    Kent
    Administrateur
    Links Farmhouse Ayleswade Lane
    Biddenden
    TN27 8LE Ashford
    Kent
    British59213560003
    REYNOLDS, Susan Anne
    115 Pack Lane
    Kempshott
    RG22 5HH Basingstoke
    Hants
    Administrateur
    115 Pack Lane
    Kempshott
    RG22 5HH Basingstoke
    Hants
    EnglandBritish109984070001
    ROBERTSON, John
    8 The Chase
    Donnington
    RG14 3AQ Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    8 The Chase
    Donnington
    RG14 3AQ Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish4907930002
    ROCHE, John Philip
    Wheathold Farm
    Ramsdell
    RG26 5SA Tadley
    Hampshire
    Administrateur
    Wheathold Farm
    Ramsdell
    RG26 5SA Tadley
    Hampshire
    British30692560001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur KESTREL FM LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    31 janv. 2019
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement05439096
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Kingsway
    St Marys Place
    SO14 1BN Southampton
    Roman Landing
    England
    06 avr. 2016
    Kingsway
    St Marys Place
    SO14 1BN Southampton
    Roman Landing
    England
    Oui
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement05679435
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    KESTREL FM LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Rent deposit deed
    Créé le 14 févr. 2008
    Livré le 22 févr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £5000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All monies from time to time stanidng to the account pursuant to the rent deposit deed.
    Personnes ayant droit
    • Grosvenor Basingstoke Properties Limited and Grosvenor Basingstoke Management Limited
    Transactions
    • 22 févr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 janv. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 15 avr. 1998
    Livré le 24 avr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The observance and performance of the obligations of the tenant in the deed and the obligations of the lessee to grosvenor (basingstoke) limited under the lease
    Brèves mentions
    The company's equitable interest in:(1) the sum of £5,000 paid by the company to the landlord and which the landlord is obliged under the deed to pay into the account (as defined).(2) any other sums paid into that account by the tenant pursuant to the deed and any interest credited to that account.
    Personnes ayant droit
    • Grosvenor (Basingstoke) Limited
    Transactions
    • 24 avr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 13 févr. 1998
    Livré le 18 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0