KESTREL FM LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | KESTREL FM LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03326134 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe KESTREL FM LIMITED ?
| Adresse du siège social | Media House Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de KESTREL FM LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour KESTREL FM LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 30 sept. 2020 au 31 déc. 2020 | 1 pages | AA01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 28 févr. 2021 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2019 | 7 pages | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 01 oct. 2020
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Statuts | 11 pages | MA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 29 févr. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Diedre Ann Ford le 31 janv. 2019 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 28 févr. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Modification des détails de Celador Radio Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 févr. 2019 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||||||
Cessation de Celador Entertainment Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 janv. 2019 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||||||
Notification de Celador Radio Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 janv. 2019 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Adrian Smith en tant que directeur le 31 janv. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Bauer Group Secretariat Limited en tant que secrétaire le 31 janv. 2019 | 2 pages | AP04 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Michael Charman en tant que directeur le 31 janv. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Mrs Sarah Jane Vickery en tant qu'administrateur le 31 janv. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Paul Anthony Keenan en tant qu'administrateur le 31 janv. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Diedre Ann Ford en tant qu'administrateur le 31 janv. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Celador Radio Roman Landing Kingsway Southampton Hampshire SO14 1BN England à Media House Peterborough Business Park Lynch Wood Peterborough PE2 6EA le 15 févr. 2019 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de KESTREL FM LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUER GROUP SECRETARIAT LIMITED | Secrétaire | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom |
| 159023720001 | ||||||||||
| FORD, Deidre Ann | Administrateur | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom | England | British | 255749500002 | |||||||||
| KEENAN, Paul Anthony | Administrateur | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom | England | British | 39692770004 | |||||||||
| VICKERY, Sarah Jane | Administrateur | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom | United Kingdom | British | 119137220002 | |||||||||
| CHESTER, Brian Robert | Secrétaire | Millstone 39 Windmill Field GU20 6QD Windlesham Surrey | British | 68831100001 | ||||||||||
| CHRISTMAS, Colin Roy George | Secrétaire | College Place Alfred Road GU9 8JE Farnham 4 Surrey England | British | 1678140002 | ||||||||||
| EUSTACE, Timothy | Secrétaire | 7 Gardiner Close OX14 3YA Abingdon Oxfordshire | British | 5555740001 | ||||||||||
| JOHNSON, Mark Alasdair Smith | Secrétaire | Long Acre WC2E 9LG London 39 United Kingdom | 171903190001 | |||||||||||
| ROCHE, John Philip | Secrétaire | Wheathold Farm Ramsdell RG26 5SA Tadley Hampshire | British | 30692560001 | ||||||||||
| YATES, Susan Ruth | Secrétaire | 7 Woodbourne GU9 9EF Farnham Surrey | British | 55952690003 | ||||||||||
| LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire désigné | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||||||
| ALLEN, Donald Gordon | Administrateur | 5 Heathrow Copse Baughurst RG26 5JG Basingstoke Hampshire | British | 38741630001 | ||||||||||
| ALLEN, Paul | Administrateur | 9 Alderney Avenue Hatch Warren RG22 4UA Basingstoke Hampshire | British | 81730010002 | ||||||||||
| AVIS, Richard Joseph Andrew | Administrateur | 8 Pamber Heath Road Pamber Heath RG26 3TQ Tadley Hampshire | England | British | 53550320001 | |||||||||
| BAKER, John | Administrateur | 1 Pound Cottages Stroud Green RG14 7JH Newbury Berkshire | British | 122288220001 | ||||||||||
| CHAPMAN, Kimberlee Ann | Administrateur | 29 Queens Road Caversham RG4 8DN Reading Berkshire | British | 68903800001 | ||||||||||
| CHARMAN, Paul Michael | Administrateur | c/o P Charman Celador Radio Ltd Festival Place RG21 7LJ Basingstoke Suite 2 Paddington House England | England | British | 226735460001 | |||||||||
| CHESTER, Brian Robert | Administrateur | Millstone 39 Windmill Field GU20 6QD Windlesham Surrey | England | British | 68831100001 | |||||||||
| CHRISTMAS, Colin Roy George | Administrateur | College Place Alfred Road GU9 8JE Farnham 4 Surrey England | England | British | 1678140002 | |||||||||
| CRAIG, Andrew Timms | Administrateur | West Barn Manor Lane Oare RG18 9SB Hermitage Berkshire | England | British | 34714840003 | |||||||||
| CRAIG, Wendy Diane, Mrs. | Administrateur | Coniston Drive GU9 0DA Farnham 6 Surrey | United Kingdom | British | 57867210001 | |||||||||
| DOEL, Brian Gilroy | Administrateur | Little Court PL20 6EF Yelverton Devon | England | British | 107694860001 | |||||||||
| FAGAN, Florence Mary | Administrateur | Deane Hill House Deane RG25 3AX Basingstoke Hampshire | England | British | 18789240001 | |||||||||
| FUSSEY, Stephen Frederick | Administrateur | Frimley 4 Cedar Close RG26 3SL Tadley Hampshire | British | 53550330001 | ||||||||||
| HAROLD, Michael Victor | Administrateur | The Maltings Mapledurwell RG25 2LJ Basingstoke Hampshire | British | 51992990001 | ||||||||||
| HAWKSLEY, Andrew | Administrateur | c/o Celador Radio Kingsway SO14 1BN Southampton Romans Landing England | England | British | 244980330001 | |||||||||
| HOLMES, Ronald | Administrateur | Ivy House Mapledurwell RG25 2LG Basingstoke Hampshire | England | British | 26355080001 | |||||||||
| HUGHES, Lawrence Edward | Administrateur | Hilltops 3 Tadley Hill Tadley RG26 6PN Basingstoke Hampshire | British | 48194990001 | ||||||||||
| JOHNSON, Mark Alasdair Smith | Administrateur | Long Acre WC2E 9LG London 39 United Kingdom | United Kingdom | British | 79195840006 | |||||||||
| MANNING, Richard Denley John | Administrateur | 39 Ash Lane BA5 2LR Wells Somerset | United Kingdom | British | 77961690001 | |||||||||
| POTTERELL, Clive Ronald | Administrateur | Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue KT7 0HF Thames Ditton Surrey | England | British | 3182530002 | |||||||||
| REEVE, Nigel John | Administrateur | Links Farmhouse Ayleswade Lane Biddenden TN27 8LE Ashford Kent | British | 59213560003 | ||||||||||
| REYNOLDS, Susan Anne | Administrateur | 115 Pack Lane Kempshott RG22 5HH Basingstoke Hants | England | British | 109984070001 | |||||||||
| ROBERTSON, John | Administrateur | 8 The Chase Donnington RG14 3AQ Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 4907930002 | |||||||||
| ROCHE, John Philip | Administrateur | Wheathold Farm Ramsdell RG26 5SA Tadley Hampshire | British | 30692560001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur KESTREL FM LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celador Radio Limited | 31 janv. 2019 | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Celador Entertainment Ltd | 06 avr. 2016 | Kingsway St Marys Place SO14 1BN Southampton Roman Landing England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
KESTREL FM LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Créé le 14 févr. 2008 Livré le 22 févr. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti £5000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions All monies from time to time stanidng to the account pursuant to the rent deposit deed. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Rent deposit deed | Créé le 15 avr. 1998 Livré le 24 avr. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti The observance and performance of the obligations of the tenant in the deed and the obligations of the lessee to grosvenor (basingstoke) limited under the lease | |
Brèves mentions The company's equitable interest in:(1) the sum of £5,000 paid by the company to the landlord and which the landlord is obliged under the deed to pay into the account (as defined).(2) any other sums paid into that account by the tenant pursuant to the deed and any interest credited to that account. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 13 févr. 1998 Livré le 18 févr. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0