CHASE MIDLAND VCT LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | CHASE MIDLAND VCT LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03327019 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CHASE MIDLAND VCT LIMITED ?
Adresse du siège social | Pearl Assurance House 319 Ballards Lane N12 8LY London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CHASE MIDLAND VCT LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2009 |
Quels sont les derniers dépôts pour CHASE MIDLAND VCT LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 10 pages | 4.71 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 1 King's Arms Yard London EC2R 7AF England le 12 oct. 2010 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Timothy Jackson-Stops en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stephen Allkins en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 30 juin 2010 au 31 déc. 2010 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2009 | 11 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 1 King's Arms Yard London EC2R 7AF Uk le 01 mars 2010 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Henry Julian Aglionby Stanford le 01 mars 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen Philip Allkins le 01 mars 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2008 | 14 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pages | 287 | ||||||||||
legacy | 5 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 2 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 5 pages | 363a | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2007 | 14 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 2 pages | 288a | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2006 | 14 pages | AA |
Qui sont les dirigeants de CHASE MIDLAND VCT LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YU, Ka Wai | Secrétaire | Alexandra Road NW8 0DP London 19 | British | 132047010001 | ||||||
STANFORD, Henry Julian Aglionby | Administrateur | 319 Ballards Lane N12 8LY London Pearl Assurance House | England | British | Investor Director | 62204660001 | ||||
DAVIS, William Edward | Secrétaire | Beechcroft Wield Road GU34 5NH Medstead Alton Hampshire | British | 4522990001 | ||||||
GAIN, Jonathan Mark | Secrétaire | 9 Nash Place HP10 8ES Penn Buckinghamshire | British | 47508930005 | ||||||
MILLER, Jane | Secrétaire | 4 Poplar Rise Wappenham NN12 8RR Towcester Northamptonshire | British | 89678850001 | ||||||
TOOMEY, Mark Daniel | Secrétaire | 51b Shepperton Road N1 3DH London | British | 102854190001 | ||||||
TOOMEY, Mark Daniel | Secrétaire | 51b Shepperton Road N1 3DH London | British | 102854190001 | ||||||
PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire désigné | 41 Park Square LS1 2NS Leeds | 900013300001 | |||||||
ALLKINS, Stephen Philip | Administrateur | Badgers House Stourton CV36 5HG Shipston On Stour Warwickshire | England | British | Director | 56899810002 | ||||
JACKSON-STOPS, Timothy William Ashworth | Administrateur | Wood Burcote Court Wood Burcote NN12 6JP Towcester Northamptonshire | England | British | Company Director | 48006790001 | ||||
JERVIS, David John Paul | Administrateur | Goldicote Hall Goldicote CV37 7NY Stratford Upon Avon Warwickshire | British | Chartered Surveyor | 74037610001 | |||||
LAWTON-SMITH, Andrew Timothy | Administrateur | Highland House Church Road CV35 8JE Norton Lindsey Warwickshire | England | British | Solicitor | 157340990001 | ||||
REEVE, Patrick Harold | Administrateur | 36 Hillgate Place W8 7ST London | British | Banker | 23026910003 | |||||
PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED | Administrateur désigné | 41 Park Square LS1 2NS Leeds | 900013290001 |
CHASE MIDLAND VCT LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 05 déc. 2005 Livré le 23 déc. 2005 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the stockholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The f/h property k/a 29 victoria embankment nottingham t/n NT37346. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 05 déc. 2005 Livré le 23 déc. 2005 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the stockholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The f/h property k/a 29 victoria embankment nottingham t/n NT37346. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 15 mars 1999 Livré le 18 mars 1999 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the debenture and the loan stock deed defined therein | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 04 mars 1997 Livré le 08 mars 1997 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the loan stock deed (as defined) | |
Brèves mentions 85-87 high street henley-in -arden west midlands. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
CHASE MIDLAND VCT LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0