ASHTON PENNEY HOLDINGS PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéASHTON PENNEY HOLDINGS PLC
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 03330836
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ASHTON PENNEY HOLDINGS PLC ?

    • (7415) /

    Où se situe ASHTON PENNEY HOLDINGS PLC ?

    Adresse du siège social
    81-82 Gracechurch St
    London
    EC3V 0AU
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ASHTON PENNEY HOLDINGS PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BRANDED DRINKS PLC.26 sept. 200226 sept. 2002
    FIT STOP PLC14 juil. 199814 juil. 1998
    HUMAN SOLUTIONS GROUP PLC28 mai 199728 mai 1997
    GREENCHASE PLC10 mars 199710 mars 1997

    Quels sont les derniers comptes de ASHTON PENNEY HOLDINGS PLC ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour ASHTON PENNEY HOLDINGS PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    legacy

    6 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    18 pages363a

    Comptes consolidés établis au 30 juin 2007

    55 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages88(2)R

    legacy

    19 pages363s

    Comptes consolidés établis au 30 juin 2006

    37 pagesAA

    legacy

    1 pages88(2)R

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    9 pages363s

    legacy

    pages363(190)

    legacy

    1 pages225

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes consolidés établis au 31 mars 2005

    13 pagesAA

    legacy

    1 pages225

    legacy

    1 pages287

    legacy

    2 pages88(2)R

    Qui sont les dirigeants de ASHTON PENNEY HOLDINGS PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PAGE, Bruce Godwin
    Wells Close
    TN10 4NW Tonbridge
    32
    Kent
    Secrétaire
    Wells Close
    TN10 4NW Tonbridge
    32
    Kent
    British21298720001
    COLE, Graham
    37 First Street
    SW3 2LB London
    Administrateur
    37 First Street
    SW3 2LB London
    British105172590003
    KINNON, David Henderson
    3 Melford Avenue
    Giffnock
    G46 6NA Glasgow
    Administrateur
    3 Melford Avenue
    Giffnock
    G46 6NA Glasgow
    United KingdomBritish34969410003
    MAITLAND, Colin Neil
    Whitegate Cottage
    Tinkerpot Lane West Kingsdown
    TN15 6AD Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Whitegate Cottage
    Tinkerpot Lane West Kingsdown
    TN15 6AD Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish2760640001
    PAGE, Bruce Godwin
    Wells Close
    TN10 4NW Tonbridge
    32
    Kent
    Administrateur
    Wells Close
    TN10 4NW Tonbridge
    32
    Kent
    United KingdomBritish21298720001
    HADDOW, Renwick Robert
    52 Nansen Road
    SW11 5LW London
    Secrétaire
    52 Nansen Road
    SW11 5LW London
    British110779940001
    KITTOE, Stephen Maurice
    Southbourne Road
    BN22 8RE Eastbourne
    Lavender House, 255
    East Sussex
    Secrétaire
    Southbourne Road
    BN22 8RE Eastbourne
    Lavender House, 255
    East Sussex
    British692590012
    MACDONALD WATSON, Robert Andrew
    85 Elsenham Street
    Southfields
    SW18 5NX London
    Secrétaire
    85 Elsenham Street
    Southfields
    SW18 5NX London
    British27289930001
    ALPHA SECRETARIAL LIMITED
    2nd Floor
    83 Clerkenwell Road
    EC1R 5AR London
    Secrétaire désigné
    2nd Floor
    83 Clerkenwell Road
    EC1R 5AR London
    900004510001
    GUNNELL, Sally Jane Janet
    Perching Holt Edburton Road
    Fulking
    BN5 9LR Henfield
    West Sussex
    Administrateur
    Perching Holt Edburton Road
    Fulking
    BN5 9LR Henfield
    West Sussex
    British49063360001
    HADDOW, Renwick Robert
    52 Nansen Road
    SW11 5LW London
    Administrateur
    52 Nansen Road
    SW11 5LW London
    British110779940001
    HOLGATE, Robert John
    124 Clonmore Street
    Southfields
    SW18 5HB London
    Administrateur
    124 Clonmore Street
    Southfields
    SW18 5HB London
    British12245150002
    HOLGATE, Robert John
    124 Clonmore Street
    Southfields
    SW18 5HB London
    Administrateur
    124 Clonmore Street
    Southfields
    SW18 5HB London
    British12245150002
    LANSBERRY, Peter Robert
    38 Stirling Way
    RH13 5RP Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    38 Stirling Way
    RH13 5RP Horsham
    West Sussex
    British39660710001
    MACDONALD WATSON, Robert Andrew
    85 Elsenham Street
    Southfields
    SW18 5NX London
    Administrateur
    85 Elsenham Street
    Southfields
    SW18 5NX London
    British27289930001
    MCBRIDE WILSON, Melania
    212 Abbots Road
    WD5 0BP Abbots Langley
    Hertfordshire
    Administrateur
    212 Abbots Road
    WD5 0BP Abbots Langley
    Hertfordshire
    British83918300001
    MEIKLE, Andrew Mcewan
    Kemps Barn
    Queens Lane
    BN18 9JN Arundel
    West Sussex
    Administrateur
    Kemps Barn
    Queens Lane
    BN18 9JN Arundel
    West Sussex
    British63744340002
    MELLORS, Timothy Damon Viash
    8 Ordnance Hill
    St Johns Wood
    NW8 6PX London
    Administrateur
    8 Ordnance Hill
    St Johns Wood
    NW8 6PX London
    British62692910001
    O'CONNOR, Claire Antonette
    All Saints Church
    Foster Street
    CM17 9HR Harlow Common
    Essex
    Administrateur
    All Saints Church
    Foster Street
    CM17 9HR Harlow Common
    Essex
    GbrEnglish94138800001
    SCOTT, Jonathan Michael Douglas
    Darroch Harrow Road West
    RH4 3BA Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Darroch Harrow Road West
    RH4 3BA Dorking
    Surrey
    British8895890001
    SHAKESHAFT, Peter Robert
    Bregsells House
    Bregsells Drive
    RH5 4QY Horsham Road Beare Green
    Dorking Surrey
    Administrateur
    Bregsells House
    Bregsells Drive
    RH5 4QY Horsham Road Beare Green
    Dorking Surrey
    British12245160003
    SHARKEY, Jane Elizabeth
    8 Oakwood
    GU2 6YQ Guildford
    Surrey
    Administrateur
    8 Oakwood
    GU2 6YQ Guildford
    Surrey
    British52717150001
    SILVERMAN, Vivian Howard
    Lakes Lane
    HP9 2JZ Beaconsfield
    78
    Buckinghamshire
    England
    Administrateur
    Lakes Lane
    HP9 2JZ Beaconsfield
    78
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish107698170002
    WADDILOVE, Justin
    79 Trindles Road
    RH1 4JG South Nutfield
    Surrey
    Administrateur
    79 Trindles Road
    RH1 4JG South Nutfield
    Surrey
    British55036700002
    WHEELER, James Martin Handley
    Ashdown House
    Moorhall Drive Ninfield
    TN33 9JT Battle
    East Sussex
    Administrateur
    Ashdown House
    Moorhall Drive Ninfield
    TN33 9JT Battle
    East Sussex
    EnglandBritish85155680001
    WILKINS, Mark
    53b Alexandra Road
    SW19 7LB London
    Administrateur
    53b Alexandra Road
    SW19 7LB London
    British40284510004

    ASHTON PENNEY HOLDINGS PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 25 janv. 2002
    Livré le 07 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £20,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Renwick Robert Hadddow
    Transactions
    • 07 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 25 janv. 2002
    Livré le 07 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £20,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Andrew Mcewan Meikle
    Transactions
    • 07 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 juil. 2001
    Livré le 24 juil. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £34,166 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Renwick Robert Haddow
    Transactions
    • 24 juil. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 juil. 2001
    Livré le 24 juil. 2001
    En cours
    Montant garanti
    £32,957 due or to become due from the compqny to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Peter Lansberry
    Transactions
    • 24 juil. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 20 juil. 2001
    Livré le 24 juil. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £37,499 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Andrew Mcewan Meikle
    Transactions
    • 24 juil. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 15 nov. 2000
    Livré le 21 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £50,000 due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    A fixed and floating charge over all f/h and l/h property plant machinery goodwill uncalled capital book debts intellectual property rights and undertaking.
    Personnes ayant droit
    • Andrew Mcewan Meikle
    Transactions
    • 21 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 15 nov. 2000
    Livré le 21 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £50,000 due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    A fixed and floating charge over all f/h and l/h property plant machinery goodwill uncalled capital book debts intellectual property rights and undertaking.
    Personnes ayant droit
    • Renwick Robert Haddow
    Transactions
    • 21 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 04 août 2000
    Livré le 09 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a units 41-44 lower level the bargate shopping centre southampton hampshire. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 09 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 13 janv. 1999
    Livré le 19 janv. 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 19 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0