P I H HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | P I H HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03335609 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe P I H HOLDINGS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley Lancashire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de P I H HOLDINGS LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour P I H HOLDINGS LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 19 mars 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 02 avr. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 19 mars 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour P I H HOLDINGS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2024 | 18 pages | AA | ||
legacy | 48 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
Nomination de Mr Mauro Piasere en tant qu'administrateur le 11 août 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Frederic Castrec en tant que directeur le 14 août 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Bjarne Christopher Petersen Sanne en tant qu'administrateur le 20 mai 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2023 | 18 pages | AA | ||
legacy | 44 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 2 pages | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 mars 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Duncan Holland en tant que secrétaire le 31 juil. 2024 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de Philip Nicholas Lanigan en tant que secrétaire le 31 juil. 2024 | 1 pages | TM02 | ||
Nomination de Mr Duncan Holland en tant qu'administrateur le 31 juil. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Philip Nicholas Lanigan en tant que directeur le 31 juil. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2022 | 21 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 mars 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||
Cessation de la nomination de Adam Rhys Wynne Hughes en tant que directeur le 16 juin 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Bruno Claudio Oliveira Teixeira en tant que directeur le 23 mai 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 26 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 mars 2023 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate Burnley Lancashire BB11 5SW | 1 pages | AD04 | ||
Qui sont les dirigeants de P I H HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLLAND, Duncan | Secrétaire | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley Lancashire | 325687740001 | |||||||
| HOLLAND, Duncan | Administrateur | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley Lancashire | Scotland | British | 325676520001 | |||||
| MACKAY, James Innes | Administrateur | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley Lancashire | Scotland | British | 108844510001 | |||||
| MCSHANE, Paul Joseph | Administrateur | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley The Pipeline Centre England England | England | Irish | 218498550002 | |||||
| PIASERE, Mauro | Administrateur | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley Lancashire | Italy | Italian | 339904950001 | |||||
| SANNE, Bjarne Christopher Petersen | Administrateur | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley Lancashire | Norway | Norwegian | 336627130001 | |||||
| COSTELLO, Steven John | Secrétaire | 3 Europa View Sheffield Business Park S91XH Sheffield Stanley U.K. Holding Ltd. England England | 186112950001 | |||||||
| COSTELLO, Steven John | Secrétaire | Bath Road SL1 4DX Slough 270 Berkshire United Kingdom | 186116830001 | |||||||
| HAYHURST, Fred | Secrétaire | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley Lancashire | 159802310001 | |||||||
| LANIGAN, Philip Nicholas | Secrétaire | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley Lancashire | 299618510001 | |||||||
| ROBINSON, Paul James | Secrétaire | 17 Moss Lane M33 6QD Sale Cheshire | British | 61464420001 | ||||||
| E P S SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 50 Stratton Street W1X 6NX London | 900004930001 | |||||||
| ALLEN, Caroline | Administrateur | Rosendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley Farrington Road England England | United Kingdom | British | 241814400001 | |||||
| BOND, Philip Michael | Administrateur | Brinklow Way HG2 9JW Harrogate 5 North Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 70384280002 | |||||
| CAREY, Malcolm Timothy | Administrateur | Indian Wells Drive 77069 Houston 14111 Texas United States | Usa | American | 135768760001 | |||||
| CASTREC, Frederic | Administrateur | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley Lancashire | France | French | 299627840001 | |||||
| COGZELL, Matthew James | Administrateur | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley Lancashire | England | British | 157755080001 | |||||
| COWLEY, John Mitchell | Administrateur | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley Lancashire | England | British | 153045530001 | |||||
| DAVISON, Thomas Patrick | Administrateur | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley Lancashire | England | British | 178471340001 | |||||
| EVANS, Calvin Paul | Administrateur | 6622 Preston Trail Houston Texas 77069 Usa | Usa | American | 26160230003 | |||||
| LAAKE, Gregory Duane | Administrateur | 9410 Brentwood Lake Circle Spring Texas 77379 Usa | United States | United States | 104309910001 | |||||
| LANIGAN, Philip Nicholas | Administrateur | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley Lancashire | England | British | 42734310002 | |||||
| MOKLAK, Paul Daniel | Administrateur | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley The Pipeline Centre England England | United Kingdom | British | 217770510001 | |||||
| RHODES, Fiona Elizabeth | Administrateur | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley The Pipeline Centre England England | United Kingdom | British | 200869110001 | |||||
| ROBINSON, Paul James | Administrateur | 17 Moss Lane M33 6QD Sale Cheshire | United Kingdom | British | 61464420001 | |||||
| SMILEY, Mark Richard | Administrateur | Europa Court Sheffield Business Park S9 1XE Sheffield 3 England | United Kingdom | British | 194271890001 | |||||
| SMITH, Michael Peter | Administrateur | Closes Hall Stump Cross Lane, Bolton By Bowland BB7 4LX Clitheroe Lancashire | British | 65426730001 | ||||||
| SOOD, Amit Kumar | Administrateur | Europa Court Sheffield Business Park S9 1XE Sheffield 3 England | England | British | 153181250001 | |||||
| STUBBS, Susan | Administrateur | Europa Court Sheffield Business Park S9 1XE Sheffield 3 England | United Kingdom | British | 169624400001 | |||||
| TEIXEIRA, Bruno Claudio Oliveira | Administrateur | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley The Pipeline Centre England England | Portugal | Portuguese | 290495760001 | |||||
| WENDELL BIGGERS, Mark | Administrateur | 405 Golf Crest Lane Austin Travis Texas Usa | American | 80999660001 | ||||||
| WOOD, Delma Dale | Administrateur | 68 Champions Court Place 77069 Houston Texas | American | 58641180004 | ||||||
| WYNNE HUGHES, Adam Rhys | Administrateur | Farrington Road BB11 5SW Burnley The Pipeline Centre England | England | British | 113722460001 | |||||
| MIKJON LIMITED | Administrateur désigné | 50 Stratton Street W1X 5FL London | 900004920001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur P I H HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipeline Technique Limited | 19 août 2022 | Midmill Business Park Kintore AB51 0QP Inverurie Site G Tofthills Avenue Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Bandhart | 06 avr. 2016 | Bath Road SL1 3YD Slough 210 Berkshire United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0