CASTLETON TECHNOLOGY LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CASTLETON TECHNOLOGY LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03336134 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CASTLETON TECHNOLOGY LIMITED ?
| Adresse du siège social | 9 King Street EC2V 8EA London United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CASTLETON TECHNOLOGY LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CASTLETON TECHNOLOGY LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 18 mars 2027 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 01 avr. 2027 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 18 mars 2026 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour CASTLETON TECHNOLOGY LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 18 mars 2026 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Roman Telerman en tant que directeur le 10 nov. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2024 | 20 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 18 mars 2025 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré 9 King Street London EC2V 8EA | 1 pages | AD04 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2023 | 17 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 18 mars 2024 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2022 | 18 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 19 mars 2023 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 20 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 19 mars 2022 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 24 pages | AA | ||||||||||
État du capital au 08 déc. 2021
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 19 mars 2021 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 mars 2020 | 61 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de The Walbrook Building 25 Walbrook London EC4N 8AF United Kingdom à 9 King Street London EC2V 8EA le 17 sept. 2020 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Période comptable actuelle raccourcie du 31 mars 2021 au 31 déc. 2020 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Certificat de réimmatriculation de société anonyme à responsabilité limitée | 1 pages | CERT10 | ||||||||||
Réenregistrement des statuts | 31 pages | MAR | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Re-enregistrement d'une société publique en société à responsabilité limitée privée | 2 pages | RR02 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 23 juin 2020
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de CASTLETON TECHNOLOGY LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSIGN, John Adler | Administrateur | King Street EC2V 8EA London 9 United Kingdom | United States | American | 270872360001 | |||||
| GHILANI, Patrick Joseph, Mr. | Administrateur | King Street EC2V 8EA London 9 United Kingdom | United States | American | 238655330001 | |||||
| BRACHER, Alan Richard | Secrétaire | 53 Foley Road KT10 0LU Claygate Surrey | British | 36451680001 | ||||||
| GRIFFITHS, Helen | Secrétaire | 25 Walbrook EC4N 8AF London The Walbrook Building United Kingdom | 246083450001 | |||||||
| HARROLD, Alan Henry | Secrétaire | Cherry Tree House The Drive SL8 5RE Bourne End Buckinghamshire | British | 88772110001 | ||||||
| HAYES, Peter Andrew | Secrétaire | Cambridge Business Park, Cowley Road CB4 0WZ Cambridge Newton House United Kingdom | 162761970001 | |||||||
| HAYES, Peter Andrew | Secrétaire | 2 Somersby Crescent SL6 3YY Maidenhead Berkshire | British | 66610550002 | ||||||
| HEUVEL, Christopher Edward Francis Van Den | Secrétaire | 7 Hawkes Leap GU20 6JL Windlesham Surrey | British | 14296970001 | ||||||
| MYHILL, Paul Harvey | Secrétaire | Fetter Lane EC4A 1BN London 100 United Kingdom | 175306790001 | |||||||
| O'RORKE, Nicholas | Secrétaire | Kirtlington Business Centre, Slade Farm Kirtlington OX5 3JA Kidlington Building B - Office 10 Oxfordshire United Kingdom | 149308000001 | |||||||
| SHOWKER, Karenjeet Kaur | Secrétaire | 25 Walbrook EC4N 8AF London The Walbrook Building United Kingdom | 260899060001 | |||||||
| YOUNG, Jenny Louise | Secrétaire | Fetter Lane EC4A 1BN London 100 United Kingdom | 200143680001 | |||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire désigné | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||
| BALAAM, Martin Anthony | Administrateur | The Laurels Coole Lane CW5 8AY Nantwich Cheshire | United Kingdom | British | 82233550001 | |||||
| BELL, Carolyn | Administrateur | Fetter Lane EC4A 1BN London 100 United Kingdom | England | British | 197027980001 | |||||
| BROWN, Ian Christopher | Administrateur | Fox Hollow Westwood Road GU20 6LX Windlesham Surrey | England | British | 75493580001 | |||||
| CARRINGTON, John Christopher | Administrateur | 1 Anchor Brewhouse 50 Shad Thames SE1 2LY London | United Kingdom | British | 79087670001 | |||||
| CHAPMAN, Haywood Trefor | Administrateur | 25 Walbrook EC4N 8AF London The Walbrook Building United Kingdom | United Kingdom | British | 193406100001 | |||||
| COPPIN, Alan Charles | Administrateur | Briar Hedge The Drive SL8 5RE Bourne End Buckinghamshire | England | British | 82808900001 | |||||
| COVE, Graham Lawrence | Administrateur | 2 White House Close SG14 3TW Watton At Stone Hertfordshire | England | British | 45340010002 | |||||
| CUSHING, Robert Sefton | Administrateur | 66 Columbia Place Fornham Street S2 4AR Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | 117325300001 | |||||
| DICKINSON, Dean Robert | Administrateur | 25 Walbrook EC4N 8AF London The Walbrook Building United Kingdom | England | British | 286283450001 | |||||
| DREDGE, Spencer Neal | Administrateur | Cambridge Business Park, Cowley Road CB4 0WZ Cambridge Newton House United Kingdom | United Kingdom | British | 138270950001 | |||||
| GIBSON, Paul David | Administrateur | 25 Walbrook EC4N 8AF London The Walbrook Building United Kingdom | United Kingdom | British | 192439290001 | |||||
| HALLETT, Peter John | Administrateur | Kirtlington Business Centre, Slade Farm Kirtlington OX5 3JA Kidlington Building B - Office 10 Oxfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 20621770002 | |||||
| HALLETT, Peter John | Administrateur | Kirtlington Business Centre, Slade Farm Kirtlington OX5 3JA Kidlington Building B - Office 10 Oxfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 20621770002 | |||||
| HALLETT, Peter John | Administrateur | Cambridge Business Park, Cowley Road CB4 0WZ Cambridge Newton House United Kingdom | United Kingdom | British | 20621770002 | |||||
| HARROLD, Alan Henry | Administrateur | Cherry Tree House The Drive SL8 5RE Bourne End Buckinghamshire | England | British | 88772110001 | |||||
| KELLY, Philip Edward | Administrateur | 25 Walbrook EC4N 8AF London The Walbrook Building United Kingdom | England | British | 3118650001 | |||||
| PATHAK, Ashvin Rao | Administrateur | Agden Hall WA13 0TZ Agden Cheshire | England | British | 150476460001 | |||||
| PAYNE, David Graham | Administrateur | Mill House BH21 5LZ Wimborne St Giles Dorset | United Kingdom | British | 77466830001 | |||||
| PERKS, Timothy Howard | Administrateur | Bowdown Farmhouse Burys Bank Road Greenham RG19 8DA Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 100207880001 | |||||
| RAMSAY, Richard Alexander Mcgregor | Administrateur | Cambridge Business Park, Cowley Road CB4 0WZ Cambridge Newton House United Kingdom | England | British | 118045470001 | |||||
| ROBERTS, Andrew Christopher | Administrateur | 31 Durlston Road KT2 5RR Kingston Upon Thames Surrey | British | 71656420001 | ||||||
| SANGHERA, Davinder Kaur | Administrateur | Fetter Lane EC4A 1BN London 100 United Kingdom | England | British | 169814200001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CASTLETON TECHNOLOGY LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mri Software Limited | 04 juin 2020 | King Street EC2V 8EA London 9 England | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
| |||||||
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour CASTLETON TECHNOLOGY LIMITED ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 02 oct. 2017 | 04 juin 2020 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
| 20 juil. 2017 | 02 oct. 2017 | La société n'a pas encore achevé les mesures raisonnables pour déterminer si une personne est une personne enregistrable ou une entité juridique pertinente enregistrable en relation avec la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0