WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED

WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03337345
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED ?

    • Autres installations en construction (43290) / Construction

    Où se situe WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Paul Scott en tant que directeur le 22 janv. 2015

    2 pagesTM01

    Nomination de Mr John William Young Strachan Samuel en tant qu'administrateur le 22 janv. 2015

    3 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2014

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 janv. 2015

    État du capital au 08 janv. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 janv. 2014

    État du capital au 06 janv. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2012

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2011

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2010

    5 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2009

    5 pagesAA

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2008

    5 pagesAA

    legacy

    1 pages353

    Qui sont les dirigeants de WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RENEW NOMINEES LIMITED
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    41291250014
    SAMUEL, John William Young Strachan
    Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA Leeds
    Yew Trees
    West Yorkshire
    England
    Administrateur
    Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA Leeds
    Yew Trees
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish3909060002
    RENEW CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Administrateur
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    91993060004
    BARKER, Roger Winston
    24 Burn Bridge Oval
    HG3 1LP Harrogate
    North Yorkshire
    Secrétaire
    24 Burn Bridge Oval
    HG3 1LP Harrogate
    North Yorkshire
    British59419910001
    HILL, David Robert
    Low House
    Lowes Water
    CA13 9UX Cockermouth
    Secrétaire
    Low House
    Lowes Water
    CA13 9UX Cockermouth
    British18429260002
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secrétaire désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BARKER, Roger Winston
    24 Burn Bridge Oval
    HG3 1LP Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    24 Burn Bridge Oval
    HG3 1LP Harrogate
    North Yorkshire
    British59419910001
    DAWES, John Brian
    Holly Lodge
    Arkleby
    CA7 2BT Wigton
    Cumbria
    Administrateur
    Holly Lodge
    Arkleby
    CA7 2BT Wigton
    Cumbria
    EnglandBritish10253750001
    FEAST, Roger
    43 Merchant Court
    61 Wapping Wall
    E1W 3SJ London
    Administrateur
    43 Merchant Court
    61 Wapping Wall
    E1W 3SJ London
    British66800550001
    HILL, David Robert
    Low House
    Lowes Water
    CA13 9UX Cockermouth
    Administrateur
    Low House
    Lowes Water
    CA13 9UX Cockermouth
    British18429260002
    LITTLEHALES, Richard
    Aisling Cottage
    Back Church Lane
    LS16 8DW Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Aisling Cottage
    Back Church Lane
    LS16 8DW Leeds
    West Yorkshire
    British57288230002
    MCARTHUR, Alexander Nigel
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    Administrateur
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    British1571200002
    PEARSON, Valerie
    Phoenix House
    Hawthorn Park
    LS14 1PQ Leeds
    Administrateur
    Phoenix House
    Hawthorn Park
    LS14 1PQ Leeds
    British82999480006
    SCOTT, Paul
    The Burroughs
    Papcastle
    CA13 0JN Cockermouth
    Cumbria
    Administrateur
    The Burroughs
    Papcastle
    CA13 0JN Cockermouth
    Cumbria
    EnglandBritish63708460003
    UNDERWOOD, Philip John
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    Administrateur
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    British59420330009
    WAREING, Anthony James
    4 Craig Road
    CA14 3JX Workington
    Cumbria
    Administrateur
    4 Craig Road
    CA14 3JX Workington
    Cumbria
    United KingdomBritish17422620001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Administrateur désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 05 janv. 2005
    Livré le 20 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 déc. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 16 avr. 1999
    Livré le 20 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 déc. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Créé le 09 mai 1997
    Livré le 14 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0