WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03337345 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED ?
| Adresse du siège social | Yew Trees Main Street North LS25 3AA Aberford West Yorkshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2014 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Scott en tant que directeur le 22 janv. 2015 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr John William Young Strachan Samuel en tant qu'administrateur le 22 janv. 2015 | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2014 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Satisfaction de la charge 3 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2013 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2012 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2011 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2010 | 5 pages | AA | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2009 | 5 pages | AA | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré | 1 pages | AD03 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée | 1 pages | AD02 | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2008 | 5 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 353 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENEW NOMINEES LIMITED | Secrétaire | Yew Trees Main Street North LS25 3AA Aberford West Yorkshire | 41291250014 | |||||||
| SAMUEL, John William Young Strachan | Administrateur | Main Street North Aberford LS25 3AA Leeds Yew Trees West Yorkshire England | England | British | 3909060002 | |||||
| RENEW CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Administrateur | Yew Trees Main Street North LS25 3AA Aberford West Yorkshire | 91993060004 | |||||||
| BARKER, Roger Winston | Secrétaire | 24 Burn Bridge Oval HG3 1LP Harrogate North Yorkshire | British | 59419910001 | ||||||
| HILL, David Robert | Secrétaire | Low House Lowes Water CA13 9UX Cockermouth | British | 18429260002 | ||||||
| WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||
| BARKER, Roger Winston | Administrateur | 24 Burn Bridge Oval HG3 1LP Harrogate North Yorkshire | British | 59419910001 | ||||||
| DAWES, John Brian | Administrateur | Holly Lodge Arkleby CA7 2BT Wigton Cumbria | England | British | 10253750001 | |||||
| FEAST, Roger | Administrateur | 43 Merchant Court 61 Wapping Wall E1W 3SJ London | British | 66800550001 | ||||||
| HILL, David Robert | Administrateur | Low House Lowes Water CA13 9UX Cockermouth | British | 18429260002 | ||||||
| LITTLEHALES, Richard | Administrateur | Aisling Cottage Back Church Lane LS16 8DW Leeds West Yorkshire | British | 57288230002 | ||||||
| MCARTHUR, Alexander Nigel | Administrateur | 39 Cornhill EC3V 3NU London | British | 1571200002 | ||||||
| PEARSON, Valerie | Administrateur | Phoenix House Hawthorn Park LS14 1PQ Leeds | British | 82999480006 | ||||||
| SCOTT, Paul | Administrateur | The Burroughs Papcastle CA13 0JN Cockermouth Cumbria | England | British | 63708460003 | |||||
| UNDERWOOD, Philip John | Administrateur | 39 Cornhill EC3V 3NU London | British | 59420330009 | ||||||
| WAREING, Anthony James | Administrateur | 4 Craig Road CA14 3JX Workington Cumbria | United Kingdom | British | 17422620001 | |||||
| WATERLOW NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 05 janv. 2005 Livré le 20 janv. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 16 avr. 1999 Livré le 20 avr. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture containing fixed and floating charges | Créé le 09 mai 1997 Livré le 14 mai 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0