SEASIDE SU1 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSEASIDE SU1 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03338717
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SEASIDE SU1 LIMITED ?

    • Autres activités sportives (93199) / Activités artistiques, de loisirs et de divertissement

    Où se situe SEASIDE SU1 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Bramall Lane
    Sheffield
    S2 4SU South Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SEASIDE SU1 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SHEFFIELD UNITED ACADEMY LIMITED06 févr. 200206 févr. 2002
    SHEFFIELD UNITED (ABBEYDALE GRANGE) LIMITED02 sept. 199702 sept. 1997
    BROOMCO (1244) LIMITED24 mars 199724 mars 1997

    Quels sont les derniers comptes de SEASIDE SU1 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour SEASIDE SU1 LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour SEASIDE SU1 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2013

    6 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Julian Winter en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed sheffield united academy LIMITED\certificate issued on 06/09/13
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name06 sept. 2013

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Nomination de Esplanade Director Limited en tant qu'administrateur

    2 pagesAP02

    Nomination de Mr Julian Winter en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 mars 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 avr. 2013

    État du capital au 24 avr. 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2012

    6 pagesAA

    Nomination de Mr Craig Burns en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Julian Winter en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 mars 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2011

    6 pagesAA

    Cessation de la nomination de David Harrop en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Craig Burns en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de David Harrop en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Julian Winter en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Charles Mccabe le 14 juil. 2011

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Trevor Birch en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Charles Mccabe le 19 nov. 2010

    3 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2010

    6 pagesAA

    legacy

    4 pagesMG02

    Qui sont les dirigeants de SEASIDE SU1 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BURNS, Craig
    Bramall Lane
    Sheffield
    S2 4SU South Yorkshire
    Secrétaire
    Bramall Lane
    Sheffield
    S2 4SU South Yorkshire
    167993580001
    BURNS, Craig
    Bramall Lane
    Sheffield
    S2 4SU South Yorkshire
    Administrateur
    Bramall Lane
    Sheffield
    S2 4SU South Yorkshire
    EnglandBritish167991320001
    DUDLEY, David Michael
    21 Weston View
    Crookes
    S10 5BZ Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    21 Weston View
    Crookes
    S10 5BZ Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish125782620001
    MCCABE, Simon Charles
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Administrateur
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritish154915110001
    ESPLANADE DIRECTOR LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    England
    Administrateur
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement01633267
    180712410001
    CAPPER, Simon
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Secrétaire
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    British118147580002
    FENOUGHTY, Mark Thomas
    108 Totley Brook Road
    S17 3QU Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire
    108 Totley Brook Road
    S17 3QU Sheffield
    South Yorkshire
    British91397360003
    HARROP, David
    Bramall Lane
    Sheffield
    S2 4SU South Yorkshire
    Secrétaire
    Bramall Lane
    Sheffield
    S2 4SU South Yorkshire
    153053780001
    MANNING, Michael Atkinson
    67 Postern Close
    YO23 1JF York
    North Yorkshire
    Secrétaire
    67 Postern Close
    YO23 1JF York
    North Yorkshire
    British20393860001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001
    ARMSTRONG, Gary John, Dr
    9 Clarkson Row
    Mornington Terrace
    NW1 7RA London
    Administrateur
    9 Clarkson Row
    Mornington Terrace
    NW1 7RA London
    United Kingdom British 81787340001
    BAMFORD, Alan Maxwell
    Stonecroft 53 Vicarage Lane
    Dore
    S17 3GX Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    Stonecroft 53 Vicarage Lane
    Dore
    S17 3GX Sheffield
    South Yorkshire
    British11424620001
    BIRCH, Trevor
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    Bramall Lane
    South Yorkshire
    Administrateur
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    Bramall Lane
    South Yorkshire
    UkBritish160667800001
    CAPPER, Simon
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Administrateur
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    United KingdomBritish118147580002
    DOOLEY, Derek
    83 Norton Park View
    S8 8GU Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    83 Norton Park View
    S8 8GU Sheffield
    South Yorkshire
    British34642040001
    FENOUGHTY, Mark Thomas
    108 Totley Brook Road
    S17 3QU Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    108 Totley Brook Road
    S17 3QU Sheffield
    South Yorkshire
    British91397360003
    GREEN, Charles Alexander
    Oak Tree Farm
    Blankney Barff
    LN4 3BJ Wetheringham
    Lincolnshire
    Administrateur
    Oak Tree Farm
    Blankney Barff
    LN4 3BJ Wetheringham
    Lincolnshire
    British75952680002
    HARROP, David Anthony
    Bramall Lane
    Sheffield
    S2 4SU South Yorkshire
    Administrateur
    Bramall Lane
    Sheffield
    S2 4SU South Yorkshire
    EnglandBritish160187290001
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    MCDONALD, Anthony Michael
    Glenwood Cottage 25 Andrew Lane
    High Lane
    SK6 8HX Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    Glenwood Cottage 25 Andrew Lane
    High Lane
    SK6 8HX Stockport
    Cheshire
    British51141710003
    ROBINSON, Terence James
    The Long Barn
    Hollymount Lane, Greenmount
    BL8 4HP Bury
    Lancashire
    Administrateur
    The Long Barn
    Hollymount Lane, Greenmount
    BL8 4HP Bury
    Lancashire
    EnglandBritish107314140001
    ROCKETT, Jason
    Bramall Lane
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    Administrateur
    Bramall Lane
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    United KingdomBritish111427410006
    SLINN, Stephen
    17 Owlthorpe Drive
    Mosborough
    S20 5JU Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    17 Owlthorpe Drive
    Mosborough
    S20 5JU Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish72785350001
    THURMAN, John Lythall
    Rosebank 8 Moor Lane
    Kirk Langley
    DE6 4LQ Ashbourne
    Derbyshire
    Administrateur
    Rosebank 8 Moor Lane
    Kirk Langley
    DE6 4LQ Ashbourne
    Derbyshire
    British41580370003
    TOWNSEND, Ian
    Homelands
    Upper Dunsforth
    YO26 9RU Great Ouseburn York
    Administrateur
    Homelands
    Upper Dunsforth
    YO26 9RU Great Ouseburn York
    United KingdomBritish26617400002
    WARNOCK, William John
    33 Hallwood Road
    Burncross
    S35 1TR Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    33 Hallwood Road
    Burncross
    S35 1TR Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish82114730001
    WINTER, Julian
    Bramall Lane
    Sheffield
    S2 4SU South Yorkshire
    Administrateur
    Bramall Lane
    Sheffield
    S2 4SU South Yorkshire
    EnglandBritish163637880001
    WINTER, Julian
    Bramall Lane
    Sheffield
    S2 4SU South Yorkshire
    Administrateur
    Bramall Lane
    Sheffield
    S2 4SU South Yorkshire
    EnglandBritish163637880001
    WOOD, Peter Philip
    Flat 45 Whinfell Court
    Eccleshall Road
    S11 9QA Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    Flat 45 Whinfell Court
    Eccleshall Road
    S11 9QA Sheffield
    South Yorkshire
    British59507480001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003800001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001

    SEASIDE SU1 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 09 oct. 2002
    Livré le 11 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/Hold land on the east side of shirecliffe rd,sheffield; SYK168119.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 17 sept. 2002
    Livré le 21 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0