RIVERSIDE CROYDON LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRIVERSIDE CROYDON LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03340555
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RIVERSIDE CROYDON LIMITED ?

    • Installations de fitness (93130) / Activités artistiques, de loisirs et de divertissement

    Où se situe RIVERSIDE CROYDON LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o MAZARS LLP
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de RIVERSIDE CROYDON LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour RIVERSIDE CROYDON LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour RIVERSIDE CROYDON LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    4 pages4.71

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de The Pinnacle 170 Midsummer Boulevard Milton Keynes MK9 1FE England

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de , Active House 21 North Fourth Street, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK9 1HL le 09 oct. 2013

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 19 sept. 2013

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 août 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Nomination de Mr Paul Antony Woolf en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Norman Field en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Nomination de Matthew Graham Merrick en tant qu'administrateur

    4 pagesAP01
    Annotations
    DateAnnotation
    27 sept. 2011The form is a duplicate of AP01 registered on 12/09/2011

    Nomination de James Archibald en tant que secrétaire

    4 pagesAP03
    Annotations
    DateAnnotation
    27 sept. 2011The form is a duplicate of AP03 registered on 12/09/2011

    Nomination de James Archibald en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Nomination de Matthew Graham Merrick en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    15 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de RIVERSIDE CROYDON LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ARCHIBALD, James
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Secrétaire
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    British162966660001
    BUCKNALL, Matthew William
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Administrateur
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    United KingdomBritish162066820001
    MERRICK, Matthew Graham
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Administrateur
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    United KingdomBritish162110530001
    WOOLF, Paul Antony
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Administrateur
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    United KingdomBritish160679880001
    ASHWORTH, Paul Richard
    118 St Anns Hill
    Wandsworth
    SW18 2RR London
    Secrétaire
    118 St Anns Hill
    Wandsworth
    SW18 2RR London
    British46410260001
    BALL, Michael David
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    Secrétaire
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    British58961410002
    DREGENT, Patricia Ann Taylor
    17 Spinney Close
    RM13 8LR Rainham
    Essex
    Secrétaire
    17 Spinney Close
    RM13 8LR Rainham
    Essex
    British6369240002
    PENRICE, Victoria Margaret
    Trebartha
    51a Frances Road
    SL4 3AQ Windsor
    Berkshire
    Secrétaire
    Trebartha
    51a Frances Road
    SL4 3AQ Windsor
    Berkshire
    British90459300001
    SCALES, Eugene Patrick
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Secrétaire
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Other124193970001
    SHILLINGLAW, Gary Preston
    Wynsdale
    9 Monkshanger
    GU9 8BU Farnham
    Surrey
    Secrétaire
    Wynsdale
    9 Monkshanger
    GU9 8BU Farnham
    Surrey
    British66825690001
    TYSON, Roger Thomas Virley
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    Secrétaire
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    British113777700001
    WHEELER, Jonathan
    19 Glebe Place
    Chelsea
    SW3 5LD London
    Secrétaire
    19 Glebe Place
    Chelsea
    SW3 5LD London
    British19812400001
    WONG, Wai Chung
    Flat 3 Rowsley Lodge
    72a Lady Margaret Road
    N19 5EL London
    Secrétaire
    Flat 3 Rowsley Lodge
    72a Lady Margaret Road
    N19 5EL London
    British123616460002
    ANDERSON, Ruth
    46 Upper Grotto Road
    Strawberry Hill
    TW1 4NF Twickenham
    Administrateur
    46 Upper Grotto Road
    Strawberry Hill
    TW1 4NF Twickenham
    British66859670001
    ASHWORTH, Paul Richard
    118 St Anns Hill
    Wandsworth
    SW18 2RR London
    Administrateur
    118 St Anns Hill
    Wandsworth
    SW18 2RR London
    EnglandBritish46410260001
    BALL, Michael David
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    Administrateur
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    United KingdomBritish58961410002
    BEADLE, Mark Ronald Sydney
    14 Fen Meadow
    TN15 9HT Ightham
    Kent
    Administrateur
    14 Fen Meadow
    TN15 9HT Ightham
    Kent
    British80515670001
    CHARLTON, Stephen Paul
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    Administrateur
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    EnglandBritish96743210001
    CLELAND, Jonathan Bradley
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish146698270001
    COLES, Charles Graham
    Willow Cottage
    Chalfont Lane
    WD3 5PP Chorleywood
    Hertfordshire
    Administrateur
    Willow Cottage
    Chalfont Lane
    WD3 5PP Chorleywood
    Hertfordshire
    EnglandBritish12337010002
    CREED, Stuart John
    Jade House The Avenue
    Claverton Down
    BA2 7AX Bath
    Administrateur
    Jade House The Avenue
    Claverton Down
    BA2 7AX Bath
    United KingdomBritish3716600001
    DHODY, Jog
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish104269910002
    FIELD, Norman Mark
    North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House 21
    Buckinghamshire
    Administrateur
    North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House 21
    Buckinghamshire
    United KingdomSouth African161860310001
    FOSTER, Michael Raymond
    4 Church Close
    Westoning
    MK45 5DH Bedford
    Administrateur
    4 Church Close
    Westoning
    MK45 5DH Bedford
    EnglandBritish53280440001
    GILLIS, Neil Duncan
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    Administrateur
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    EnglandBritish69204500003
    GUYER, Paul John
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    Administrateur
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    British100971720002
    HALL, Andrew James
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish30306840002
    HENCHOZ, Patrick
    Huntington Court
    Huntington Lane
    HR4 7RA Hereford
    Herefordshire
    Administrateur
    Huntington Court
    Huntington Lane
    HR4 7RA Hereford
    Herefordshire
    United KingdomSwiss93431850001
    JOHNSON, Mark Christopher
    Little Stream
    Sunning Hill Road
    SL5 9JZ Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Little Stream
    Sunning Hill Road
    SL5 9JZ Ascot
    Berkshire
    EnglandBritish48443030001
    KELLY, Maurice William
    Spinney Cottage Wing Road
    Mentmore
    LU7 0QG Leighton Buzzard
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Spinney Cottage Wing Road
    Mentmore
    LU7 0QG Leighton Buzzard
    Buckinghamshire
    British89366130001
    LEATHERBARROW, David Jon
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritish135618280002
    MCCOLLUM, Kevin Boyd
    Waterton Stables
    Ampney Crucis
    GL7 5RX Cirencester
    Gloucestershire
    Administrateur
    Waterton Stables
    Ampney Crucis
    GL7 5RX Cirencester
    Gloucestershire
    EnglandBritish121972580001
    MCGUIGAN, Marc Edward
    Avadi
    Chapel Lane
    GL20 7ER Tewkesbury
    Gloucester
    Administrateur
    Avadi
    Chapel Lane
    GL20 7ER Tewkesbury
    Gloucester
    EnglandBritish93677590002
    MCRORY, Penelope Ann
    13 Queen Street
    KT16 8BS Chertsey
    Surrey
    Administrateur
    13 Queen Street
    KT16 8BS Chertsey
    Surrey
    British52251860001
    MICHAELS, Terry
    The Vines Hardwick Close
    KT22 0HZ Oxshott
    Surrey
    Administrateur
    The Vines Hardwick Close
    KT22 0HZ Oxshott
    Surrey
    New Zealand72228080001

    RIVERSIDE CROYDON LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed and floating security document
    Créé le 18 juin 2009
    Livré le 26 juin 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any other chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transactions
    • 26 juin 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Group debenture
    Créé le 08 févr. 2006
    Livré le 18 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for the Secured Parties)(in Such Capacity the "Security Agent")
    Transactions
    • 18 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 27 janv. 2004
    Livré le 07 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrower, the charging group and/or any other member of the group to the note finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Electra Partners Europe Limited as Noteholders' Agent and Noteholders' Security Trustee Andnoteholders Security Trust (The "Noteholders' Security Trustee")
    Transactions
    • 07 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 27 janv. 2004
    Livré le 03 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrower, the charging group and/or any member of the group (meaning the borrower or its subsidiaries from time to time) to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Dukes meadow chiswick hounslow t/no NGL147830; imperial way croydon surrey t/no SGL454522; llandarcy neath swansea t/no CYM43829 and WA953690 for details of further properties charged please refer to form 395 unscheduled property, rental income, fixed or other plant and machinery, insurances, licences on land, reights as tenant, book and other debts, bank accounts, charged securities, uncalled capital , goodwill, intellectual property, licences, credit agreements, contracts floating charge undertaking property rights and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 03 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    RIVERSIDE CROYDON LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    24 sept. 2013Commencement of winding up
    20 nov. 2014Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Scott Christian Bevan
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    practitioner
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Simon David Chandler
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    practitioner
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0