THE NEIGHBOURHOOD INITIATIVES FOUNDATION

THE NEIGHBOURHOOD INITIATIVES FOUNDATION

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE NEIGHBOURHOOD INITIATIVES FOUNDATION
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited'
    Numéro de société 03344183
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE NEIGHBOURHOOD INITIATIVES FOUNDATION ?

    • (9305) /

    Où se situe THE NEIGHBOURHOOD INITIATIVES FOUNDATION ?

    Adresse du siège social
    BEGBIES TRAYNOR
    The Old Barn Caverswall Park Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent
    Staffordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de THE NEIGHBOURHOOD INITIATIVES FOUNDATION ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour THE NEIGHBOURHOOD INITIATIVES FOUNDATION ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    3 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 16 sept. 2012

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 16 mars 2012

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 16 sept. 2011

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 16 mars 2011

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 12 sept. 2011

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 16 mars 2011

    5 pages4.68

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 11 mars 2010

    18 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    18 pages2.34B

    Avis de nomination d'un administrateur de remplacement/supplémentaire

    1 pages2.40B

    Avis de vacance de poste par l'administrateur

    7 pages2.39B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 15 sept. 2009

    14 pages2.24B

    Résultat de la réunion des créanciers

    25 pages2.23B

    Résultat de la réunion des créanciers

    25 pages2.23B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    24 pages2.17B

    legacy

    1 pages287

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    5 pages363a

    Comptes consolidés établis au 31 mars 2007

    28 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de THE NEIGHBOURHOOD INITIATIVES FOUNDATION ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BELL, Graeme Hylton
    3 Mannicotts
    AL8 7BW Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Secrétaire
    3 Mannicotts
    AL8 7BW Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British74246760001
    ANDERSON, Kenneth Wyper Paterson
    12 Kirk Lane
    Livingston Village
    EH54 7HY Livingston
    West Lothian
    Administrateur
    12 Kirk Lane
    Livingston Village
    EH54 7HY Livingston
    West Lothian
    British72233240001
    BELL, Graeme Hylton
    3 Mannicotts
    AL8 7BW Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Administrateur
    3 Mannicotts
    AL8 7BW Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    United KingdomBritish74246760001
    BLOWER, Barrie Stuart
    44 Wood End Road
    WS5 3BG Walsall
    West Midlands
    Administrateur
    44 Wood End Road
    WS5 3BG Walsall
    West Midlands
    British31521100001
    DAVIES, David Glyn
    43 Wesley Road
    Ironbridge
    TF8 7BD Telford
    Salop
    Administrateur
    43 Wesley Road
    Ironbridge
    TF8 7BD Telford
    Salop
    United KingdomBritish53631090001
    LOCKE, Andrew John
    The Grange
    Middleton Scriven
    WV16 6AG Bridgnorth
    Salop
    Administrateur
    The Grange
    Middleton Scriven
    WV16 6AG Bridgnorth
    Salop
    British57982120001
    WATSON, Paul Richard
    77 Heath Street
    DY8 1SA Stourbridge
    West Midlands
    Administrateur
    77 Heath Street
    DY8 1SA Stourbridge
    West Midlands
    EnglandBritish94883450001
    WOODROW, Frederick David
    178 Alcester Road
    B80 7PA Studley
    Warwickshire
    Administrateur
    178 Alcester Road
    B80 7PA Studley
    Warwickshire
    British12607050001
    BURROWS, Donald Leslie
    38 Manor Rise
    Arleston
    TF1 2ND Telford
    Shropshire
    Secrétaire
    38 Manor Rise
    Arleston
    TF1 2ND Telford
    Shropshire
    Other117191990001
    FOSTER, Helen
    Badger Farmhouse
    Badger
    WV6 7JS Wolverhampton
    West Midlands
    Secrétaire
    Badger Farmhouse
    Badger
    WV6 7JS Wolverhampton
    West Midlands
    British32122700001
    HAMPTON, David John
    102 Prestwood Road West
    Wednesfield
    WV11 1HL Wolverhampton
    West Midlands
    Secrétaire
    102 Prestwood Road West
    Wednesfield
    WV11 1HL Wolverhampton
    West Midlands
    British73194160001
    ALLEN, Lorna Marjorie
    23 Berberis Road
    Leegomery
    TF1 6XF Telford
    Salop
    Administrateur
    23 Berberis Road
    Leegomery
    TF1 6XF Telford
    Salop
    EnglandBritish76285730001
    DAVIDSON, Scott Wilson
    2/1 3 Westclyffe Street
    G41 2EF Glasgow
    Administrateur
    2/1 3 Westclyffe Street
    G41 2EF Glasgow
    British54329010001
    DENT, John
    44 Kestrel Drive
    Loggerheads
    TF9 2QT Market Drayton
    Salop
    Administrateur
    44 Kestrel Drive
    Loggerheads
    TF9 2QT Market Drayton
    Salop
    British52067540001
    GIBSON, John Anthony Clark, Doctor
    67 Beech Grove
    Blackhall Mill
    NE17 7TD Newcastle Upon Tyne
    Administrateur
    67 Beech Grove
    Blackhall Mill
    NE17 7TD Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish52067530001
    HANDY, Christopher Ronald, Dr
    69 Bridgnorth Road
    Stourton
    DY7 6RS Stourbridge
    West Midlands
    Administrateur
    69 Bridgnorth Road
    Stourton
    DY7 6RS Stourbridge
    West Midlands
    EnglandBritish33322070002
    HERON, Frances Mary
    65 Oxenholme
    Harrington Square
    NW1 2JN London
    Administrateur
    65 Oxenholme
    Harrington Square
    NW1 2JN London
    EnglandBritish47033650002
    HOLMES, Nicola Caroline
    85 Silverton Way
    Wednesfield
    WV11 3LA Wolverhampton
    West Midlands
    Administrateur
    85 Silverton Way
    Wednesfield
    WV11 3LA Wolverhampton
    West Midlands
    British94277630001
    KNIGHT, Christine Mary, Dr
    Wem
    SY4 5HF Shrewsbury
    Mill Dam Cottage
    Shropshire
    Administrateur
    Wem
    SY4 5HF Shrewsbury
    Mill Dam Cottage
    Shropshire
    EnglandBritish88314340002
    POON, Yeow Hua, Dr
    46 Primrose Lane
    Hall Green
    B28 0JJ Birmingham
    Administrateur
    46 Primrose Lane
    Hall Green
    B28 0JJ Birmingham
    Malaysian44289640001
    PYE, John
    Old School House
    Drayton Road
    TF9 3NF Hodnet
    Shropshire
    Administrateur
    Old School House
    Drayton Road
    TF9 3NF Hodnet
    Shropshire
    British40531790001
    RILEY, Edith Mary
    4 Vicarage Way
    ST17 9AD Stafford
    Staffordshire
    Administrateur
    4 Vicarage Way
    ST17 9AD Stafford
    Staffordshire
    British52067550001
    ROOKWOOD, Ralph Maurice
    14 Park Close
    Middleton Stoney
    OX6 8ST Bicester
    Oxon
    Administrateur
    14 Park Close
    Middleton Stoney
    OX6 8ST Bicester
    Oxon
    Canadian12607020001
    TURKINGTON, Richard, Dr
    59 Stocks Lane
    Newland
    WR13 5DY Malvern
    Worcestershire
    Administrateur
    59 Stocks Lane
    Newland
    WR13 5DY Malvern
    Worcestershire
    United KingdomBritish75302520001

    THE NEIGHBOURHOOD INITIATIVES FOUNDATION a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 15 janv. 2007
    Livré le 25 janv. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Land at the poplars lightmoor telford shropshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 25 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 18 mai 1999
    Livré le 21 mai 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The poplars lightmoor road lightmoor telford wrekin t/n SL74598.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 mai 1999Enregistrement d'une charge (395)

    THE NEIGHBOURHOOD INITIATIVES FOUNDATION a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    16 mars 2009Administration started
    17 mars 2010Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Robert Michael Young
    Currie Young Limited The Old Barn
    Caverswall Park, Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent
    practitioner
    Currie Young Limited The Old Barn
    Caverswall Park, Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent
    Paul Finnity
    Begbies Traynor
    The Old Barn
    ST3 6HP Caverswall Park
    Caverswall Lane Stoke On Trent
    practitioner
    Begbies Traynor
    The Old Barn
    ST3 6HP Caverswall Park
    Caverswall Lane Stoke On Trent
    Steven John Currie
    The Old Barn Caverswall Park
    Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent
    Staffordshire
    practitioner
    The Old Barn Caverswall Park
    Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent
    Staffordshire
    2
    DateType
    17 mars 2010Commencement of winding up
    05 mars 2013Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Steven John Currie
    The Old Barn Caverswall Park
    Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent
    Staffordshire
    practitioner
    The Old Barn Caverswall Park
    Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent
    Staffordshire
    Robert Michael Young
    Currie Young Limited The Old Barn
    Caverswall Park, Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent
    practitioner
    Currie Young Limited The Old Barn
    Caverswall Park, Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0