IMCO RECONOMY 5 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéIMCO RECONOMY 5 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03347372
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de IMCO RECONOMY 5 LIMITED ?

    • Collecte de déchets non dangereux (38110) / Approvisionnement en eau, assainissement, gestion des déchets et activités de dépollution

    Où se situe IMCO RECONOMY 5 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Kelsall House Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Shropshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de IMCO RECONOMY 5 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SKIPS@HOME LIMITED18 avr. 200718 avr. 2007
    WELLS FARGO SKIPS LIMITED08 avr. 199708 avr. 1997

    Quels sont les derniers comptes de IMCO RECONOMY 5 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour IMCO RECONOMY 5 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Déclaration de confirmation établie le 08 avr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 avr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Changement d'adresse du siège social de 2 Coldbath Square London EC1R 5HL à Kelsall House Stafford Court Stafford Park 1 Telford Shropshire TF3 3BD le 26 juil. 2016

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr John Sullivan en tant que secrétaire le 21 juil. 2016

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Richard Llewelyn Milnes-James en tant que directeur le 21 juil. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Charles Nicholas Pollard en tant que directeur le 21 juil. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Alistair Myrie Holl en tant que directeur le 21 juil. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Caroline Elizabeth Allen en tant que secrétaire le 21 juil. 2016

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr John Terence Sullivan en tant qu'administrateur le 21 juil. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Paul Cox en tant qu'administrateur le 21 juil. 2016

    2 pagesAP01

    Satisfaction de la charge 033473720005 en totalité

    4 pagesMR04

    Deuxième dépôt de TM02 précédemment soumis à Companies House

    5 pagesRP04
    Annotations
    DateAnnotation
    13 juin 2016Clarification This document is a second filing of the TM02 registered on 12/05/2016 for Sophie Catherine Jane Reed

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    16 pagesAA

    Nomination de Ms Caroline Elizabeth Allen en tant que secrétaire le 11 avr. 2016

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Sophie Catherine Jane Reed en tant que secrétaire le 01 avr. 2016

    2 pagesTM02
    Annotations
    DateAnnotation
    13 juin 2016Clarification A second filed TM02 was registered on 13/06/2016

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 avr. 2016

    État du capital au 21 avr. 2016

    • Capital: GBP 10
    SH01

    Cessation de la nomination de Peter Anton Gerstrom en tant que directeur le 01 déc. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Charles Nicholas Pollard en tant qu'administrateur le 01 déc. 2015

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de IMCO RECONOMY 5 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SULLIVAN, John
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    Secrétaire
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    210820120001
    COX, Paul Anthony
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    Administrateur
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    EnglandBritish153797870001
    SULLIVAN, John Terence
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    Administrateur
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    EnglandBritish180046340001
    ALLEN, Caroline Elizabeth
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Secrétaire
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    208085190001
    DIXON, Sally Veronica
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Secrétaire
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    British105363350001
    JESKE, Riga
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Secrétaire
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    189290690001
    KAHVECI, Suheda
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Secrétaire
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    176235280001
    PHILLIPS, Elizabeth Clare
    14 Blackhill Lane
    WA16 9DR Knutsford
    Cheshire
    Secrétaire
    14 Blackhill Lane
    WA16 9DR Knutsford
    Cheshire
    British56302980001
    REED, Sophie Catherine Jane
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Secrétaire
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    198174110001
    SCOTT, Stephen John
    52 Mucklow Hill
    Halesowen
    B62 8BL Birmingham
    Secrétaire désigné
    52 Mucklow Hill
    Halesowen
    B62 8BL Birmingham
    British900002270001
    WELLS, Jennifer Ann
    20a Collett Way
    Priorslee
    TF2 9SL Telford
    Salop
    Secrétaire
    20a Collett Way
    Priorslee
    TF2 9SL Telford
    Salop
    British63479470001
    EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    Secrétaire
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    32524900007
    DIXON, Sally Veronica
    22 Ardleigh Road
    N1 4HP London
    Administrateur
    22 Ardleigh Road
    N1 4HP London
    EnglandBritish105363350001
    GERSTROM, Peter Anton
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Administrateur
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    EnglandBritish138719750001
    HARRISON, Julian John
    24 Havelock Road
    SY3 7NE Shrewsbury
    Salop
    Administrateur
    24 Havelock Road
    SY3 7NE Shrewsbury
    Salop
    EnglandBritish123927990001
    HOLL, Alistair Myrie
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Administrateur
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    WalesBritish138014840001
    JOHNSON, Peter Stuart
    The Old Post Office
    Church Road West Peckham
    ME18 5JL Maidstone
    Kent
    Administrateur
    The Old Post Office
    Church Road West Peckham
    ME18 5JL Maidstone
    Kent
    EnglandBritish11159620001
    MILNES-JAMES, Richard Llewelyn
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Administrateur
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    United KingdomBritish140753960001
    PHILLIPS, John
    14 Blackhill Lane
    WA16 9DR Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    14 Blackhill Lane
    WA16 9DR Knutsford
    Cheshire
    British343070001
    POLLARD, Charles Nicholas
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Administrateur
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    EnglandBritish192011710001
    RIDDLE, David Ellison
    3 Lovelace Road
    KT6 6NS Surbiton
    Surrey
    Administrateur
    3 Lovelace Road
    KT6 6NS Surbiton
    Surrey
    EnglandBritish556710002
    SCOTT, Jacqueline
    52 Mucklow Hill
    Halesowen
    B62 8BL Birmingham
    Administrateur désigné
    52 Mucklow Hill
    Halesowen
    B62 8BL Birmingham
    British900002260001
    STEGGLES, Jonathan David
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Administrateur
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    United KingdomBritish45141530001
    WARD, Malcolm John
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Administrateur
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    United KingdomBritish57775660003
    WELLS, Peter
    20a Collett Way
    Priorslee
    TF2 9SL Telford
    Salop
    Administrateur
    20a Collett Way
    Priorslee
    TF2 9SL Telford
    Salop
    British45937400001
    WILLACY, Richard Johannes Ormerod
    Wraymead
    158 Croydon Road
    RH2 0NG Reigate
    Surrey
    Administrateur
    Wraymead
    158 Croydon Road
    RH2 0NG Reigate
    Surrey
    United KingdomBritish92108930002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur IMCO RECONOMY 5 LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Waste Hire Service Limited
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    England
    06 avr. 2016
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementUk
    Numéro d'enregistrement03441128
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    IMCO RECONOMY 5 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 20 août 2015
    Livré le 27 août 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 août 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 25 juil. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A supplemental common debenture
    Créé le 29 nov. 2011
    Livré le 08 déc. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 déc. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 24 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of accession
    Créé le 18 mai 2007
    Livré le 25 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (Security Trustee)
    Transactions
    • 25 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 26 avr. 2005
    Livré le 11 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee in its capacity as security agent for the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cibc World Markets PLC
    Transactions
    • 11 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    First fixed and floating charge
    Créé le 26 mai 1999
    Livré le 04 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    A first fixed charge on all book and other debts as are not sold or bought by alex lawrie receivable financing limited under an agreement dated 2ND june 1999 and a floating charge all proceeds of book and other debts with the payment of any sum due or owing to alex lawrie receivables financing limited under or in connection with any bill of exchange or other negotiable instrument to which both the company and alex lawrie receivables financing limited are a party.
    Personnes ayant droit
    • Alex Lawrie Receivables Financing Limited
    Transactions
    • 04 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0