STANDARD CHARTERED TRUSTEES (UK) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | STANDARD CHARTERED TRUSTEES (UK) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03350300 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe STANDARD CHARTERED TRUSTEES (UK) LIMITED ?
| Adresse du siège social | 1 Basinghall Avenue EC2V 5DD London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de STANDARD CHARTERED TRUSTEES (UK) LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour STANDARD CHARTERED TRUSTEES (UK) LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 05 mars 2027 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 19 mars 2027 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 05 mars 2026 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour STANDARD CHARTERED TRUSTEES (UK) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Cessation de la nomination de Justin Andrew Seymour Fowke en tant que directeur le 24 mars 2026 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 05 mars 2026 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Maria Alejandra Jacobson en tant qu'administrateur le 16 oct. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Michael Rose en tant que directeur le 16 oct. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2024 | 5 pages | AA | ||
Nomination de Mr Palwinder Singh Hare en tant qu'administrateur le 14 mai 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Palwinder Singh Hare en tant que directeur le 25 avr. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 05 mars 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2023 | 5 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 05 mars 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Notification de Standard Chartered Bank en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 26 juin 2017 | 2 pages | PSC02 | ||
Cessation de Standard Chartered Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 26 juin 2017 | 1 pages | PSC07 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Justin Andrew Seymour Fowke le 05 févr. 2024 | 2 pages | CH01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022 | 5 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 avr. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Janice Yan Ping Yeo le 12 avr. 2023 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur The Law Debenture Pension Trust Corporation P.L.C. le 30 nov. 2020 | 1 pages | CH02 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021 | 5 pages | AA | ||
Nomination de Janice Yan Ping Yeo en tant qu'administrateur le 01 août 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Peter John Phillip Gibbinson en tant que directeur le 01 août 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 avr. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Justin Andrew Seymour Fowke le 01 sept. 2019 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Peter John Phillip Gibbinson le 01 juil. 2018 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nigel John Richards le 17 déc. 2021 | 2 pages | CH01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020 | 5 pages | AA | ||
Qui sont les dirigeants de STANDARD CHARTERED TRUSTEES (UK) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC (SECRETARIES) LIMITED | Secrétaire | Basinghall Avenue EC2V 5DD London 1 United Kingdom |
| 126490730001 | ||||||||||
| HARE, Palwinder Singh | Administrateur | Basinghall Avenue EC2V 5DD London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 149787070001 | |||||||||
| JACOBSON, Maria Alejandra | Administrateur | Basinghall Avenue EC2V 5DD London 1 United Kingdom | United Kingdom | Australian | 341753820001 | |||||||||
| LAWRENCE, Linda Ann | Administrateur | La Pearl, 4 Ashfield Lane BR7 6LQ Chislehurst Kent | United Kingdom | British | 7449690003 | |||||||||
| RICHARDS, Nigel John | Administrateur | Basinghall Avenue EC2V 5DD London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 211600540002 | |||||||||
| ROSSETTI, Sonia | Administrateur | Basinghall Avenue EC2V 5DD London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 187343520001 | |||||||||
| WHEELER, Christopher Paul | Administrateur | Basinghall Avenue EC2V 5DD London 1 United Kingdom | Scotland | British | 146779280002 | |||||||||
| YEO, Janice Yan Ping | Administrateur | Basinghall Avenue EC2V 5DD London 1 United Kingdom | United Kingdom | Singaporean | 298641000002 | |||||||||
| THE LAW DEBENTURE PENSION TRUST CORPORATION P.L.C. | Administrateur | 100 Bishopsgate EC2N 4AG London 8th Floor United Kingdom |
| 146073480001 | ||||||||||
| CALLAHAN, Linda Ann | Secrétaire | 5 Sedcombe Close DA14 4QG Sidcup Kent | British | 7449690001 | ||||||||||
| DWYER, Daniel John | Secrétaire désigné | 6 Brimstone Close Chelsfield Park BR6 7ST Chelsfield Kent | British | 900003970001 | ||||||||||
| FOX, Mark Adam | Secrétaire | 9 Trent Close WD7 9HX Shenley Hertfordshire | British | 79601950001 | ||||||||||
| GILL, Christopher Richard | Secrétaire | 104 Miles Road KT19 9AB Epsom Surrey | British | 58988340001 | ||||||||||
| SKIPPEN, Terry Charles | Secrétaire | 61 Richmond Road Leytonstone E11 4BX London | British | 54597200001 | ||||||||||
| THE LAW DEBENTURE PENSION TRUST CORPORATION P.L.C. | Secrétaire | 100 Wood Street EC2V 7EX London Fifth Floor United Kingdom |
| 146073480001 | ||||||||||
| BAILLIE, Robin Alexander Macdonald | Administrateur | 19 Post Office Square London Road TN1 1BQ Tunbridge Wells Kent | British | 26138380004 | ||||||||||
| DAVIDSON, John Sneddon | Administrateur | Longfield House 8 Dudsbury Road West Parley BH22 8RF Ferndown Dorset | British | 55271150003 | ||||||||||
| DOYLE, Betty June | Administrateur désigné | 8 The Bartons Elstree Hill North WD6 3EN Elstree Herts | British | 900003960001 | ||||||||||
| DWYER, Daniel John | Administrateur désigné | 6 Brimstone Close Chelsfield Park BR6 7ST Chelsfield Kent | British | 900003970001 | ||||||||||
| FLETCHER, David Martin | Administrateur | Ickleton Place 32 Brookhampton Street Ickleton CB10 1SP Saffron Walden Essex | British | 141816590001 | ||||||||||
| FOWKE, Justin Andrew Seymour | Administrateur | Basinghall Avenue EC2V 5DD London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 201778170003 | |||||||||
| FRANKLIN, William John | Administrateur | 80 South Road CF36 3DA Porthcawl Mid Glamorgan | British | 8309500001 | ||||||||||
| GIBBINSON, Peter John Phillip | Administrateur | Basinghall Avenue EC2V 5DD London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 245104280002 | |||||||||
| GRAY, Mark Douglas | Administrateur | Basinghall Avenue EC2V 5DD London 1 United Kingdom | England | British | 155951830001 | |||||||||
| GREEN, Michael James | Administrateur | The Hermitage High Street Twyford SO21 1RG Winchester Hampshire | British | 48480960001 | ||||||||||
| HARE, Palwinder Singh | Administrateur | Basinghall Avenue EC2V 5DD London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 149787070001 | |||||||||
| HUNTER, Richard Andrew | Administrateur | Holmfield Wonersh Common, Wonersh GU5 0PL Guildford Surrey | United Kingdom | British | 50520200002 | |||||||||
| JEBSON, Paul Stephen | Administrateur | 22 Greystone Park TN14 6EB Sundridge Kent | United Kingdom | British | 93182210002 | |||||||||
| JULIUS, Laurence Jeffrey | Administrateur | Basinghall Avenue EC2V 5DD London 1 United Kingdom | England | British | 22499730001 | |||||||||
| KELJIK, Christopher Avedis | Administrateur | 62a Flood Street SW3 5TE London | England | British | 52296240002 | |||||||||
| LAWS, Gavin Crawford | Administrateur | Basinghall Avenue EC2V 5DD London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 90826000001 | |||||||||
| LEICESTER, Mark Simon | Administrateur | Basinghall Avenue EC2V 5DD London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 180135400002 | |||||||||
| MAXWELL, John Alexander | Administrateur | Dalintober Ledaig PA37 1SA Oban Argyll | British | 63334440002 | ||||||||||
| MOORE, Sarah Alison | Administrateur | 62 Ty Draw Road Penylan CF23 5HD Cardiff South Glamorgan | British | 118820740001 | ||||||||||
| ORSICH, Alan | Administrateur | 5 Cary Walk WD7 8AP Radlett Hertfordshire | United Kingdom | British | 93237010001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur STANDARD CHARTERED TRUSTEES (UK) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Chartered Bank | 26 juin 2017 | Basinghall Avenue EC2V 5DD London 1 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Standard Chartered Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Basinghall Avenue EC2V 5DD London 1 United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0