COACH HOLIDAY GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOACH HOLIDAY GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03353865
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COACH HOLIDAY GROUP LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe COACH HOLIDAY GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de COACH HOLIDAY GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WALLACE ARNOLD GROUP LIMITED09 juil. 199709 juil. 1997
    INHOCO 640 LIMITED16 avr. 199716 avr. 1997

    Quels sont les derniers comptes de COACH HOLIDAY GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour COACH HOLIDAY GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    12 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 21 mai 2021

    10 pagesLIQ03

    Cessation de la nomination de a G Secretarial Limited en tant que secrétaire le 22 mars 2020

    2 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de Waterside House Waterside Drive Wigan Lancashire WN3 5AZ United Kingdom à 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds West Yorkshire LS11 5QR le 22 juil. 2020

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 22 mai 2020

    LRESEX

    Déclaration des affaires

    10 pagesLIQ02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 16 avr. 2019 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Gary Speakman en tant que directeur le 31 déc. 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Paul David Smith en tant qu'administrateur le 01 oct. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Vincent Flower en tant que directeur le 01 oct. 2018

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    7 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Graham John Rogers le 12 sept. 2018

    2 pagesCH01

    Modification des détails de Shearings Leisure Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 juin 2018

    2 pagesPSC05

    Déclaration de confirmation établie le 16 avr. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Statuts

    36 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Graham John Rogers le 13 nov. 2017

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gary Speakman le 13 nov. 2017

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Vincent Flower le 13 nov. 2017

    2 pagesCH01

    Modification des détails de Shearings Leisure Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 nov. 2017

    2 pagesPSC05

    Modification des détails de Shearings Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 nov. 2017

    2 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de Victoria Mill Miry Lane Wigan WN3 4AG à Waterside House Waterside Drive Wigan Lancashire WN3 5AZ le 13 nov. 2017

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    8 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de COACH HOLIDAY GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CALVERT, Richard James
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    Administrateur
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    1 Bridgewater Place
    West Yorkshire
    EnglandBritishCeo163434180002
    ROGERS, Graham John
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    Administrateur
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector69494710002
    SMITH, Paul David
    Waterside Drive
    Wigan Pier Business Park
    WN3 5AZ Wigan
    C/O Specialist Leisure Group, Waterside House
    United Kingdom
    Administrateur
    Waterside Drive
    Wigan Pier Business Park
    WN3 5AZ Wigan
    C/O Specialist Leisure Group, Waterside House
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant228581750001
    HINSLIFF, Robert
    30 Buckingham Drive
    WA16 8LH Knutsford
    Cheshire
    Secrétaire
    30 Buckingham Drive
    WA16 8LH Knutsford
    Cheshire
    British51000070001
    MEDDES, Kenneth Sydney
    Hillside Townhill
    Bramham
    LS23 6QD Wetherby
    Secrétaire
    Hillside Townhill
    Bramham
    LS23 6QD Wetherby
    BritishDirector11486330002
    THOMAS, Joan Valerie
    3 Broom Road
    LS24 9LH Tadcaster
    North Yorkshire
    Secrétaire
    3 Broom Road
    LS24 9LH Tadcaster
    North Yorkshire
    British51418740001
    TURNER, Jayne Marie
    33 Dingleway
    Appleton
    WA4 3AB Warrington
    Cheshire
    Secrétaire
    33 Dingleway
    Appleton
    WA4 3AB Warrington
    Cheshire
    BritishAccountant117561640001
    A B & C SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secrétaire désigné
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006570001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    60 Chiswell Street
    EC1Y 4AG London
    Milton Gate
    United Kingdom
    Secrétaire
    60 Chiswell Street
    EC1Y 4AG London
    Milton Gate
    United Kingdom
    90084920001
    BARBER, Stephen Donald
    5 Springbank Close
    Farsley Pudsey
    LS28 5TP Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    5 Springbank Close
    Farsley Pudsey
    LS28 5TP Leeds
    West Yorkshire
    BritishOperations Dir11617040001
    BARR, Robert Adam
    Crow House Farm
    Burton Leonard
    HG3 3SX Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    Crow House Farm
    Burton Leonard
    HG3 3SX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDeputy Chairman28813320001
    FLOWER, Vincent
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    Administrateur
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director91542970002
    GILMORE, Nicholas John
    76 Ilsham Road
    TQ1 2HY Torquay
    Devon
    Administrateur
    76 Ilsham Road
    TQ1 2HY Torquay
    Devon
    BritishDirector53768550001
    MAXWELL, William
    Snelsins House
    Snelsins Lane
    BD19 3UE Cleckheaton
    West Yorkshire
    Administrateur
    Snelsins House
    Snelsins Lane
    BD19 3UE Cleckheaton
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector108831380001
    MEDDES, Kenneth Sydney
    Hillside Townhill
    Bramham
    LS23 6QD Wetherby
    Administrateur
    Hillside Townhill
    Bramham
    LS23 6QD Wetherby
    United KingdomBritishManaging Director11486330002
    NEWBOLD, David Robert
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    Administrateur
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director30276880001
    NORMAN, Bernard Robert
    Brackley House
    Marholm Road Ufford
    PE9 3BL Stamford
    Lincolnshire
    Administrateur
    Brackley House
    Marholm Road Ufford
    PE9 3BL Stamford
    Lincolnshire
    United KingdomBritishCompany Director65467300001
    O'CALLAGHAN, Joseph
    9 Mallard Walk
    DE3 0TF Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    9 Mallard Walk
    DE3 0TF Derby
    Derbyshire
    EnglandBritishDirector110216340001
    SLATCHER, David John
    3 Brindle Heights Water Street
    Brindle
    PR6 8YA Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    3 Brindle Heights Water Street
    Brindle
    PR6 8YA Chorley
    Lancashire
    BritishCompany Director104434750001
    SPEAKMAN, Gary
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    Administrateur
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director56066860001
    WORMWELL, Denis
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    Administrateur
    Miry Lane
    WN3 4AG Wigan
    Victoria Mill
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Executive Officer124681340001
    WORSNUP, Peter Jonathan
    12 Grantley Place
    Bradley
    HD2 1LZ Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    12 Grantley Place
    Bradley
    HD2 1LZ Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant95865490001
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Administrateur désigné
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur COACH HOLIDAY GROUP LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement5272464
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Waterside Drive
    WN3 5AZ Wigan
    Waterside House
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement09009187
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    COACH HOLIDAY GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee and set-off agreement
    Créé le 20 avr. 2006
    Livré le 05 mai 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Its credit balances. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 05 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 20 avr. 2006
    Livré le 05 mai 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 05 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 18/04/06 and
    Créé le 20 mars 2006
    Livré le 22 avr. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All and whole the claymore hotel (formerly the cobbler hotel) arrochar t/no DMB19886.
    Personnes ayant droit
    • Jewel Hotels Trustee I Limited and Jewel Hotels Trutee Ii Limited as Trustees of the Jewelhotel
    Transactions
    • 22 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 28 march 2005 and
    Créé le 21 mars 2005
    Livré le 08 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All and whole the subjects k/a and forming the fife arms hotel, braemar, aberdeenshire (formerly the cobbler hotel) arrochar, t/n DMB19886. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Indigo Capital Limited as Security Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 08 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 28 march 2005 and
    Créé le 21 mars 2005
    Livré le 08 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All and whole the subjects k/a and forming the fife arms hotel, braemar, aberdeenshire, t/n ABN50574. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Indigo Capital Limited as Security Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 08 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 nov. 2005Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 16 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 28 march 2005 and
    Créé le 21 mars 2005
    Livré le 08 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All and whole the subjects k/a and forming the fife arms hotel, braemar, aberdeenshire, t/n ABN50574. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 08 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 nov. 2005Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 24 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 28 march 2005 and
    Créé le 21 mars 2005
    Livré le 08 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All and whole the subjects k/a and forming the claymore hotel (formerly the cobbler hotel) arrochar, t/n DMB19886. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 08 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on 29 march 2005 and
    Créé le 21 mars 2005
    Livré le 13 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All and whole the subjects known as and forming the fife arms hotel braemar aberdeenshire t/n ABN50574.
    Personnes ayant droit
    • 3I Investments PLC (As Security Trustee for the Finance Parties)
    Transactions
    • 13 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 nov. 2005Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 24 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on 29 march 2005 and
    Créé le 21 mars 2005
    Livré le 13 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All and whole the subjects forming the claymore hotel (formerly the cobbler hotel) arrochar t/n DMB19886.
    Personnes ayant droit
    • 3I Investments PLC (As Security Trustee for the Finance Parties)
    Transactions
    • 13 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 mars 2005
    Livré le 31 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage its interest in the land, by way of fixed charge all shares and all related distribution rights, all investments and all related distribution rights, plant and machinery, book debts, non-trading debts and by way of floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Indigo Capital Limited as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 31 mars 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 mars 2005
    Livré le 31 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage its interest in the land, by way of fixed charge all shares and all related distribution rights, all investments and all related distribution rights, plant and machinery, book debts, non-trading debts and by way of floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 31 mars 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mars 2006Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 04 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 mars 2005
    Livré le 30 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • 3I Investments PLC (As Security Trustee)
    Transactions
    • 30 mars 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 18 september 2003 and
    Créé le 03 sept. 2003
    Livré le 25 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and whole the property known as and forming the cobbler hotel, arrochar, scotland t/no DMB19886.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 25 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 15 october 2001 and
    Créé le 02 oct. 2001
    Livré le 19 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and in terms of a facility letter and/or pursuant to any of the other finance documents
    Brèves mentions
    The fife arms hotel braemar (ABN50574).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 15 october 2001 and
    Créé le 02 oct. 2001
    Livré le 19 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and in terms of a facility letter and/or pursuant to any of the other finance documents
    Brèves mentions
    0.40 acres at broombank terrace braemar (AB50572). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of key-man policies
    Créé le 02 oct. 2001
    Livré le 18 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite cross guarantee and mortgage debenture
    Créé le 02 oct. 2001
    Livré le 18 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite cross guarantee and mortgage debenture
    Créé le 02 oct. 2001
    Livré le 18 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 30 july 2001 and
    Créé le 13 juil. 2001
    Livré le 03 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including without prejudice to that generality in terms of a facilities agreement (as defined) dated 15 august 1997 and/or pursuant to any of the other finance documents
    Brèves mentions
    0,40 acres at broombank terrace, braemar, aberdeenshire (ABN50572). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC for Itself and as Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 03 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 30 july 2001 and
    Créé le 13 juil. 2001
    Livré le 03 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including without prejudice to that generality in terms of a facilities agreement (as defined) dated 15 august 1997 and/or pursuant to any of the other finance documents
    Brèves mentions
    The fife arms hotel, braemar, aberdeenshire (ABN50574). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC for Itself and as Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 03 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 26 july 2001 and
    Créé le 13 juil. 2001
    Livré le 03 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including without prejudice to that generality in terms of a facility letter (as defined) and/or pursuant to any of the other finance documents
    Brèves mentions
    0.40 acres at broombrook terrace, braemar, aberdeenshire. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC for Itself and as Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 03 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 26 july 2001 and
    Créé le 13 juil. 2001
    Livré le 03 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including without prejudice to that generality in terms of a facility letter (as defined) and/or pursuant to any of the other finance documents
    Brèves mentions
    The fife arms hotel, braemar, aberdeenshire. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC for Itself and as Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 03 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A charge over shares between the company and barclays bank PLC (the "security trustee")
    Créé le 09 févr. 2001
    Livré le 28 févr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys, obligations and liabilities for the time being due owing or incurred by any company in the wallace arnold group to the security trustee and/or the beneficiaries on any account whatsoever
    Brèves mentions
    27,000 ordinary shares of £1.00 each in perfect holidays limited and all dividends interest and other distributions.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 févr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A charge over shares
    Créé le 26 janv. 2001
    Livré le 07 févr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee and/or the beneficiaries on any account whatsoever pursuant to the banking agreements (as defined)
    Brèves mentions
    All the shares,dividends,and bonus issues. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 févr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 18TH march 1999 and
    Créé le 05 mars 1999
    Livré le 24 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    25 high st,bonnyrigg,county of midlothian with all rights,pertinents,etc. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    COACH HOLIDAY GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    22 mai 2020Commencement of winding up
    09 mai 2022Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0