HI FINANCE PROPERTIES LIMITED

HI FINANCE PROPERTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHI FINANCE PROPERTIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03363702
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HI FINANCE PROPERTIES LIMITED ?

    • Hôtels et hébergement similaire (55100) / Hébergement et restauration

    Où se situe HI FINANCE PROPERTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hill House 1
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HI FINANCE PROPERTIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HOLIDAY INN FINANCE PROPERTIES LIMITED16 juil. 200216 juil. 2002
    COMPASS HOTEL PROPERTIES LIMITED31 janv. 200131 janv. 2001
    GRANADA HOTEL PROPERTIES LIMITED26 sept. 199726 sept. 1997
    2036TH SINGLE MEMBER SHELF INVESTMENT COMPANY LIMITED01 mai 199701 mai 1997

    Quels sont les derniers comptes de HI FINANCE PROPERTIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour HI FINANCE PROPERTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    17 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 nov. 2018

    16 pagesLIQ03

    Cessation de la nomination de Justin Bruce Robinson en tant que directeur le 14 sept. 2018

    1 pagesTM01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 10 Queen Street Place London EC4R 1AG

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 10 Queen Street Place London EC4R 1AG

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 10 Queen Street Place London EC4R 1AG United Kingdom à Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR le 21 déc. 2017

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    6 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 30 nov. 2017

    LRESSP

    Modification des coordonnées du secrétaire Haysmacintyre Company Secretaries Limited le 18 déc. 2017

    1 pagesCH04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Justin Bruce Robinson le 18 déc. 2017

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Michael Teasdale le 18 déc. 2017

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de 26 Red Lion Square London WC1R 4AG United Kingdom à 10 Queen Street Place London EC4R 1AG le 18 déc. 2017

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Patrick Thomas Mabry le 18 déc. 2017

    2 pagesCH01

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 033637020006

    5 pagesMR05

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    20 pagesAA

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 03 oct. 2017

    • Capital: GBP 1.00
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 01 oct. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge 033637020006

    5 pagesMR05

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Justin Bruce Robinson le 03 févr. 2017

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 01 oct. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de HI FINANCE PROPERTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Queen Street Place
    EC4R 1AG London
    10
    United Kingdom
    Secrétaire
    Queen Street Place
    EC4R 1AG London
    10
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement4682161
    89121630002
    MABRY, Patrick Thomas
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    Administrateur
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    LuxembourgGerman204005420001
    TEASDALE, Simon Michael
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    Administrateur
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    United KingdomBritish204008350001
    COMBEER, Jean Brenda
    Robin Hill 3 St Johns Avenue
    KT22 7HT Leatherhead
    Surrey
    Secrétaire
    Robin Hill 3 St Johns Avenue
    KT22 7HT Leatherhead
    Surrey
    British50345500001
    ENGMANN, Catherine
    18 Rays Avenue
    SL4 5HG Windsor
    Berkshire
    Secrétaire
    18 Rays Avenue
    SL4 5HG Windsor
    Berkshire
    British92722710002
    LOYNES, Paul
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    Secrétaire
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    203651900001
    MASON, Timothy Charles
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    British12314170002
    TAUTZ, Helen Jane
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    Secrétaire
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    British37564540001
    WILLIAMS, Alison
    27 Valley Road
    CM11 2BS Billericay
    Essex
    Secrétaire
    27 Valley Road
    CM11 2BS Billericay
    Essex
    British78744290002
    HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Secrétaire
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement4682161
    89121630002
    PAUL HASTINGS ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED
    Bishops Square
    Eighth Floor
    E1 6EG London
    Ten
    United Kingdom
    Secrétaire
    Bishops Square
    Eighth Floor
    E1 6EG London
    Ten
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement04131463
    125623230001
    SISEC LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Secrétaire désigné
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001770001
    BAKER, Skardon Francis
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    Administrateur
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United KingdomAmerican196342720001
    CARTWRIGHT, Stacey Lee
    46 Chiddingstone Road
    SW6 3TG London
    Administrateur
    46 Chiddingstone Road
    SW6 3TG London
    British37682070002
    CROSTON, Francis John
    5 The Laurels
    Queenborough Lane
    CM77 7QD Braintree
    Essex
    Administrateur
    5 The Laurels
    Queenborough Lane
    CM77 7QD Braintree
    Essex
    United KingdomBritish65219360003
    DAVENPORT, Donald Andrew
    Ramsbury House 23 Badgers Hill
    Wentworth
    GU25 4SA Virginia Water
    Surrey
    Administrateur
    Ramsbury House 23 Badgers Hill
    Wentworth
    GU25 4SA Virginia Water
    Surrey
    United KingdomBritish13178710003
    DEMPSEY, Patrick Joseph Anthony
    Cuckoo Meadow Little Shardeloes
    HP7 0EF Old Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Cuckoo Meadow Little Shardeloes
    HP7 0EF Old Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish100598030001
    EKAS, Petra Cecilia Maria
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Administrateur
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    United KingdomDutch169731050002
    FISH, Andrew John
    Cherry Tree Cottage
    Manor Close
    KT24 6SA East Horsley
    Surrey
    Administrateur
    Cherry Tree Cottage
    Manor Close
    KT24 6SA East Horsley
    Surrey
    EnglandBritish77133450001
    KOLEV, Ivaylo
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    Administrateur
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    UkBulgarian193389430001
    LOYNES, Paul
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    Administrateur
    St. George Street
    W1S 1FS London
    25
    United Kingdom
    United KingdomBritish241370450001
    MACKENZIE, Lisa Marie
    70 Vassall Road
    Kennington
    SW9 6HY London
    Administrateur
    70 Vassall Road
    Kennington
    SW9 6HY London
    British78059700001
    MARTIN, Andrew David
    5 Dalkeith Road
    AL5 5PP Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    5 Dalkeith Road
    AL5 5PP Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritish52743800001
    MCCARTHY, John Patrick
    Regents Park Road
    NW1 8XL London
    120
    Administrateur
    Regents Park Road
    NW1 8XL London
    120
    United States112396050001
    MCEWAN, Allan Scott
    29 Kings Road
    SL4 2AD Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    29 Kings Road
    SL4 2AD Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish75569660002
    MITCHELL, Paul Raymond
    Waltons Farm
    Hollygreen Lane
    HP27 9PL Bledlow
    Bucks
    England
    Administrateur
    Waltons Farm
    Hollygreen Lane
    HP27 9PL Bledlow
    Bucks
    England
    EnglandBritish148147140001
    MORTIMER, David Grant
    86 Frenchay Road
    OX2 6TF Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    86 Frenchay Road
    OX2 6TF Oxford
    Oxfordshire
    British47770480002
    NEWMAN, Mark
    Flat 7 44 Sloane Street
    SW1X 9LU London
    Administrateur
    Flat 7 44 Sloane Street
    SW1X 9LU London
    United KingdomCanadian62529820001
    PARROTT, Graham Joseph
    Flat 1 27 Redington Road
    Hampstead
    NW3 7QY London
    Administrateur
    Flat 1 27 Redington Road
    Hampstead
    NW3 7QY London
    British6741720003
    PRINCE, Ryan David
    7a Howick Place
    SW1P 1DZ London
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    7a Howick Place
    SW1P 1DZ London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomCanadian85682450077
    ROBINSON, Justin Bruce
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    Administrateur
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    United KingdomBritish225299130001
    SPRINGETT, Catherine Mary
    The Coach House
    32 Kerrison Road Ealing
    W5 5NW London
    Administrateur
    The Coach House
    32 Kerrison Road Ealing
    W5 5NW London
    United KingdomBritish147336720001
    STAUNTON, Henry Eric
    Fairfield
    Nursery Road
    KT20 7TZ Walton On The Hill
    Surrey
    Administrateur
    Fairfield
    Nursery Road
    KT20 7TZ Walton On The Hill
    Surrey
    EnglandBritish37935500001
    STOCKS, Nigel Peter
    Birdwoods
    School Lane Shackleford
    GU8 6AZ Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Birdwoods
    School Lane Shackleford
    GU8 6AZ Godalming
    Surrey
    United KingdomBritish147336730001
    STRETTON, Mark Nigel
    Top Cottage
    Upper Oddington
    GL56 0XN Moreton-In-Marsh
    Administrateur
    Top Cottage
    Upper Oddington
    GL56 0XN Moreton-In-Marsh
    British95909440001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HI FINANCE PROPERTIES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement04160938
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    HI FINANCE PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 01 déc. 2015
    Livré le 02 déc. 2015
    En cours
    Brève description
    F/H crest hotel filton road hambrook t/no.AV194979 and l/h the bloomsbury crest hotel coram stret t/no.NGL672413.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale, London Branch (As Common Security Agent for the Common Secured Parties (the Common Security Agent))
    Transactions
    • 02 déc. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 05 sept. 2017Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 18 déc. 2017L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    A registered charge
    Créé le 22 mai 2013
    Livré le 03 juin 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    F/H basingstoke crest hotel grove road basingstoke t/no HP409818, f/h black prince hotel southwold road bexley t/no SGL103988, f/h crest hotel filton road hambrook t/no AV194979, for details of further properties charged please refer to the form MR01. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutshce Bank Ag, London Branch (The Common Security Agent)
    Transactions
    • 03 juin 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 04 sept. 2014Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 02 déc. 2014Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 07 avr. 2015Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 03 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 20 juin 2005
    Livré le 28 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H crowne plaza birmingham nec at national exhibition centre birmingham west midlands t/n WM722535 f/h crowne plaza london - heathrow at land and buildings on the west side of stockley road and the north side of cherry lane west drayton t/n NGL160680 f/h holiday inn brentwood at brook street brentwood t/n EX323558 * please refer to the form 395 for further details of property charged *. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Citicorp Trustee Company Limited (The Security Trustee)
    Transactions
    • 28 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juin 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 20 juin 2005
    Livré le 22 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Citicorp Trustee Company Limited
    Transactions
    • 22 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juin 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 241097
    Créé le 24 oct. 1997
    Livré le 07 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The erskine crest hotel erskine renfrew t/n REN57421.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 oct. 1997
    Livré le 29 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from granada group PLC to the chargee pursuant to the terms of the loan agreement of even date together with any other monies payable by the company to the chargee under the legal charge
    Brèves mentions
    Basingstoke posthouse (formerly basingstoke crest hotel) basingstoke hampshire T.no: HP409818; bexley posthouse (formerly k/a black prince public house) rochester way l/b of bexley t/no: SGL103988; bristol posthouse (formerly crest hotel) filton house hambrrok south gloucestershire t/no: AV194979. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (The "Secured Party")
    Transactions
    • 29 oct. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    HI FINANCE PROPERTIES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    30 nov. 2017Commencement of winding up
    17 avr. 2019Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    practitioner
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Ian Harvey Dean
    Athene Place,66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    practitioner
    Athene Place,66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0