COVE CARE (MOUNTAIN ASH RESIDENTIAL HOME) LIMITED

COVE CARE (MOUNTAIN ASH RESIDENTIAL HOME) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOVE CARE (MOUNTAIN ASH RESIDENTIAL HOME) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03364414
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COVE CARE (MOUNTAIN ASH RESIDENTIAL HOME) LIMITED ?

    • Établissements de soins infirmiers en résidence (87100) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe COVE CARE (MOUNTAIN ASH RESIDENTIAL HOME) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Voyage Care Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Staffordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de COVE CARE (MOUNTAIN ASH RESIDENTIAL HOME) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour COVE CARE (MOUNTAIN ASH RESIDENTIAL HOME) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour COVE CARE (MOUNTAIN ASH RESIDENTIAL HOME) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 mai 2015

    État du capital au 07 mai 2015

    • Capital: GBP 4
    SH01

    Nomination de Mr Philip Andre Sealey en tant qu'administrateur le 09 janv. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kevin Wei Roberts en tant que directeur le 09 janv. 2015

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2014

    18 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 mai 2014

    État du capital au 12 mai 2014

    • Capital: GBP 4
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2013

    18 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * Garrick House 2 Queen Street Lichfield Staffordshire WS13 6QD United Kingdom* le 25 sept. 2013

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Kevin Wei Roberts en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de James Mckendrick en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Période comptable actuelle raccourcie du 30 sept. 2013 au 31 mars 2013

    1 pagesAA01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2012

    17 pagesAA

    Nomination de Mr James Bruce Mckendrick en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr James Bruce Mckendrick en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de * Ilg St Georges House, Knoll Road Camberley Surrey GU15 3SY* le 13 mars 2013

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de James Hayward en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Neil Donaldson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Philip Andre Sealey en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Nomination de Mr Andrew Winning en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Thomas Burns en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de COVE CARE (MOUNTAIN ASH RESIDENTIAL HOME) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SEALEY, Philip Andre
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    Secrétaire
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    176562560001
    SEALEY, Philip Andre
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    Administrateur
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    EnglandBritish45325360001
    WINNING, Andrew
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    Administrateur
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    EnglandBritish73772160002
    ALFLATT, John Neal
    The Old Rectory
    St Andrew Street
    SG14 1HZ Hertford
    Secrétaire
    The Old Rectory
    St Andrew Street
    SG14 1HZ Hertford
    British86320800002
    FENTON, Janet Patricia
    Bracken View
    Fyrsway
    TN35 4BG Fairlight Cove
    East Sussex
    Secrétaire
    Bracken View
    Fyrsway
    TN35 4BG Fairlight Cove
    East Sussex
    British75885450002
    HYATT, Gregory John
    The Firs
    27 Crookham Road
    GU51 5DP Fleet
    Hampshire
    Secrétaire
    The Firs
    27 Crookham Road
    GU51 5DP Fleet
    Hampshire
    British61663230001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Secrétaire désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    BURNS, Thomas
    27 Park Avenue North
    NN3 2HT Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    27 Park Avenue North
    NN3 2HT Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish78519600001
    DONALDSON, Neil
    Ilg St Georges House, Knoll Road
    Camberley
    GU15 3SY Surrey
    Administrateur
    Ilg St Georges House, Knoll Road
    Camberley
    GU15 3SY Surrey
    EnglandBritish172494110001
    FENTON, Allen Kenneth
    Bracken View Fyrs Way
    Fairlight Cove
    TN35 4BG Hastings
    East Sussex
    Administrateur
    Bracken View Fyrs Way
    Fairlight Cove
    TN35 4BG Hastings
    East Sussex
    British38064290002
    FENTON, Janet Patricia
    Bracken View
    Fyrsway
    TN35 4BG Fairlight Cove
    East Sussex
    Administrateur
    Bracken View
    Fyrsway
    TN35 4BG Fairlight Cove
    East Sussex
    British75885450002
    HAYWARD, James Duncan Henry
    Ilg St Georges House, Knoll Road
    Camberley
    GU15 3SY Surrey
    Administrateur
    Ilg St Georges House, Knoll Road
    Camberley
    GU15 3SY Surrey
    EnglandBritish24500050002
    HYATT, Gregory John
    The Firs
    27 Crookham Road
    GU51 5DP Fleet
    Hampshire
    Administrateur
    The Firs
    27 Crookham Road
    GU51 5DP Fleet
    Hampshire
    United KingdomBritish61663230001
    LANE, Geoffrey Roy
    Larkrise
    Redcroft Walk
    GU6 8DS Cranleigh
    Surrey
    Administrateur
    Larkrise
    Redcroft Walk
    GU6 8DS Cranleigh
    Surrey
    EnglandBritish20198450001
    MCKENDRICK, James Bruce
    2 Queen Street
    WS13 6QD Lichfield
    Garrick House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    2 Queen Street
    WS13 6QD Lichfield
    Garrick House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish154043480001
    ROBERTS, Kevin Wei
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    Administrateur
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    EnglandBritish72030660002
    SAVAGE, Andrew
    Lindisfarne The Cloisters
    Wadworth Hall Lane Wadworth
    DN11 9BH Doncaster
    Administrateur
    Lindisfarne The Cloisters
    Wadworth Hall Lane Wadworth
    DN11 9BH Doncaster
    EnglandBritish117869550001
    TURNER, Thelma Lucille
    5 Bar Road North
    Beckingham
    DN10 4NN Doncaster
    Cobblers Cottage
    South Yorkshire
    Administrateur
    5 Bar Road North
    Beckingham
    DN10 4NN Doncaster
    Cobblers Cottage
    South Yorkshire
    United KingdomBritish170427170001
    WHITTAKER, George Anthony David
    Ketton House
    Ketton
    PE9 3TD Aldgate
    Rutland
    Administrateur
    Ketton House
    Ketton
    PE9 3TD Aldgate
    Rutland
    EnglandBritish125108980001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Administrateur désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    COVE CARE (MOUNTAIN ASH RESIDENTIAL HOME) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 18 déc. 2006
    Livré le 29 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or other obligor to the security trustee and the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Mountain ash fairlight gardens fairlight cove east sussex t/n ESX53352. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 29 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mars 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Supplemental deed
    Créé le 14 déc. 2005
    Livré le 22 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Equity Partnership Investment Comapny PLC
    Transactions
    • 22 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 14 déc. 2005
    Livré le 21 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mars 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 19 juil. 2004
    Livré le 03 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Flat 27 and garage 16, fairlight gardens, fairlight, east sussex; all fixtures and fittings; all the plant and machinery vehicles and computer equipment; all furniture furnishings equipment tools and other chattels. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 janv. 2003
    Livré le 08 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    "Phoenix house" lower waites lane,fairlight east sussex TN35 4DD; esx 263989. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 janv. 2003
    Livré le 08 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Mountain ash residential care home waites lane,fairlight,east sussex TN35 4AX; esx 53352. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 27 nov. 2002
    Livré le 06 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0