AEQUANIMITER LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAEQUANIMITER LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03365130
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AEQUANIMITER LIMITED ?

    • (7415) /

    Où se situe AEQUANIMITER LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Unit C25 Jacks Place
    6 Corbet Place
    E1 6NN London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AEQUANIMITER LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TYROLESE (381) LIMITED02 mai 199702 mai 1997

    Quels sont les derniers comptes de AEQUANIMITER LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour AEQUANIMITER LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    État du capital au 12 févr. 2010

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    resolution

    Résolution de capitalisation ou d'émission d'actions gratuites

    Re payment of dividend 09/12/2009
    RES14

    legacy

    2 pagesSH20

    legacy

    4 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel share perm a/c / £217270 be utilised from merger reserve a/c and a/c cancelled/ capital redemption reserve cancelled 09/12/2009
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    12 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    11 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages403a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    12 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    11 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2004

    11 pagesAA

    legacy

    3 pages363s

    Qui sont les dirigeants de AEQUANIMITER LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FOX, Andrew Staley
    4 Dukes Road
    RH16 2JH Haywards Heath
    West Sussex
    Secrétaire
    4 Dukes Road
    RH16 2JH Haywards Heath
    West Sussex
    British43073160004
    EWART, David John
    Courthill House
    Potterne
    SN10 5PN Devizes
    Wiltshire
    Administrateur
    Courthill House
    Potterne
    SN10 5PN Devizes
    Wiltshire
    United KingdomBritish23635320001
    HARBORD-HAMOND, Charles Anthony Assheton
    45 Alderbrook Road
    SW12 8AD London
    Administrateur
    45 Alderbrook Road
    SW12 8AD London
    United KingdomBritish56874210004
    BENNETT, Fiona Marie Therese
    29 Little Adelphi
    10 John Adam Street
    WC2N 6HA London
    Secrétaire
    29 Little Adelphi
    10 John Adam Street
    WC2N 6HA London
    British39511970004
    CRAWFORD-SMITH, Neil Leslie
    11 Manor Rise
    Bearsted
    ME14 4DB Maidstone
    Kent
    Secrétaire
    11 Manor Rise
    Bearsted
    ME14 4DB Maidstone
    Kent
    British65236570001
    CRWFORD SMITH, Neil Leslie
    11 Manor Rise
    ME14 4DB Bearsted
    Kent
    Secrétaire
    11 Manor Rise
    ME14 4DB Bearsted
    Kent
    British104304670001
    HARFITT, Lorraine
    3 Greensands
    Walderslade
    ME5 9DQ Chatham
    Kent
    Secrétaire
    3 Greensands
    Walderslade
    ME5 9DQ Chatham
    Kent
    British81874010001
    MCMULLEN, Gerald Phipps
    Little Broomhall Warnham
    RH12 3PA Horsham
    West Sussex
    Secrétaire
    Little Broomhall Warnham
    RH12 3PA Horsham
    West Sussex
    British19668600001
    TYROLESE (SECRETARIAL) LIMITED
    66 Lincoln's Inn Fields
    WC2A 3LH London
    Secrétaire désigné
    66 Lincoln's Inn Fields
    WC2A 3LH London
    900002460001
    HOLBECH, Timothy Hugh
    64 Geraldine Road
    SW18 2NL London
    Administrateur
    64 Geraldine Road
    SW18 2NL London
    British19390190001
    ROYDS, Emma Louise
    4 Lysias Road
    SW12 8BP London
    Administrateur
    4 Lysias Road
    SW12 8BP London
    British30320080003
    SPARROW, Andrew James
    Eye Kettleby Hall
    LE14 2TS Melton Mowbray
    Leicestershire
    Administrateur
    Eye Kettleby Hall
    LE14 2TS Melton Mowbray
    Leicestershire
    EnglandBritish19390170004
    WATSON, Michael John Bannatyne
    3 Edenhurst Avenue
    SW6 3PD London
    Administrateur
    3 Edenhurst Avenue
    SW6 3PD London
    British64292610002
    TYROLESE (DIRECTORS) LIMITED
    66 Lincoln's Inn Fields
    WC2A 3LH London
    Administrateur désigné
    66 Lincoln's Inn Fields
    WC2A 3LH London
    900002470001
    TYROLESE (SECRETARIAL) LIMITED
    66 Lincoln's Inn Fields
    WC2A 3LH London
    Administrateur désigné
    66 Lincoln's Inn Fields
    WC2A 3LH London
    900002460001

    AEQUANIMITER LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 14 oct. 2004
    Livré le 25 oct. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the trustee or any of the other beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company, the investments, the shares, all dividends, interest and other moneys payable in respect of the shares; and all monetary claims and all related rights. Assignment of the proceeds of any insurance policy and all related rights; and all rights and claims in relation to any assigned account. First floating charge over the whole of the company's undertaking and assets, both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 25 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 15 janv. 2002
    Livré le 16 janv. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 16 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 26 nov. 1999
    Livré le 03 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0