SUNSHINE REALISATIONS LIMITED

SUNSHINE REALISATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSUNSHINE REALISATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03367115
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SUNSHINE REALISATIONS LIMITED ?

    • (2030) /

    Où se situe SUNSHINE REALISATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o KPMG LLP
    Quayside House
    110 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SUNSHINE REALISATIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    AMDEGA LIMITED16 sept. 199816 sept. 1998
    CROSSCO (263) LIMITED08 mai 199708 mai 1997

    Quels sont les derniers comptes de SUNSHINE REALISATIONS LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 sept. 2010
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2011
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2009

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SUNSHINE REALISATIONS LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au08 mai 2017
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation22 mai 2017
    En retardOui

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour SUNSHINE REALISATIONS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour SUNSHINE REALISATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Restauration par ordonnance du tribunal

    2 pagesAC92

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 19 oct. 2012

    28 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la dissolution le 19 oct. 2012

    28 pages2.35B

    legacy

    2 pagesLQ01

    legacy

    2 pagesLQ01

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 12 mars 2012

    21 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 26 oct. 2011

    26 pages2.24B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    3 pagesF2.18

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    11 pages2.16B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    33 pages2.17B

    Certificat de changement de nom

    Company name changed amdega LIMITED\certificate issued on 03/06/11
    3 pagesCERTNM
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Changement d'adresse du siège social de Amdega Ltd Faverdale Industrial Estate Darlington County Durham DL3 0PW United Kingdom le 05 mai 2011

    2 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael Derek Willink le 26 avr. 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Alan Moore le 26 avr. 2011

    2 pagesCH01

    Nomination de Mrs Michelle Woodward en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Nomination de Mr Michael Derek Willink en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Philip Barker en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr David Alan Moore en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Philip Barker en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Karl Wharton en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de SUNSHINE REALISATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WOODWARD, Michelle
    c/o Kpmg Llp
    110 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Quayside House
    Secrétaire
    c/o Kpmg Llp
    110 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Quayside House
    156730100001
    CRUDDACE, Paul
    c/o Kpmg Llp
    110 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Quayside House
    Administrateur
    c/o Kpmg Llp
    110 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Quayside House
    EnglandBritish156717870001
    MOORE, David Alan
    c/o Kpmg Llp
    110 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Quayside House
    Administrateur
    c/o Kpmg Llp
    110 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Quayside House
    United KingdomBritish156725110002
    WILLINK, Michael Derek
    c/o Kpmg Llp
    110 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Quayside House
    Administrateur
    c/o Kpmg Llp
    110 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Quayside House
    United KingdomBritish117390210002
    BARKER, Philip Dennison
    Faverdale Industrial Estate
    DL3 0PW Darlington
    Amdega Ltd
    County Durham
    United Kingdom
    Secrétaire
    Faverdale Industrial Estate
    DL3 0PW Darlington
    Amdega Ltd
    County Durham
    United Kingdom
    153221490001
    ROBSON, Louise Annette
    1 Fewston Close
    TS26 0QN Hartlepool
    Teeside
    Secrétaire
    1 Fewston Close
    TS26 0QN Hartlepool
    Teeside
    British86240210001
    DICKINSON DEES
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    Secrétaire désigné
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    900005460001
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Secrétaire
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    94529700001
    BARKER, Philip Dennison
    Faverdale Industrial Estate
    DL3 0PW Darlington
    Amdega Ltd
    County Durham
    United Kingdom
    Administrateur
    Faverdale Industrial Estate
    DL3 0PW Darlington
    Amdega Ltd
    County Durham
    United Kingdom
    United KingdomBritish40070580001
    CARE, Timothy James
    West House Whorlton Hall Farm
    Westerhope
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    Administrateur désigné
    West House Whorlton Hall Farm
    Westerhope
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    British900005450001
    HOWSE, Gary Nigel
    Faverdale Industrial Estate
    DL3 0PW Darlington
    Amdega Ltd
    County Durham
    United Kingdom
    Administrateur
    Faverdale Industrial Estate
    DL3 0PW Darlington
    Amdega Ltd
    County Durham
    United Kingdom
    United KingdomBritish48461770001
    MEE, Andrew John
    10 St Aidans Park
    Fourstones
    NE47 5EB Hexham
    Northumberland
    Administrateur
    10 St Aidans Park
    Fourstones
    NE47 5EB Hexham
    Northumberland
    British61646630001
    MORAN, Peter Joseph
    1 Wilton Close
    DL3 9RE Darlington
    County Durham
    Administrateur
    1 Wilton Close
    DL3 9RE Darlington
    County Durham
    British54512410001
    REDFERN, Christopher John
    Faverdale Industrial Estate
    DL3 0PW Darlington
    Amdega Ltd
    County Durham
    United Kingdom
    Administrateur
    Faverdale Industrial Estate
    DL3 0PW Darlington
    Amdega Ltd
    County Durham
    United Kingdom
    EnglandBritish54512330003
    REYNOLDS, Anthony Edward James, Dr
    Keats House Barnes Croft
    Hilderstone
    ST15 8XU Stone
    Staffordshire
    Administrateur
    Keats House Barnes Croft
    Hilderstone
    ST15 8XU Stone
    Staffordshire
    British50009530001
    TAYLOR, Colin Michael
    4 Serpentine Road
    TS26 0LZ Hartlepool
    Administrateur
    4 Serpentine Road
    TS26 0LZ Hartlepool
    British54512180003
    WHARTON, Karl David
    Faverdale Industrial Estate
    DL3 0PW Darlington
    Amdega Ltd
    County Durham
    United Kingdom
    Administrateur
    Faverdale Industrial Estate
    DL3 0PW Darlington
    Amdega Ltd
    County Durham
    United Kingdom
    EnglandBritish130080150001
    WILSON, Robert Graham
    8 Oaklands Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9PH Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Administrateur
    8 Oaklands Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9PH Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    United KingdomBritish6564660002

    SUNSHINE REALISATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 18 août 2010
    Livré le 21 août 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Endless LLP (Security Trustee)
    Transactions
    • 21 août 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal mortgage
    Créé le 22 juin 2006
    Livré le 07 juil. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H faverdale industrial estate darlington county durham t/n DU161351. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 07 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 208 juin 2012Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (LQ01)
      • Numéro de dossier 2
    Debenture
    Créé le 28 févr. 2003
    Livré le 11 mars 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 11 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 28 févr. 2003
    Livré le 04 mars 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property land and buildings at faverdale industrial estate darlington county durham t/n's DU144683, DU181179, DU181252 and DU210805. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 04 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 308 juin 2012Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (LQ01)
      • Numéro de dossier 3
    Mortgage of trade marks
    Créé le 24 oct. 2000
    Livré le 31 oct. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the united kingdom trade marks listed in the schedule hereto. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 31 oct. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 juil. 1998
    Livré le 17 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Premises to the east of faverdale and to the north east of west auckland rd,faverdale industrial estate,darlington,durham; t/nos DU144683,DU181179,DU181252 and DU210805.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 juil. 1998
    Livré le 15 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Premises situated to the east of faverdale and land to the north-east of west auckland road faverdale industrial estate darlington co durham t/nos: DU144683 DU181179 DU181252 and DU210805 by way of assignment the goodwill of the business and the benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • Northern Rock PLC
    Transactions
    • 15 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 15 août 1997
    Livré le 29 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 août 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 15 août 1997
    Livré le 28 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of floating charge the udertaking of the company and all its property and assets please refer to form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Northern Rock Building Society
    Transactions
    • 28 août 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    SUNSHINE REALISATIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 avr. 2011Administration started
    19 oct. 2012Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Mark Granville Firmin
    Kpmg Llp
    Quayside House, 110 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    practitioner
    Kpmg Llp
    Quayside House, 110 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    practitioner
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    2Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Andrew Donald Rodger
    Gva Grimley Limited City Point
    29 King Street
    LS1 2HL Leeds
    receiver manager
    Gva Grimley Limited City Point
    29 King Street
    LS1 2HL Leeds
    Andrew Foster
    First Floor City Point
    29 King Street
    LS1 2HL Leeds
    West Yorkshire
    receiver manager
    First Floor City Point
    29 King Street
    LS1 2HL Leeds
    West Yorkshire
    3Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Andrew Donald Rodger
    Gva Grimley Limited City Point
    29 King Street
    LS1 2HL Leeds
    receiver manager
    Gva Grimley Limited City Point
    29 King Street
    LS1 2HL Leeds
    Andrew Foster
    First Floor City Point
    29 King Street
    LS1 2HL Leeds
    West Yorkshire
    receiver manager
    First Floor City Point
    29 King Street
    LS1 2HL Leeds
    West Yorkshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0