W A G GIBB LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéW A G GIBB LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03367190
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de W A G GIBB LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe W A G GIBB LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Kings Business Centre 90-92 King Edward Road
    CV11 4BB Nuneaton
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de W A G GIBB LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2015

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour W A G GIBB LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour W A G GIBB LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    4 pages4.71

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2015

    3 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Kings Business Centre 90-92 King Edward Road Nuneaton CV11 4BB England à Kings Business Centre 90-92 King Edward Road Nuneaton CV11 4BB le 12 déc. 2015

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Sapphire Court Walsgrave Triangle Coventry CV2 2TX à Kings Business Centre 90-92 King Edward Road Nuneaton CV11 4BB le 11 déc. 2015

    1 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 29 oct. 2015

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 mai 2015

    État du capital au 11 mai 2015

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2014 au 31 mars 2015

    1 pagesAA01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 mai 2014

    État du capital au 12 mai 2014

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Nomination de Mrs Wendy Margaret Hall en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de William Shepherd en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    3 pagesAA

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    3 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    3 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    3 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 13 en totalité

    3 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    3 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Nomination de Mr Thorsten Beer en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    3 pagesAA

    Cessation de la nomination de Andrew Willetts en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Nichola Louise Legg en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Qui sont les dirigeants de W A G GIBB LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LEGG, Nichola Louise
    King Edward Road
    CV11 4BB Nuneaton
    Kings Business Centre 90-92
    Secrétaire
    King Edward Road
    CV11 4BB Nuneaton
    Kings Business Centre 90-92
    171100430001
    BEER, Thorsten
    King Edward Road
    CV11 4BB Nuneaton
    Kings Business Centre 90-92
    Administrateur
    King Edward Road
    CV11 4BB Nuneaton
    Kings Business Centre 90-92
    United KingdomGerman172030260001
    HALL, Wendy Margaret
    King Edward Road
    CV11 4BB Nuneaton
    Kings Business Centre 90-92
    Administrateur
    King Edward Road
    CV11 4BB Nuneaton
    Kings Business Centre 90-92
    EnglandBritish172979860001
    BRIERLEY, Jennifer Anne
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Secrétaire
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    British118563210001
    GIBB, Lynne Vanessa
    Green End Farm
    Green End
    MK45 2AB Maulden
    Bedfordshire
    Secrétaire
    Green End Farm
    Green End
    MK45 2AB Maulden
    Bedfordshire
    British62759410003
    HEATON, Janet Ruth
    Sapphire Court
    Walsgrave
    CV2 2TX Coventry
    C/O Wendy Hall
    England
    Secrétaire
    Sapphire Court
    Walsgrave
    CV2 2TX Coventry
    C/O Wendy Hall
    England
    British81228260001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Secrétaire désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    GIBB, Lynne Vanessa
    Green End Farm
    Green End
    MK45 2AB Maulden
    Bedfordshire
    Administrateur
    Green End Farm
    Green End
    MK45 2AB Maulden
    Bedfordshire
    United KingdomBritish62759410003
    GIBB, William Andrew Gerald
    Green End Farm
    Green End
    MK45 2AB Maulden
    Bedfordshire
    Administrateur
    Green End Farm
    Green End
    MK45 2AB Maulden
    Bedfordshire
    United KingdomBritish80202790002
    HOOD, John
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    Administrateur
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    British39644740002
    SHEPHERD, William
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Great BritainBritish162873980001
    SMERDON, Peter
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish16898700002
    WILLETTS, Andrew John
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish120451550002
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Administrateur désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    W A G GIBB LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 13 sept. 2004
    Livré le 17 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold - 30 marsh rd,luton; BD124384. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 17 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 juil. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 08 sept. 2004
    Livré le 15 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property at unit 2 kingfisher centre elthorne way newport pagnell milton keynes t/no BM161781. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 15 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 juil. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 05 août 2004
    Livré le 10 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 10 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 juil. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 05 févr. 2001
    Livré le 10 févr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 30 marsh road luton bedfordshire LU3 2NJ.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 févr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 nov. 1998
    Livré le 18 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 14 katherine place abbots langley herts.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 févr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 nov. 1998
    Livré le 18 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 2 kingfisher centre elthorne way newport pagnell bucks.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 nov. 1998
    Livré le 18 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 62 calverton road luton beds.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 nov. 1998
    Livré le 18 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 186(b) marsh road luton beds.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 nov. 1998
    Livré le 18 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 12 purley centre marsh farm housing estate luton beds.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 nov. 1998
    Livré le 10 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £200,000.00 plus stock at valuation which is not to exceed a sum of £120,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Shop number 12 purley centre,marsh farm,luton,beds.including any statutory renewal or extension thereof comprised in the lease dated 29 april 1987.shop number 186(b) marsh road,luton aforesaid including any statutory renewal or extension thereof comprised in the lease dated 14 december 1984.shop number 62 calverton road,luton aforesaid comprised in the lease dated 30 november 1998.floating security all the undertaking and goodwill fixtures and fittings.
    Personnes ayant droit
    • Frederick Herbert Pearson
    Transactions
    • 10 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 nov. 1998
    Livré le 08 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aah Pharmaceuticals Limited
    Transactions
    • 08 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 juil. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 03 août 1998
    Livré le 21 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 09 juil. 1997
    Livré le 17 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 17 juil. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 juil. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)

    W A G GIBB LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    29 oct. 2015Commencement of winding up
    09 sept. 2016Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ian Pattinson
    Pattinsons Insolvency Limited Kings Business Centre
    90-92 King Edward Road
    CV11 4BB Nuneaton
    Warwickshire
    practitioner
    Pattinsons Insolvency Limited Kings Business Centre
    90-92 King Edward Road
    CV11 4BB Nuneaton
    Warwickshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0