KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED

KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED
    Statut de la sociétéConverti / Fermé
    Forme juridiqueConverti ou fermé
    Numéro de société 03372093
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED ?

    • Vente au détail en magasin non spécialisé avec prédominance d'alimentation, de boissons ou de tabac (47110) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PRICESTORE LIMITED16 mai 199716 mai 1997

    Quels sont les derniers comptes de KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au11 janv. 2015

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Divers

    Forms b & z convert to rs
    2 pagesMISC

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Convert to rs 02/06/2016
    RES13

    État du capital après une attribution d'actions au 02 juin 2016

    • Capital: GBP 2,800,002
    3 pagesSH01

    Nomination de Mr David Roberts en tant qu'administrateur le 01 avr. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Steven Clive Bailey en tant que directeur le 01 avr. 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 avr. 2016

    État du capital au 28 avr. 2016

    • Capital: GBP 2,800,000
    SH01

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2015

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 mai 2015

    État du capital au 01 mai 2015

    • Capital: GBP 2,800,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 02 janv. 2014

    4 pagesAA

    Période comptable actuelle prolongée du 02 janv. 2015 au 11 janv. 2015

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 août 2014

    État du capital au 29 août 2014

    • Capital: GBP 2,800,000
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 mai 2014

    État du capital au 06 mai 2014

    • Capital: GBP 2,800,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 05 janv. 2013

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de * New Century House Corporation Street Manchester M60 4ES* le 03 déc. 2012

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    4 pagesAA

    Nomination de Cws (No.1) Limited en tant qu'administrateur

    2 pagesAP02

    Nomination de Mr Steven Clive Bailey en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Stephen Humes en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Timothy Hurrell en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 01 janv. 2011

    4 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy Hurrell le 01 août 2010

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SELLERS, Caroline Jane
    1 Gale Close
    Littleborough
    OL15 9EJ Rochdale
    Lancashire
    Secrétaire
    1 Gale Close
    Littleborough
    OL15 9EJ Rochdale
    Lancashire
    British45801060004
    ROBERTS, David Francis
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish200852560001
    CWS (NO.1) LIMITED
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Administrateur
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement1925625
    130695310001
    COBURN, Ian David
    6 Sorrel Drive
    GU18 5PB Lightwater
    Surrey
    Secrétaire
    6 Sorrel Drive
    GU18 5PB Lightwater
    Surrey
    British3000420001
    COUSINS, Alan Gordon Arthur
    94 Bridge Road
    SO31 7EP Sarisbury Green
    Hampshire
    Secrétaire
    94 Bridge Road
    SO31 7EP Sarisbury Green
    Hampshire
    British57534360001
    WHITTAKER, Katherine Alison
    22 Westfield Drive
    Woodley
    SK6 1LD Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    22 Westfield Drive
    Woodley
    SK6 1LD Stockport
    Cheshire
    British29899300002
    EXCELLET INVESTMENTS LIMITED
    Senator House
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4JL London
    Secrétaire
    Senator House
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4JL London
    1872620003
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secrétaire désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    BAILEY, Steven Clive
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish95753690002
    BRAITHWAITE, Neil
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    Administrateur
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    EnglandBritish87486660004
    CHEYNE, David George Thomson
    The Covert 98 Woodlands Road
    Ashurst
    SO40 7AH Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    The Covert 98 Woodlands Road
    Ashurst
    SO40 7AH Southampton
    Hampshire
    BritainBritish74956170001
    CLAPHAM, David John
    4 Heritage Hill
    BR2 6AU Keston
    Kent
    Administrateur
    4 Heritage Hill
    BR2 6AU Keston
    Kent
    United KingdomBritish29705630001
    COBURN, Ian David
    6 Sorrel Drive
    GU18 5PB Lightwater
    Surrey
    Administrateur
    6 Sorrel Drive
    GU18 5PB Lightwater
    Surrey
    British3000420001
    HENSHAW, Stephen Anthony
    Aylesbury House
    Horsebridge Road Broughton
    SO20 8BD Stockbridge
    Hampshire
    Administrateur
    Aylesbury House
    Horsebridge Road Broughton
    SO20 8BD Stockbridge
    Hampshire
    British91828160001
    HOLLAND, Joseph
    87 Chapleton Road
    Bromley Cross
    BL7 9LZ Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    87 Chapleton Road
    Bromley Cross
    BL7 9LZ Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish14141950001
    HOOKE, Anthony Arnold
    Cedars Wildwood Gardens
    Dingels Lane Cricket Hill
    GU46 6EB Yateley
    Hampshire
    Administrateur
    Cedars Wildwood Gardens
    Dingels Lane Cricket Hill
    GU46 6EB Yateley
    Hampshire
    British69353000002
    HUMES, Stephen
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    Administrateur
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United KingdomBritish84087790001
    HURRELL, Timothy
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    Administrateur
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    United KingdomBritish99724260001
    LAWSON, Stuart
    Treetops Smithwood Avenue
    GU6 8PS Cranleigh
    Surrey
    Administrateur
    Treetops Smithwood Avenue
    GU6 8PS Cranleigh
    Surrey
    British60361810001
    MCCRACKEN, Philip Guy
    The Bothy
    Bere Court Farm Pangbourne
    RG8 8HT Reading
    Berkshire
    Administrateur
    The Bothy
    Bere Court Farm Pangbourne
    RG8 8HT Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish106997230001
    ROBSON, William Henry Mark
    90 Springfield Road
    SL4 3PH Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    90 Springfield Road
    SL4 3PH Windsor
    Berkshire
    British57803420001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Administrateur désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001
    QUICKNESS LIMITED
    Senator House
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4JL London
    Administrateur
    Senator House
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4JL London
    47109420002

    KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and mortgage debenture
    Créé le 31 mai 2001
    Livré le 06 juin 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All actual, contingent, present and/or future obligations and liabilities of the company to the chargee and each of the secured parties
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Agent and Security Trustee for Itself and the Secured Parties (as Defined) (the "Security Trustee")
    Transactions
    • 06 juin 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 mai 1999
    Livré le 21 mai 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that l/h property k/a 105A junction road andover hampshire and the proceeds of sale all planat machinery fixtures and fittings goodwill and the benefit of the option dated 18/05/99.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 21 mai 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 avr. 1999
    Livré le 12 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Premises known as the maisonette/shop at 2/3 atholl court,kingsway gardens andover; see form 395. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 févr. 1999
    Livré le 25 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a 150A junction road andover hampshire the benefit of the option dated 23 february 1999 between the company and alldays stores limited. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 janv. 1999
    Livré le 28 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Ground floor shop and first floor office premises at 5 queens road farnborough hants. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 28 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 04 janv. 1999
    Livré le 07 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Ground floor shop premises and first and second floor maisonettes at 1/5 elizabeth parade tudor drive yateley hants. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 nov. 1998
    Livré le 24 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 570 wokingham road earley reading-BK84581 assigned the benefit of the option dated 10TH november 1998 between the company and alldays stores limited relating to the property (the option). By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 24 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 04 nov. 1998
    Livré le 09 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property at 8 alexandra road north camp farnborough hampshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of variation to a legal charge dated 21 august 1998
    Créé le 20 oct. 1998
    Livré le 28 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property means the ground floor shop premises at 286 gosbrook road caversham reading berkshire.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 28 oct. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 sept. 1998
    Livré le 30 sept. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Leasehold property k/a 109/113 queens road aldershot hampshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 sept. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 sept. 1998
    Livré le 18 sept. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at ash street ash surrey. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 18 sept. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 21 août 1998
    Livré le 09 sept. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Piece or parcel of land at the ground floor shop premises at 286 gosbrook road caversham reading berkshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 sept. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 juin 1998
    Livré le 15 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Ground floor shop premises at 1 and 2 giles court brookside walk tadley hampshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 05 mars 1998
    Livré le 18 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this legal charge
    Brèves mentions
    The company charges the property being land at ground floor shop premises at 53 high street aldershot hampshire GU11 1BH t/n-HP371495 (to the full extent of the company's interest in the property or its proceeds of sale) by way of legal mortagage of all legal interests and otherwise by way of specific equitable charge, assigned the benefit of all covenants and rights affecting or concerning the property subject to re-assignment on redemption, by way of fixed charge all the plant machinery and fixtures and fittings equipment and utensils, all the present or future goodwill of any business.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 18 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 déc. 1997
    Livré le 24 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property k/a ground floor and basement 55/57 erleigh road reading berkshire the goodwill of the business and the benefit of the option dated 23 december 1997 between the company and alldays stores limited. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 24 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 17 nov. 1997
    Livré le 19 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Ground floor and basement at 133/135 oxford road reading berkshire RG1 7UU t/n BK285171 all legal ineterests and otherwise by specific equitable charge assinged the benefit of all covenants and rights fixed charge all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements utensils all present or future goodwill of any business assigns the benefit of the option of even date.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 19 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 21 oct. 1997
    Livré le 24 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease dated 5TH february 1990
    Brèves mentions
    The rent deposit being an amount equal to 6 months rent from time to time firstly reserved by the lease being at the date of creation of the charge a deposit of £6,500.
    Personnes ayant droit
    • Double Reading Limited
    Transactions
    • 24 oct. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 mars 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 15 oct. 1997
    Livré le 24 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    That piece or parcel of land at 1 anstey close, basingstoke, hampshire and the goodwill of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 24 oct. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 sept. 1997
    Livré le 12 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Piece or parcel of land at 27/31 high street chobham surrey. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 sept. 1997
    Livré le 12 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Piece or parcel of land at 37 guildford road lightwater surrey. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 août 1997
    Livré le 27 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    That piece or parcel of land at 8 alexandra road north camp farnborough hants t/no.HP527455 and goodwill of any business.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 août 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 août 1997
    Livré le 22 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a 132 cove road farnborough hants t/no HP504574 by way of fixed charge all the present or future goodwill of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 août 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 août 1997
    Livré le 22 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 août 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 09 juil. 1997
    Livré le 28 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Alldays Stores Limited
    Transactions
    • 28 juil. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 09 juil. 1997
    Livré le 28 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Alldays Franchising Limited
    Transactions
    • 28 juil. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0