MINORPLANET SYSTEMS PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMINORPLANET SYSTEMS PLC
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 03372097
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MINORPLANET SYSTEMS PLC ?

    • (7415) /

    Où se situe MINORPLANET SYSTEMS PLC ?

    Adresse du siège social
    BDO LLP
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MINORPLANET SYSTEMS PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PIXIEDEAL PLC16 mai 199716 mai 1997

    Quels sont les derniers comptes de MINORPLANET SYSTEMS PLC ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour MINORPLANET SYSTEMS PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    17 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 oct. 2017

    17 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de C/O Bdo Llp 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds West Yorkshire LS11 5RU à Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL le 20 avr. 2017

    2 pagesAD01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 oct. 2016

    11 pages4.68

    Dépôt d'insolvabilité

    INSOLVENCY:Sec. Of State Cert of Release of Liquidator
    1 pagesLIQ MISC

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order insolvency:co to remove/replace liquidator
    13 pagesLIQ MISC OC

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 oct. 2015

    23 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 oct. 2014

    17 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 oct. 2013

    19 pages4.68

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 30 oct. 2012

    10 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    1 pages2.34B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 08 mai 2012

    12 pages2.24B

    Résultat de la réunion des créanciers

    2 pages2.23B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    47 pages2.17B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    20 pages2.16B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 08 nov. 2011

    11 pages2.24B

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 08 nov. 2011

    14 pages2.24B

    Avis de fin automatique de l'administration

    9 pages2.30B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 08 nov. 2011

    13 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 08 mai 2011

    17 pages2.24B

    Qui sont les dirigeants de MINORPLANET SYSTEMS PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HOPKIN, Richard
    37 The Meadows
    HX6 2UN Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    Secrétaire
    37 The Meadows
    HX6 2UN Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    British12491060010
    DONOVAN, Terence John
    Glebe House
    The Terrace Boston Spa
    LS23 6AH Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    Glebe House
    The Terrace Boston Spa
    LS23 6AH Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish101474510001
    HOPKIN, Richard
    37 The Meadows
    HX6 2UN Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    Administrateur
    37 The Meadows
    HX6 2UN Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    EnglandBritish12491060010
    HURLEY, Carolanne
    Flowery Fields Cottage
    Common Road
    ST8 7SR Biddulph Park
    Flowery Fields Cottage
    Staffs
    Administrateur
    Flowery Fields Cottage
    Common Road
    ST8 7SR Biddulph Park
    Flowery Fields Cottage
    Staffs
    EnglandEnglish80127620002
    WALKER, Andrew William
    The Fields Linton Road
    Collingham
    LS22 5BS Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    The Fields Linton Road
    Collingham
    LS22 5BS Wetherby
    West Yorkshire
    United KingdomBritish12066700001
    BYWELL, Robert Howard
    Moorlands
    Moorbottom Lane
    BD16 4HA Bingley
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Moorlands
    Moorbottom Lane
    BD16 4HA Bingley
    West Yorkshire
    British72284400001
    KELLY, Robert Daniel
    Stafford House
    33 Stafford Hill Lane
    HD5 0EE Huddersfield
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Stafford House
    33 Stafford Hill Lane
    HD5 0EE Huddersfield
    West Yorkshire
    British71715970001
    KING, Andrew Paul
    12 Princess Mead
    Goldsborough
    HG5 8NP Knaresborough
    N Yorkshire
    Secrétaire
    12 Princess Mead
    Goldsborough
    HG5 8NP Knaresborough
    N Yorkshire
    British24333360002
    MELTHAM, John David
    Willow Garth
    Howden Croft Hill, Ellerker
    HU15 2DE Brough
    North Humberside
    Secrétaire
    Willow Garth
    Howden Croft Hill, Ellerker
    HU15 2DE Brough
    North Humberside
    British74570910001
    MULLEN, Kenneth John
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    Scottish146642810001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secrétaire désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    WESTLEX REGISTRARS LIMITED
    21 Southampton Row
    WC1B 5HS London
    Secrétaire
    21 Southampton Row
    WC1B 5HS London
    39191480001
    ABRAHAMS, Michael David
    Newfield
    Mickley
    HG4 3JH Ripon
    North Yorkshire
    Administrateur
    Newfield
    Mickley
    HG4 3JH Ripon
    North Yorkshire
    EnglandBritish5117870001
    ALEXANDER, Charles Edward
    1 Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    Administrateur
    1 Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    British32134300001
    BENNETT, Philip William
    Scalvert Parade
    Newport
    New South Wales 2106
    Administrateur
    Scalvert Parade
    Newport
    New South Wales 2106
    Australian130990430001
    BEST, David Martin
    34 Vicarage Meadows
    WF14 9JL Mirfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    34 Vicarage Meadows
    WF14 9JL Mirfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish47892490001
    FISH, Graham Stewart
    The Old School House
    Church Street
    LE17 6EZ North Kilworth
    Leicester
    Administrateur
    The Old School House
    Church Street
    LE17 6EZ North Kilworth
    Leicester
    United KingdomBritish181919010001
    GAUNT, David Benjamin
    1a Saint Winifreds Road
    HG2 8LN Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    1a Saint Winifreds Road
    HG2 8LN Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish91939970001
    HARRISON, Christopher Gerard, Professor
    11 Ringley Park
    Whitefield
    M45 7NT Manchester
    Administrateur
    11 Ringley Park
    Whitefield
    M45 7NT Manchester
    EnglandBritish50288450002
    JACOMB, Martin Wakefield
    Manor Cottage
    Mill Lane, Adderbury
    OX17 3LW Banbury
    Oxfordshire
    Administrateur
    Manor Cottage
    Mill Lane, Adderbury
    OX17 3LW Banbury
    Oxfordshire
    British75361610004
    JARVIS, John Michael
    2 Greystone Park
    TN14 6EB Sundridge
    Kent
    Administrateur
    2 Greystone Park
    TN14 6EB Sundridge
    Kent
    EnglandBritish80470600001
    KEATING, James
    Robinscourt
    Model Farm Road
    IRISH Cork
    County Cork
    Ireland
    Administrateur
    Robinscourt
    Model Farm Road
    IRISH Cork
    County Cork
    Ireland
    IrelandIrish34330720001
    KELLY, Neil
    Beverley 22 Hill Top Road
    Stockton Heath
    WA4 2EF Warrington
    Administrateur
    Beverley 22 Hill Top Road
    Stockton Heath
    WA4 2EF Warrington
    EnglandBritish11745350004
    KELLY, Robert Daniel
    Stafford House
    33 Stafford Hill Lane
    HD5 0EE Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    Stafford House
    33 Stafford Hill Lane
    HD5 0EE Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish71715970001
    KING, Andrew Paul
    12 Princess Mead
    Goldsborough
    HG5 8NP Knaresborough
    N Yorkshire
    Administrateur
    12 Princess Mead
    Goldsborough
    HG5 8NP Knaresborough
    N Yorkshire
    British24333360002
    MACEY, John Dennis
    27 Whitegates Crescent
    Willaston
    L64 2UX South Wirral
    Administrateur
    27 Whitegates Crescent
    Willaston
    L64 2UX South Wirral
    British51013920001
    MCBRIDE, John Kristian Lars
    61 Arthur Road
    Wimbledon
    SW19 7DN London
    Administrateur
    61 Arthur Road
    Wimbledon
    SW19 7DN London
    EnglandBritish54651830001
    MELTHAM, John David
    Willow Garth
    Howden Croft Hill, Ellerker
    HU15 2DE Brough
    North Humberside
    Administrateur
    Willow Garth
    Howden Croft Hill, Ellerker
    HU15 2DE Brough
    North Humberside
    United KingdomBritish74570910001
    MORRIS, Jeffrey Clive
    Moor End Farm
    Harewood Avenue
    LS17 9HL East Keswick
    Leeds
    Administrateur
    Moor End Farm
    Harewood Avenue
    LS17 9HL East Keswick
    Leeds
    United KingdomBritish10648420001
    PERRY, David Gordon
    Deighton House
    York Road
    YO19 6HQ Deighton
    York
    Administrateur
    Deighton House
    York Road
    YO19 6HQ Deighton
    York
    British6323460001
    SPOONER, James Douglas, Sir
    Swire House
    59 Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    Administrateur
    Swire House
    59 Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    British35374990005
    TILLMAN, Andrew Daniel
    Hill Dean
    Barrowby Lane Kirby Overblow
    HG3 1HQ Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    Hill Dean
    Barrowby Lane Kirby Overblow
    HG3 1HQ Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish36748120001
    WOODS, Lucy Ann
    Ballencrief Road
    RG27 8JY Sunningdale
    Windlestream Cottage
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ballencrief Road
    RG27 8JY Sunningdale
    Windlestream Cottage
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish89944470003
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Administrateur désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Administrateur
    120 East Road
    N1 6AA London
    38524190001

    MINORPLANET SYSTEMS PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge over shares
    Créé le 13 mai 2010
    Livré le 01 juin 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right title and interest in and to the securities all dividends all stocks shares and the securities system rights see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Digicore International Holdings Bv
    Transactions
    • 01 juin 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 09 févr. 2010
    Livré le 19 févr. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Tcjm Limited
    Transactions
    • 19 févr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 03 sept. 2009
    Livré le 12 sept. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Asbury Park S.A.R.L
    Transactions
    • 12 sept. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 04 sept. 2008
    Livré le 09 sept. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 09 sept. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Rent deposit deed
    Créé le 26 sept. 2006
    Livré le 29 sept. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All monies standing to the credit of a deposit account pursuant to the terms of the rent deposit deed.
    Personnes ayant droit
    • Sanderson Logistics Limited
    Transactions
    • 29 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 16 mai 2006
    Livré le 20 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 20 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 28 juin 2005
    Livré le 18 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to the secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Ge Capital Equity Holdings Inc & Terence Donovan
    Transactions
    • 18 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 15 nov. 2004
    Livré le 27 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to the secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Capital Equity Holdings, Inc (As Security Trustee for the Secured Creditors)
    Transactions
    • 27 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge/security over shares
    Créé le 13 janv. 2004
    Livré le 22 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All securities and their proceeds of sale, all dividends, interest and other distributions paid in respect of the securities. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 03 sept. 2002
    Livré le 18 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property k/a 2 and 4 meanwood road leeds t/no WYK532960. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Escrow account charge
    Créé le 11 juin 2002
    Livré le 11 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    With full title guarantee charges by way of first fixed charge to hfgl all of its right title and interest in and to the account of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hfgl Limited
    Transactions
    • 11 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 14 févr. 2002
    Livré le 15 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a city garage manor street sheepscar leeds t/no WYK456290. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 21 nov. 2001
    Livré le 23 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a peregrine house gelderd close gelderd road leeds t/n WYK301906. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 24 oct. 1997
    Livré le 31 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 oct. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    MINORPLANET SYSTEMS PLC a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 nov. 2010Administration started
    08 nov. 2011Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Francis Graham Newton
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Dermot Justin Power
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    2
    DateType
    09 nov. 2011Administration started
    30 oct. 2012Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Dermot Justin Power
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Francis Graham Newton
    Bdo Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5RU Water Lane
    Leeds
    practitioner
    Bdo Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5RU Water Lane
    Leeds
    3
    DateType
    30 oct. 2012Commencement of winding up
    08 sept. 2018Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Dermot Justin Power
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Francis Graham Newton
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Kerry Bailey
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    practitioner
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0