EUROBELL (IDA) LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEUROBELL (IDA) LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03373001
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EUROBELL (IDA) LTD ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe EUROBELL (IDA) LTD ?

    Adresse du siège social
    Media House
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Hampshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de EUROBELL (IDA) LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    EUROBELL MANAGED SERVICES LIMITED03 juil. 199703 juil. 1997
    EUROBELL (NO.1) LIMITED19 mai 199719 mai 1997

    Quels sont les derniers comptes de EUROBELL (IDA) LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour EUROBELL (IDA) LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 mai 2016

    État du capital au 20 mai 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    legacy

    94 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT1

    legacy

    3 pagesGUARANTEE1

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 mai 2015

    État du capital au 19 mai 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    legacy

    92 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT1

    legacy

    3 pagesGUARANTEE1

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 mai 2014

    État du capital au 21 mai 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Nomination de Mine Ozkan Hifzi en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Caroline Withers en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Robert Dominic Dunn en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Robert Gale en tant que directeur

    1 pagesTM01

    legacy

    97 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT1

    legacy

    3 pagesGUARANTEE1

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Caroline Bernadette Elizabeth Withers le 14 mars 2013

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Joanne Tillbrook en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Caroline Bernadette Elizabeth Withers en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Qui sont les dirigeants de EUROBELL (IDA) LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JAMES, Gillian Elizabeth
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Secrétaire
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    151020900001
    DUNN, Robert Dominic
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Administrateur
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish179134020002
    HIFZI, Mine Ozkan
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Administrateur
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish182167230001
    BLANKFIELD, Andrew Morris
    14 Hall Place Gardens
    AL1 3SP St. Albans
    Hertfordshire
    Secrétaire
    14 Hall Place Gardens
    AL1 3SP St. Albans
    Hertfordshire
    British81192720001
    BURNS, Clive
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    Secrétaire
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    British71073800001
    RICHARDS, Allan
    12 Thistle Grove
    SW10 9RZ London
    Secrétaire
    12 Thistle Grove
    SW10 9RZ London
    British55171600002
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Secrétaire
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    BARNES, Richard Nigel
    42 Victoria Avenue
    KT6 5DW Surbiton
    Surrey
    Administrateur
    42 Victoria Avenue
    KT6 5DW Surbiton
    Surrey
    British5240090001
    BLANKFIELD, Andrew Morris
    14 Hall Place Gardens
    AL1 3SP St. Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    14 Hall Place Gardens
    AL1 3SP St. Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish81192720001
    BURDICK, Charles James
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    Administrateur
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    British-American52311710004
    COOK, Stephen Sands
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    Administrateur
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    British73000530008
    CORNISH, Alan Stewart
    Aspens 42 Oxenden Wood Road
    BR6 6HP Orpington
    Kent
    Administrateur
    Aspens 42 Oxenden Wood Road
    BR6 6HP Orpington
    Kent
    British2757380001
    FREEDMAN, Philip Zachary
    98 Highgate Hill
    N6 5HE London
    Administrateur
    98 Highgate Hill
    N6 5HE London
    American73535900001
    GALE, Robert Charles
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Administrateur
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish96956740001
    HOFMANN, Klaus
    Meineckestrasse 46
    D40474 Duesseldorf
    Germany
    Administrateur
    Meineckestrasse 46
    D40474 Duesseldorf
    Germany
    German69180580001
    LAQUA, Markus Josef
    23 Hatchlands
    RH12 5JX Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    23 Hatchlands
    RH12 5JX Horsham
    West Sussex
    German43624140002
    MACKENZIE, Robert Mario
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Administrateur
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish47785600002
    MAGOWAN, Andrew Colin
    East India House
    109/117 Middlesex Street
    E1 7JF London
    Administrateur
    East India House
    109/117 Middlesex Street
    E1 7JF London
    British75379710001
    SMITH, Neil Reynolds
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    British79956240002
    STENHAM, Anthony William Paul
    4 The Grove
    Highgate
    N6 6JU London
    Administrateur
    4 The Grove
    Highgate
    N6 6JU London
    British8281170001
    THOMAS, David
    Middle Barn Lower Barns Farm
    Wall
    NE6 4DR Hexham
    Northumberland
    Administrateur
    Middle Barn Lower Barns Farm
    Wall
    NE6 4DR Hexham
    Northumberland
    British35030200001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Administrateur
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Administrateur
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    WITHERS, Caroline Bernadette Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Administrateur
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish140137570002
    VIRGIN MEDIA DIRECTORS LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Administrateur
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107430002
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Administrateur
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002

    EUROBELL (IDA) LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite debenture
    Créé le 29 juin 2010
    Livré le 08 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due to the chargee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transactions
    • 08 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 12 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Confirmation deed
    Créé le 15 avr. 2010
    Livré le 04 mai 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transactions
    • 04 mai 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 12 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite debenture
    Créé le 19 janv. 2010
    Livré le 22 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transactions
    • 22 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 12 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite debenture
    Créé le 19 janv. 2010
    Livré le 22 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transactions
    • 22 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 28 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite debenture
    Créé le 03 mars 2006
    Livré le 10 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 10 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 mai 2010Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 24 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite debenture
    Créé le 21 déc. 2004
    Livré le 23 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 23 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    New composite guarantee and debenture
    Créé le 14 juil. 2004
    Livré le 28 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A first equitable charge over the stocks, shares and any other interests of the company in front row television LTD, any tcn entity or any joint venture. A first floating charge over all other present and future assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cibc World Markets PLC in Its Capacity as New Security Trustee for the New Beneficiaries
    Transactions
    • 28 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    New composite guarantee and debenture
    Créé le 14 juil. 2004
    Livré le 22 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A first equitable charge over the stocks, shares and any other interests of tcn in front row television LTD, any tcn entity or any joint venture. A first floating charge over all other present and future assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cibc World Markets PLC in Its Capacity as New Security Trustee for the New Beneficiaries
    Transactions
    • 22 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A supplemental deed made between (1) eurobell (holdings) limited, (2) telewest communications networks limited, (3) cibc worlds markets PLC and (4) telewest communications PLC pursuant to which, inter alia the company accedes to a guarantee and debenture dated 16 march 2001 and
    Créé le 15 févr. 2002
    Livré le 21 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any of the chargors to the security trustee and any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right, title and/or interest in all stocks and shares whatsoever whether marketable or otherwise and all other interests (including but not limited to loan capital) including all allotments, rights, benefits and advantages whatsoever at any time accruing. The loan stock, all amounts payable, the intercompany loan. By way of floating charge all its property, assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future, other than any property or assets from time to time charged by way of fixed charge or assignment above.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cibc World Markets PLC (In Its Capacity as Security Trustee for Thebeneficiaries)
    Transactions
    • 21 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0