GARETH JAMES PHARMACY LIMITED

GARETH JAMES PHARMACY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGARETH JAMES PHARMACY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03375701
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GARETH JAMES PHARMACY LIMITED ?

    • (5231) /

    Où se situe GARETH JAMES PHARMACY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Sandbrook Park, Sandbrook Way
    Rochdale
    OL11 1RY Lancashire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de GARETH JAMES PHARMACY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au10 janv. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour GARETH JAMES PHARMACY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Anthony John Smith le 31 juil. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Branson Nuttall le 31 juil. 2010

    2 pagesCH01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 mai 2010

    État du capital au 20 mai 2010

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cessation de la nomination de Peter Batty en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Caroline Jane Sellers en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Katherine Eldridge en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 10 janv. 2009

    20 pagesAA

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    Comptes annuels établis au 12 janv. 2008

    20 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2007

    23 pagesAA

    legacy

    6 pages288a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages225

    Qui sont les dirigeants de GARETH JAMES PHARMACY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SELLERS, Caroline Jane
    Sandbrook Park, Sandbrook Way
    Rochdale
    OL11 1RY Lancashire
    Secrétaire
    Sandbrook Park, Sandbrook Way
    Rochdale
    OL11 1RY Lancashire
    150066860001
    NUTTALL, John Branson
    13 Green Villa Park
    SK9 6EJ Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    13 Green Villa Park
    SK9 6EJ Wilmslow
    Cheshire
    United KingdomBritish44967060002
    SMITH, Anthony John
    Three Mile Lane
    ST5 5HW Whitmore
    Hillside Lodge
    Staffordshire
    Administrateur
    Three Mile Lane
    ST5 5HW Whitmore
    Hillside Lodge
    Staffordshire
    EnglandBritish137558680001
    ELDRIDGE, Katherine Elizabeth
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    Secrétaire
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    British110230860001
    HARRISON, Irene Lesley
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    Secrétaire désigné
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    British900003790001
    JAMES, Susan Laura
    The Old Vicarage Vicarage Drive
    Pontardawe
    SA8 4PB Swansea
    Secrétaire
    The Old Vicarage Vicarage Drive
    Pontardawe
    SA8 4PB Swansea
    British53038800002
    MATHIAS, Clive Stanley
    1 The Mews
    St Nicholas Road
    CF62 6QX Barry
    Vale Of Glamorgan
    Secrétaire
    1 The Mews
    St Nicholas Road
    CF62 6QX Barry
    Vale Of Glamorgan
    British90539780002
    SELLERS, Caroline Jane
    1 Gale Close
    Littleborough
    OL15 9EJ Rochdale
    Lancashire
    Secrétaire
    1 Gale Close
    Littleborough
    OL15 9EJ Rochdale
    Lancashire
    British45801060004
    BATTY, Peter David
    Church Hill
    Ingham
    LN1 2YE Lincoln
    2
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Church Hill
    Ingham
    LN1 2YE Lincoln
    2
    Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandBritish140380300001
    BRAITHWAITE, Neil
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    Administrateur
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    EnglandBritish87486660004
    BROCKLEHURST, Jonathan David
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Administrateur
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British49108820004
    DUGGAN, Rachel
    18 Mentone Road
    Heaton Moor
    SK4 4HF Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    18 Mentone Road
    Heaton Moor
    SK4 4HF Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish122443900001
    FARQUHAR, Gordon Hillocks
    3 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    Administrateur
    3 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    United KingdomBritish125645380001
    JAMES, Gareth Lloyd
    The Old Vicarage Vicarage Drive
    Pontardawe
    SA8 4PB Swansea
    Administrateur
    The Old Vicarage Vicarage Drive
    Pontardawe
    SA8 4PB Swansea
    WalesBritish58499330001
    JAMES, Susan Laura
    The Old Vicarage Vicarage Drive
    Pontardawe
    SA8 4PB Swansea
    Administrateur
    The Old Vicarage Vicarage Drive
    Pontardawe
    SA8 4PB Swansea
    WalesBritish53038800002
    JONES, Ailsa Michelle
    16 Northways
    CF36 5LB Porthcawl
    Mid Glamorgan
    Administrateur
    16 Northways
    CF36 5LB Porthcawl
    Mid Glamorgan
    British116649550001
    WANLISS, Mike
    2 Ridgeview
    Off Scott Close
    LE16 7GJ Market Harborough
    Leicestershire
    Administrateur
    2 Ridgeview
    Off Scott Close
    LE16 7GJ Market Harborough
    Leicestershire
    British120288660001
    BUSINESS INFORMATION RESEARCH & REPORTING LIMITED
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    Administrateur désigné
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    900005500001
    FARMERS FABRICATIONS LIMITED
    Eos House
    Weston Square
    CF63 2YF Barry
    South Glamorgan
    Administrateur
    Eos House
    Weston Square
    CF63 2YF Barry
    South Glamorgan
    44551190001

    GARETH JAMES PHARMACY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 30 juin 2006
    Livré le 01 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 01 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 15 août 2005
    Livré le 30 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a the pharmacy llanybydder dyfed. Fixed and floating charge over undertaking property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Medical Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 30 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of keyman life policy intination dated 17/03/04 and
    Créé le 11 mars 2004
    Livré le 18 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Company: scottish provident, policy number: 12184958, date: 16/04/2003, sum: £1,300,000, life assured: gareth lloyd james/susan laura james together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of keyman life policy intimation dated 17/03/04 and
    Créé le 11 mars 2004
    Livré le 18 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Company: scottish provident, policy number: 12182633, sum: £2800000, life assured: gareth lloyd james/susan laura james together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 10 juin 2003
    Livré le 13 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 juin 2003
    Livré le 13 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Peglers building, 1-5 pontardulais road, gorseinon, swansea t/n CYM39275. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 juin 2003
    Livré le 13 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    2 alexandra road, gorseinon t/n WA930290. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 juin 2003
    Livré le 13 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    47/49 charles street, milford haven t/n CYM15196. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 mai 2002
    Livré le 11 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    L/H property the new pharmacy gowerton surgery mill street gowerton swansea.
    Personnes ayant droit
    • Medical Finance (Bristol) Limited
    Transactions
    • 11 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 06 juin 2001
    Livré le 09 juin 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H peglers building 1-5 pontardulais road gorseinon swansea and all rights attached or appurtenant to it and all buildings fixtures fititngs plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Medical Finance (Bristol) Limited
    Transactions
    • 09 juin 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 nov. 2000
    Livré le 25 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property 2 alexandra road gorseinon swansea 150-152 station road llanelli 33 terrace road aberystwyth fixed and floating charges over the undertaking and all property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Medical Finance (Retail) Limited
    Transactions
    • 25 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 oct. 2000
    Livré le 14 oct. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/H property k/a 47/49 charles street milford haven pembrokshire fixed charge all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Medical Finance (Retail) Limited
    Transactions
    • 14 oct. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 nov. 1999
    Livré le 18 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 33 terrace road aberystwyth any goodwill of any business. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Medical Finance (Retail) Limited
    Transactions
    • 18 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 nov. 1999
    Livré le 18 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 2 alexandra road gorseinon swansea any goodwill of any business. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Medical Finance (Retail) Limited
    Transactions
    • 18 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 nov. 1999
    Livré le 18 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 150/152 station road llanelli any goodwill of any business. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Medical Finance (Retail) Limited
    Transactions
    • 18 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 14 oct. 1999
    Livré le 26 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Medical Finance (Retail) Limited
    Transactions
    • 26 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 nov. 1998
    Livré le 04 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aah Pharmaceuticals Limited
    Transactions
    • 04 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage deed
    Créé le 01 juin 1998
    Livré le 04 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/Hold property being 33 terrace rd,aberystwyth. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 04 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 mars 1998
    Livré le 18 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 18 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 27 juin 1997
    Livré le 18 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of first floating charge all its undertaking and property both present and future including its uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 18 juil. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0