TRIANGLE TRAINING LTD.

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTRIANGLE TRAINING LTD.
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03375741
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TRIANGLE TRAINING LTD. ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe TRIANGLE TRAINING LTD. ?

    Adresse du siège social
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de TRIANGLE TRAINING LTD. ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le26 juin 2022
    Date d'échéance des prochains comptes20 sept. 2023
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2021

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour TRIANGLE TRAINING LTD. ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au11 oct. 2023
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation25 oct. 2023
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au11 oct. 2022
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour TRIANGLE TRAINING LTD. ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 sept. 2025

    50 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 sept. 2024

    68 pagesLIQ03

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 20 sept. 2023

    LRESEX

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    4 pages600

    Déclaration des affaires

    11 pagesLIQ02

    Changement d'adresse du siège social de Capital Tower 91 Waterloo Road London SE1 8RT England à Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL le 15 sept. 2023

    1 pagesAD01

    Période comptable précédente raccourcie du 27 juin 2022 au 26 juin 2022

    1 pagesAA01

    Période comptable précédente raccourcie du 28 juin 2022 au 27 juin 2022

    1 pagesAA01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2021

    20 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 oct. 2022 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    État du capital au 25 juil. 2022

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Période comptable précédente raccourcie du 29 juin 2021 au 28 juin 2021

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Richard Vose en tant que directeur le 15 déc. 2021

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Christopher James Edwards en tant qu'administrateur le 14 déc. 2021

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 11 oct. 2021 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Période comptable précédente prolongée du 29 déc. 2020 au 29 juin 2021

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Julie Helen Downman en tant que directeur le 23 juin 2021

    1 pagesTM01

    Nomination de Jeremy Mark White en tant qu'administrateur le 22 juin 2021

    2 pagesAP01

    Nomination de Richard Vose en tant qu'administrateur le 22 juin 2021

    2 pagesAP01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2019

    19 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 30 déc. 2019 au 29 déc. 2019

    1 pagesAA01

    Modification des détails de Triangle Training Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 déc. 2020

    2 pagesPSC05

    Qui sont les dirigeants de TRIANGLE TRAINING LTD. ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EDWARDS, Christopher James
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    England
    Administrateur
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    England
    EnglandBritish279311610001
    WHITE, Jeremy Mark
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    England
    Administrateur
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    England
    EnglandBritish284537740001
    BROWN, Steven David Russell
    17 Woodlands Lane
    Quarndon
    DE22 5JU Derby
    Secrétaire
    17 Woodlands Lane
    Quarndon
    DE22 5JU Derby
    British102159320002
    DOBSON, Joanna
    Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    12
    United Kingdom
    Secrétaire
    Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    12
    United Kingdom
    171990960001
    HOLMES, Adrian Russell
    Bank Green House
    Fox Lane
    S18 7WG Millthorpe
    Derbyshire
    Secrétaire
    Bank Green House
    Fox Lane
    S18 7WG Millthorpe
    Derbyshire
    British65428120002
    KEEN, Richard
    George Road
    Erdington
    B23 7RZ Birmingham
    395
    England
    Secrétaire
    George Road
    Erdington
    B23 7RZ Birmingham
    395
    England
    193517860001
    LAVELLE, Andrea
    Tranby Top Street
    Northend
    CV47 2TN Leamington Spa
    Warwickshire
    Secrétaire
    Tranby Top Street
    Northend
    CV47 2TN Leamington Spa
    Warwickshire
    British52937060002
    LAVELLE, John
    3 Top Street, North End
    CV47 2TN Southam
    Warwickshire
    Secrétaire
    3 Top Street, North End
    CV47 2TN Southam
    Warwickshire
    British108144950001
    SHEPHERD, Richard John
    Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    12
    United Kingdom
    Secrétaire
    Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    12
    United Kingdom
    155908680001
    THURSTON, Mark Stuart
    Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    12
    United Kingdom
    Secrétaire
    Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    12
    United Kingdom
    160364270001
    CHETTLEBURGH INTERNATIONAL LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    Secrétaire désigné
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000860001
    BEALE, Colin James
    41
    Frythe Close
    CV8 2SY Kenilworth
    Warwickshire
    Administrateur
    41
    Frythe Close
    CV8 2SY Kenilworth
    Warwickshire
    British59870170001
    BENTON, Anthony Henley
    Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    12
    United Kingdom
    Administrateur
    Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    12
    United Kingdom
    United KingdomBritish75082440001
    BROWN, Steven David Russell
    17 Woodlands Lane
    Quarndon
    DE22 5JU Derby
    Administrateur
    17 Woodlands Lane
    Quarndon
    DE22 5JU Derby
    United KingdomBritish102159320002
    DOBSON, Joanna
    Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    12
    United Kingdom
    Administrateur
    Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    12
    United Kingdom
    EnglandBritish172594880001
    DOWNMAN, Julie Helen
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    Administrateur
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    EnglandBritish242317210001
    FREED, Gavin Mark
    Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    12
    United Kingdom
    Administrateur
    Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    12
    United Kingdom
    United KingdomBritish111438990002
    GOWENS, Laura
    12 Europa View, Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Interserve Learning & Employment
    South Yorkshire
    England
    Administrateur
    12 Europa View, Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Interserve Learning & Employment
    South Yorkshire
    England
    EnglandBritish252238640001
    HOBDAY, Carolyne Angela
    6 Foxglove Close
    CV23 0TS Rugby
    Warwickshire
    Administrateur
    6 Foxglove Close
    CV23 0TS Rugby
    Warwickshire
    EnglandBritish126137970001
    HOLMES, Adrian Russell
    Bank Green House
    Fox Lane
    S18 7WG Millthorpe
    Derbyshire
    Administrateur
    Bank Green House
    Fox Lane
    S18 7WG Millthorpe
    Derbyshire
    EnglandBritish65428120002
    JONES, Stephen Michael
    Ruscombe Park
    Twyford
    RG10 9JU Reading
    Interserve House
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Ruscombe Park
    Twyford
    RG10 9JU Reading
    Interserve House
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish88268290002
    LAVELLE, Andrea
    Tranby Top Street
    Northend
    CV47 2TN Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    Tranby Top Street
    Northend
    CV47 2TN Leamington Spa
    Warwickshire
    British52937060002
    LAVELLE, John
    3 Top Street, North End
    CV47 2TN Southam
    Warwickshire
    Administrateur
    3 Top Street, North End
    CV47 2TN Southam
    Warwickshire
    British108144950001
    MONDON, Andrew Paul
    Ruscombe
    RG10 9JU Reading
    Interserve House Ruscombe Park
    England
    Administrateur
    Ruscombe
    RG10 9JU Reading
    Interserve House Ruscombe Park
    England
    EnglandBritish113109530002
    PEEL, Christopher Mark Victor
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    12 Europa View
    England
    Administrateur
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    12 Europa View
    England
    EnglandBritish200256180001
    RIGBY, Michelle
    Wortley Bank Farm
    Bank Lane, Wortley
    S35 7DG Sheffield
    Administrateur
    Wortley Bank Farm
    Bank Lane, Wortley
    S35 7DG Sheffield
    EnglandBritish116792190002
    SCOTT, Gregg Michael
    12 Europa View, Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Interserve
    United Kingdom
    Administrateur
    12 Europa View, Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Interserve
    United Kingdom
    EnglandBritish264322020001
    SHEPHERD, Richard John
    Wollescote Drive
    Hillfield
    B91 3YN Solihull
    17
    West Midlands
    United Kingdom
    Administrateur
    Wollescote Drive
    Hillfield
    B91 3YN Solihull
    17
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish83963520003
    THOMAS, Yvonne Mary
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    Administrateur
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    EnglandBritish194601710002
    THURSTON, Mark Stuart
    Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    12
    United Kingdom
    Administrateur
    Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    12
    United Kingdom
    EnglandBritish114940320003
    VINCE, Robert David
    George Road
    Erdington
    B23 7RZ Birmingham
    395
    England
    Administrateur
    George Road
    Erdington
    B23 7RZ Birmingham
    395
    England
    EnglandBritish69268810003
    VOSE, Richard
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    Administrateur
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    United KingdomBritish284537890001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TRIANGLE TRAINING LTD. ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Triangle Training Holdings Limited
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    06 avr. 2016
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUk Company Law
    Lieu d'enregistrementEngland
    Numéro d'enregistrement05588523
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    TRIANGLE TRAINING LTD. a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 27 févr. 2020
    Livré le 15 mars 2020
    En cours
    Brève description
    N/A.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Glas Trust Corporation Limited (As Security Agent and Trustee for the Secured Parties)
    Transactions
    • 15 mars 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 14 oct. 2019
    Livré le 23 oct. 2019
    En cours
    Brève description
    N/A.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Glas Trust Corporation Limited
    Transactions
    • 23 oct. 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 15 mars 2019
    Livré le 19 mars 2019
    En cours
    Brève description
    N/A.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Glas Trust Corporation Limited
    Transactions
    • 19 mars 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 01 mai 2018
    Livré le 03 mai 2018
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Not applicable.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Glas Trust Corporation Limited (As Security Agent & Trustee for Secured Parties)
    Transactions
    • 03 mai 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 03 avr. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 23 juil. 2012
    Livré le 02 août 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ares Capital Europe Limited
    Transactions
    • 02 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 26 nov. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 24 mars 2010
    Livré le 07 avr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ares Capital Europe Limited
    Transactions
    • 07 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 26 nov. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 31 oct. 2007
    Livré le 16 nov. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 16 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee & debenture
    Créé le 31 oct. 2007
    Livré le 13 nov. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Sovereign Capital Partners LLP (As Security Trustee)
    Transactions
    • 13 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Accession deed
    Créé le 31 oct. 2007
    Livré le 13 nov. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Sovereign Capital Partners LLP (The Security Trustee)
    Transactions
    • 13 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 11 avr. 2007
    Livré le 18 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all the property, undertaking and assets of the company.
    Personnes ayant droit
    • Triangle Training Holdings Limited
    Transactions
    • 18 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    TRIANGLE TRAINING LTD. a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 sept. 2023Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Mark James Tobias Banfield
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Victoria Hatton
    8th Floor Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    8th Floor Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    David Robert Baxendale
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0