THE WALTHAM ABBEY ROYAL GUNPOWDER MILLS COMPANY LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | THE WALTHAM ABBEY ROYAL GUNPOWDER MILLS COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social |
| Numéro de société | 03376501 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe THE WALTHAM ABBEY ROYAL GUNPOWDER MILLS COMPANY LIMITED ?
| Adresse du siège social | Beaulieu Drive Waltham Abbey EN9 1JY Essex United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de THE WALTHAM ABBEY ROYAL GUNPOWDER MILLS COMPANY LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 30 juin 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 mars 2027 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour THE WALTHAM ABBEY ROYAL GUNPOWDER MILLS COMPANY LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 21 mai 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 04 juin 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 21 mai 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour THE WALTHAM ABBEY ROYAL GUNPOWDER MILLS COMPANY LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2025 | 28 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 mai 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Statuts | 20 pages | MA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Grahame Seymour Browne en tant que directeur le 31 déc. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2024 au 30 juin 2025 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Column House London Road Shrewsbury Shropshire SY2 6NN United Kingdom à Beaulieu Drive Waltham Abbey Essex EN9 1JY le 13 nov. 2024 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher Mark Pemberton en tant que directeur le 31 oct. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Rosanna Lawes en tant que directeur le 31 oct. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2023 | 31 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jill Amador en tant que directeur le 22 juin 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 mai 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Geoffrey Hooper en tant que directeur le 10 mars 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Len Stuart en tant que directeur le 29 nov. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Peter Darrell Egan en tant que directeur le 11 oct. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2022 | 26 pages | AA | ||||||||||
Statuts | 20 pages | MA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 mai 2023 avec mises à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew David Macdonald en tant que directeur le 31 mai 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jeremy John Brown en tant que directeur le 09 mai 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Ms Rosanna Lawes en tant qu'administrateur le 29 mars 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr Andrew David Macdonald en tant qu'administrateur le 29 mars 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Peter Darrell Egan en tant qu'administrateur le 27 févr. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Suite 407 Grosvenor House Central Park Telford TF2 9TW England à Column House London Road Shrewsbury Shropshire SY2 6NN le 05 oct. 2022 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de THE WALTHAM ABBEY ROYAL GUNPOWDER MILLS COMPANY LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAXTER, Fiona Elizabeth Ann | Administrateur | Waltham Abbey EN9 1JY Essex Beaulieu Drive United Kingdom | United Kingdom | British | 175985510001 | |||||
| MCIVER, Andrew Ross | Administrateur | Waltham Abbey EN9 1JY Essex Beaulieu Drive United Kingdom | United Kingdom | British | 69125840004 | |||||
| RICHARDSON, James Andrew | Administrateur | Waltham Abbey EN9 1JY Essex Beaulieu Drive United Kingdom | United Kingdom | British | 193813560001 | |||||
| DAVIES, Ian | Secrétaire | 66 High Street Dawley TF4 2HD Telford Shropshire | 200932520001 | |||||||
| LOWE, Michael John | Secrétaire | The Manor House Admaston TF5 0AD Telford Shropshire | British | 2729860001 | ||||||
| HALCO SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | 8-10 New Fetter Lane EC4A 1RS London | 42871950001 | |||||||
| ABBEY, Ian Edward, Councillor | Administrateur | 35 Oak Piece North Weald Bassett CM16 6JH Epping Essex | British | 45351230001 | ||||||
| ADAMS, Peter Robin | Administrateur | 2 Highview Close IG10 3EG Loughton | Great Britain | British | 57421510002 | |||||
| AMADOR, Jill | Administrateur | London Road SY2 6NN Shrewsbury Column House Shropshire United Kingdom | England | Irish | 245832080001 | |||||
| AMADOR, Jill | Administrateur | 66 High Street Dawley TF4 2HD Telford Shropshire | England | Irish | 245832080001 | |||||
| BARNARD, Paul Robert | Administrateur | Grosvenor House Central Park TF2 9TW Telford Suite 407 England | England | British | 282007990001 | |||||
| BOURNE, Lance Cedric | Administrateur | Trinity Lane EN8 7EW Waltham Cross 137 Hertfordshire England | Britain | British | 200973050001 | |||||
| BOWLES, John Huw | Administrateur | 9 Humber Road SE3 7LS London | England | British | 96154420001 | |||||
| BROWN, Jeremy John | Administrateur | London Road SY2 6NN Shrewsbury Column House Shropshire United Kingdom | England | British | 284749460001 | |||||
| BROWNE, Grahame Seymour | Administrateur | Waltham Abbey EN9 1JY Essex Beaulieu Drive United Kingdom | United Kingdom | British | 205076270001 | |||||
| BROWNE, Grahame Seymour | Administrateur | Heron Close IG9 5TP Buckhurst Hill 8 Essex England | United Kingdom | British | 205076270001 | |||||
| CROCKER, Alan Godfrey, Dr | Administrateur | 6 Burwood Close Merrow GU1 2SB Guildford Surrey | United Kingdom | British | 15839570001 | |||||
| CROSBY, Anthony Barry | Administrateur | 66 High Street Dawley TF4 2HD Telford Shropshire | England | British | 183109980001 | |||||
| CROWE, Frances Mary | Administrateur | Little Goddards Hunsdon Road, Widford SG12 8SE Ware Hertfordshire | British | 70706650001 | ||||||
| DENHAM, Richard Antony | Administrateur | 35 Winters Way EN9 3HR Waltham Abbey Essex | British | 76192780001 | ||||||
| EARLE, James Christopher Reginald St John | Administrateur | 1 Temple Close Duxford CB2 4PX Cambridge | United Kingdom | British | 175935710001 | |||||
| EDEN, Keith Leslie | Administrateur | 6 Friends Walk CB11 4EA Saffron Walden Essex | United Kingdom | British | 53429470001 | |||||
| EGAN, Peter Darrell | Administrateur | London Road SY2 6NN Shrewsbury Column House Shropshire United Kingdom | England | British | 193634760001 | |||||
| EYRE, Karen Fiona | Administrateur | 14 Norfolk Road NW8 6HE London | British | 50065100001 | ||||||
| FREEMAN, Jennifer Margaret, Dr | Administrateur | Kensington Gate W8 5NA London 8 England | England | British | 43387130001 | |||||
| GAMBLE, Terence Joel | Administrateur | Penman Close AL2 3DJ St. Albans 7 Hertfordshire England | United Kingdom | British | 45396650001 | |||||
| GOODWIN, Timothy Robert Thomas | Administrateur | 33 Kent Avenue Ealing W13 8BE London | England | British | 97546570001 | |||||
| GREEN, Norma Lea | Administrateur | Highfields Wellington Hill High Beech IG10 4AH Loughton Essex | British | 51580310001 | ||||||
| HARVEY, Brian | Administrateur | Dark Lane Cheshunt EN7 5ED Waltham Cross 3 Hertfordshire England | England | British | 185586290001 | |||||
| HOOPER, Geoffrey, Dr | Administrateur | Beaulieu Drive EN9 1JY Waltham Abbey Royal Gunpowder Mills England | England | British | 57156930001 | |||||
| HOOPER, Geoffrey, Dr | Administrateur | 17 Stonyshotts EN9 3DF Waltham Abbey Essex | England | British | 57156930001 | |||||
| IVES, Martin Victor | Administrateur | Liberty Close SG13 8JY Hertford 34 England | England | British | 206055210001 | |||||
| JONES, Philippa Whiston | Administrateur | 97a Moray Road N4 3LB London | England | British | 57157500001 | |||||
| KENT, Douglas David | Administrateur | Wendens Ambo CB11 4JL Saffron Walden The Outspan Essex England | England | British | 128394080001 | |||||
| KNAPP, Trevor | Administrateur | 32 Hawthorne Road BR1 2HH Bickley Kent | England | British | 57156890001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur THE WALTHAM ABBEY ROYAL GUNPOWDER MILLS COMPANY LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
|---|---|---|---|
| Dr Jennifer Margaret Freeman | 01 juin 2016 | 66 High Street Dawley TF4 2HD Telford Shropshire | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour THE WALTHAM ABBEY ROYAL GUNPOWDER MILLS COMPANY LIMITED ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 12 août 2021 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0