EVERLOGIC GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEVERLOGIC GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03379484
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EVERLOGIC GROUP LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe EVERLOGIC GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Azzurri House Walsall Business Park, Walsall Road
    Aldridge
    WS9 0RB Walsall
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de EVERLOGIC GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour EVERLOGIC GROUP LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour EVERLOGIC GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    GAZ2(A)

    Cessation de la nomination de Vim Vithaldas en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Stephen Andrews en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 mai 2014

    État du capital au 29 mai 2014

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2013

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Nomination de Mr Andrew Neil Marshall en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de John Whitehead en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Timothy Maynard en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Martin St Quinton en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2012

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Nomination de Mr Vim Vithaldas en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2011

    1 pagesAA

    Nomination de Mr John Whitehead en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2010

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de Mr Timothy Sven Maynard en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01
    Annotations
    DateAnnotation
    09 juin 2011This document is a duplicate of the AP01 registered on 11/05/2011

    Nomination de Mr Timothy Sven Maynard en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01
    Annotations
    DateAnnotation
    09 juin 2011This document is a duplicate of the AP01 registered on 11/05/2011

    Nomination de Mr Timothy Sven Maynard en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2009

    1 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Qui sont les dirigeants de EVERLOGIC GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ANDREWS, Stephen
    Walsall Business Park, Walsall Road
    Aldridge
    WS9 0RB Walsall
    Azzurri House
    Administrateur
    Walsall Business Park, Walsall Road
    Aldridge
    WS9 0RB Walsall
    Azzurri House
    United KingdomBritish183587520001
    MARSHALL, Andrew Neil
    Walsall Business Park, Walsall Road
    Aldridge
    WS9 0RB Walsall
    Azzurri House
    United Kingdom
    Administrateur
    Walsall Business Park, Walsall Road
    Aldridge
    WS9 0RB Walsall
    Azzurri House
    United Kingdom
    United KingdomBritish115143470001
    BHARDWAJ, Ashok
    47-49 Green Lane
    HA6 3AE Northwood
    Middlesex
    Secrétaire désigné
    47-49 Green Lane
    HA6 3AE Northwood
    Middlesex
    British900010640001
    CLAXTON, Peter
    93 Churchill Avenue
    HU16 5NJ Cottingham
    North Humberside
    Secrétaire
    93 Churchill Avenue
    HU16 5NJ Cottingham
    North Humberside
    British38329190001
    DOLTON, Stephen
    99 Cumnor Hill
    OX2 9JR Oxford
    Secrétaire
    99 Cumnor Hill
    OX2 9JR Oxford
    British70990450005
    FLETCHER, Julie Karen
    18 Manor Close
    SN6 8AE Shrivenham
    Wiltshire
    Secrétaire
    18 Manor Close
    SN6 8AE Shrivenham
    Wiltshire
    British123046330001
    GLANVILLE, Ian
    Park Farm
    Bramley Road, Silchester
    RG7 2LJ Reading
    Secrétaire
    Park Farm
    Bramley Road, Silchester
    RG7 2LJ Reading
    British162008180001
    LORD, Darren
    18 The Grange
    Carlton
    WF3 3TR Wakefield
    Secrétaire
    18 The Grange
    Carlton
    WF3 3TR Wakefield
    British81219520003
    ATHERTON, Rodney Frederick
    Paddock House 24 Station Road
    Nafferton
    YO25 4LT Driffield
    North Humberside
    Administrateur
    Paddock House 24 Station Road
    Nafferton
    YO25 4LT Driffield
    North Humberside
    EnglandBritish63235600001
    CLARK, Stephen Thomas
    1 Hobstones Barn
    Smithy Lane
    BB8 7LZ Foulridge
    Lancashire
    Administrateur
    1 Hobstones Barn
    Smithy Lane
    BB8 7LZ Foulridge
    Lancashire
    EnglandBritish81433780001
    CLAXTON, Peter
    93 Churchill Avenue
    HU16 5NJ Cottingham
    North Humberside
    Administrateur
    93 Churchill Avenue
    HU16 5NJ Cottingham
    North Humberside
    British38329190001
    DOLTON, Stephen
    99 Cumnor Hill
    OX2 9JR Oxford
    Administrateur
    99 Cumnor Hill
    OX2 9JR Oxford
    British70990450005
    GLANVILLE, Ian
    Park Farm
    Bramley Road, Silchester
    RG7 2LJ Reading
    Administrateur
    Park Farm
    Bramley Road, Silchester
    RG7 2LJ Reading
    United KingdomBritish162008180001
    LORD, Darren
    18 The Grange
    Carlton
    WF3 3TR Wakefield
    Administrateur
    18 The Grange
    Carlton
    WF3 3TR Wakefield
    EnglandBritish81219520003
    MATTHEWS, Andrew Raymond
    Paddock Wood Mill Lane
    Elloughton
    HU15 1JL Brough
    East Yorkshire
    Administrateur
    Paddock Wood Mill Lane
    Elloughton
    HU15 1JL Brough
    East Yorkshire
    United KingdomBritish50435380001
    MAYNARD, Timothy Sven
    Walsall Business Park, Walsall Road
    Aldridge
    WS9 0RB Walsall
    Azzurri House
    United Kingdom
    Administrateur
    Walsall Business Park, Walsall Road
    Aldridge
    WS9 0RB Walsall
    Azzurri House
    United Kingdom
    United KingdomBritish150961040001
    PARKINSON, Philip Dennis
    37 Church Street
    North Cave
    HU15 2LJ Brough
    East Yorkshire
    Administrateur
    37 Church Street
    North Cave
    HU15 2LJ Brough
    East Yorkshire
    EnglandBritish54367750001
    SMITH, David
    12 Whispering Meadows
    Sykehouse
    DN14 9AY Goole
    Administrateur
    12 Whispering Meadows
    Sykehouse
    DN14 9AY Goole
    British61948500005
    ST QUINTON, Martin George
    Netherton Farm House
    Netherton
    SP11 0DR Andover
    Hampshire
    Administrateur
    Netherton Farm House
    Netherton
    SP11 0DR Andover
    Hampshire
    EnglandBritish58961460002
    VITHALDAS, Vim
    Walsall Business Park, Walsall Road
    Aldridge
    WS9 0RB Walsall
    Azzurri House
    United Kingdom
    Administrateur
    Walsall Business Park, Walsall Road
    Aldridge
    WS9 0RB Walsall
    Azzurri House
    United Kingdom
    United KingdomBritish59433340003
    WALLIS, Malcolm Stuart
    2 Stone Croft Court Farrer Lane
    Oulton
    LS26 8GA Leeds
    Yorkshire
    Administrateur
    2 Stone Croft Court Farrer Lane
    Oulton
    LS26 8GA Leeds
    Yorkshire
    United KingdomBritish81433350001
    WHITEHEAD, John
    Walsall Business Park, Walsall Road
    Aldridge
    WS9 0RB Walsall
    Azzurri House
    United Kingdom
    Administrateur
    Walsall Business Park, Walsall Road
    Aldridge
    WS9 0RB Walsall
    Azzurri House
    United Kingdom
    EnglandBritish168999520001
    WINGFIELD, Richard Alan
    1 Town Farm Close
    Thame
    OX9 2DA Oxford
    Administrateur
    1 Town Farm Close
    Thame
    OX9 2DA Oxford
    EnglandBritish76932830002
    BHARDWAJ CORPORATE SERVICES LIMITED
    47-49 Green Lane
    HA6 3AE Northwood
    Middlesex
    Administrateur désigné
    47-49 Green Lane
    HA6 3AE Northwood
    Middlesex
    900010630001

    EVERLOGIC GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee and debenture
    Créé le 11 mars 2004
    Livré le 19 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities due or to become due from each obligor to the chargee and the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Agent and Trustee for Itself and for Eachof the Secured Parties
    Transactions
    • 19 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 déc. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 25 oct. 1999
    Livré le 01 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 01 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 mars 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0