EVERLOGIC GROUP LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | EVERLOGIC GROUP LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03379484 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe EVERLOGIC GROUP LIMITED ?
| Adresse du siège social | Azzurri House Walsall Business Park, Walsall Road Aldridge WS9 0RB Walsall |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de EVERLOGIC GROUP LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2013 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour EVERLOGIC GROUP LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour EVERLOGIC GROUP LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | GAZ2(A) | |||||||||||
Cessation de la nomination de Vim Vithaldas en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Stephen Andrews en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2013 | 1 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Mr Andrew Neil Marshall en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Whitehead en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Timothy Maynard en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Martin St Quinton en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2012 | 1 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Mr Vim Vithaldas en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2011 | 1 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr John Whitehead en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2010 | 1 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Mr Timothy Sven Maynard en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr Timothy Sven Maynard en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr Timothy Sven Maynard en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2009 | 1 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de EVERLOGIC GROUP LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREWS, Stephen | Administrateur | Walsall Business Park, Walsall Road Aldridge WS9 0RB Walsall Azzurri House | United Kingdom | British | 183587520001 | |||||
| MARSHALL, Andrew Neil | Administrateur | Walsall Business Park, Walsall Road Aldridge WS9 0RB Walsall Azzurri House United Kingdom | United Kingdom | British | 115143470001 | |||||
| BHARDWAJ, Ashok | Secrétaire désigné | 47-49 Green Lane HA6 3AE Northwood Middlesex | British | 900010640001 | ||||||
| CLAXTON, Peter | Secrétaire | 93 Churchill Avenue HU16 5NJ Cottingham North Humberside | British | 38329190001 | ||||||
| DOLTON, Stephen | Secrétaire | 99 Cumnor Hill OX2 9JR Oxford | British | 70990450005 | ||||||
| FLETCHER, Julie Karen | Secrétaire | 18 Manor Close SN6 8AE Shrivenham Wiltshire | British | 123046330001 | ||||||
| GLANVILLE, Ian | Secrétaire | Park Farm Bramley Road, Silchester RG7 2LJ Reading | British | 162008180001 | ||||||
| LORD, Darren | Secrétaire | 18 The Grange Carlton WF3 3TR Wakefield | British | 81219520003 | ||||||
| ATHERTON, Rodney Frederick | Administrateur | Paddock House 24 Station Road Nafferton YO25 4LT Driffield North Humberside | England | British | 63235600001 | |||||
| CLARK, Stephen Thomas | Administrateur | 1 Hobstones Barn Smithy Lane BB8 7LZ Foulridge Lancashire | England | British | 81433780001 | |||||
| CLAXTON, Peter | Administrateur | 93 Churchill Avenue HU16 5NJ Cottingham North Humberside | British | 38329190001 | ||||||
| DOLTON, Stephen | Administrateur | 99 Cumnor Hill OX2 9JR Oxford | British | 70990450005 | ||||||
| GLANVILLE, Ian | Administrateur | Park Farm Bramley Road, Silchester RG7 2LJ Reading | United Kingdom | British | 162008180001 | |||||
| LORD, Darren | Administrateur | 18 The Grange Carlton WF3 3TR Wakefield | England | British | 81219520003 | |||||
| MATTHEWS, Andrew Raymond | Administrateur | Paddock Wood Mill Lane Elloughton HU15 1JL Brough East Yorkshire | United Kingdom | British | 50435380001 | |||||
| MAYNARD, Timothy Sven | Administrateur | Walsall Business Park, Walsall Road Aldridge WS9 0RB Walsall Azzurri House United Kingdom | United Kingdom | British | 150961040001 | |||||
| PARKINSON, Philip Dennis | Administrateur | 37 Church Street North Cave HU15 2LJ Brough East Yorkshire | England | British | 54367750001 | |||||
| SMITH, David | Administrateur | 12 Whispering Meadows Sykehouse DN14 9AY Goole | British | 61948500005 | ||||||
| ST QUINTON, Martin George | Administrateur | Netherton Farm House Netherton SP11 0DR Andover Hampshire | England | British | 58961460002 | |||||
| VITHALDAS, Vim | Administrateur | Walsall Business Park, Walsall Road Aldridge WS9 0RB Walsall Azzurri House United Kingdom | United Kingdom | British | 59433340003 | |||||
| WALLIS, Malcolm Stuart | Administrateur | 2 Stone Croft Court Farrer Lane Oulton LS26 8GA Leeds Yorkshire | United Kingdom | British | 81433350001 | |||||
| WHITEHEAD, John | Administrateur | Walsall Business Park, Walsall Road Aldridge WS9 0RB Walsall Azzurri House United Kingdom | England | British | 168999520001 | |||||
| WINGFIELD, Richard Alan | Administrateur | 1 Town Farm Close Thame OX9 2DA Oxford | England | British | 76932830002 | |||||
| BHARDWAJ CORPORATE SERVICES LIMITED | Administrateur désigné | 47-49 Green Lane HA6 3AE Northwood Middlesex | 900010630001 |
EVERLOGIC GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee and debenture | Créé le 11 mars 2004 Livré le 19 mars 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All obligations and liabilities due or to become due from each obligor to the chargee and the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 25 oct. 1999 Livré le 01 nov. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0