MISYS GROUP HOLDINGS LIMITED

MISYS GROUP HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMISYS GROUP HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03379662
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MISYS GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe MISYS GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    One Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MISYS GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BROKERCARE LIMITED20 août 199720 août 1997
    CHANCEFLAME LIMITED02 juin 199702 juin 1997

    Quels sont les derniers comptes de MISYS GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mai 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour MISYS GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    14 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 nov. 2016

    14 pages4.68

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 27 nov. 2015

    LRESSP

    legacy

    60 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 7

    5 pagesMR05

    État du capital au 07 août 2015

    • Capital: GBP 126,727.00
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel share prem a/c 29/07/2015
    RES13

    Nomination de Mr Johannes Jacobus Olivier en tant qu'administrateur le 20 juil. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew Paul Woodward en tant que directeur le 20 juil. 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 juin 2015

    État du capital au 05 juin 2015

    • Capital: GBP 126,727
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mai 2014

    14 pagesAA

    Nomination de Mr Andrew Paul Woodward en tant qu'administrateur le 05 sept. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Sanjay Patel en tant que directeur le 28 août 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr John Van Harken en tant qu'administrateur le 31 juil. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Elizabeth Mary Collins en tant que directeur le 31 juil. 2014

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 juin 2014

    État du capital au 04 juin 2014

    • Capital: GBP 126,727
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mai 2013

    13 pagesAA

    Cessation de la nomination de Misys Corporate Director Limited en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de MISYS GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HARKEN, John Van
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomAmerican183654340001
    HOMER, Thomas Edward Timothy
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish146605570001
    OLIVIER, Johannes Jacobus
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomSouth African199516920001
    BRAIN, Sarah Elizabeth Highton
    The Street Warninglid
    Haywards Heath
    RH17 5SZ West Sussex
    No 1 Portwood Cottage
    England
    England
    Secrétaire
    The Street Warninglid
    Haywards Heath
    RH17 5SZ West Sussex
    No 1 Portwood Cottage
    England
    England
    146627810001
    DURRANT, Zoe Vivienne
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    Secrétaire
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    British68141090001
    GRAY, Elizabeth Andrea
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    Secrétaire
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    British98035800001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Secrétaire
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    British136433670001
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    Secrétaire
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    WILSON, Kevin Michael
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    10
    Secrétaire
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    10
    Other138835080001
    MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Secrétaire
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement07036299
    170448630001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BROOK, Anthony Richard
    Crofftau
    Cantref
    LD3 8LL Brecon
    Powys
    Administrateur
    Crofftau
    Cantref
    LD3 8LL Brecon
    Powys
    British44545910001
    COLLINS, Elizabeth Mary
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish180406780001
    COOK, John
    Barnside
    GL20 7BP Tredington
    Gloucestershire
    Administrateur
    Barnside
    GL20 7BP Tredington
    Gloucestershire
    EnglandBritish86208160001
    COPELAND, Philip Robert
    Crofton Sheldon Road
    Ickford
    HP18 9HY Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Crofton Sheldon Road
    Ickford
    HP18 9HY Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritish44954570001
    DUDLEY, John Mark
    Eagle Way
    Hampton Vale
    PE7 8EA Peterborough
    124
    England
    England
    Administrateur
    Eagle Way
    Hampton Vale
    PE7 8EA Peterborough
    124
    England
    England
    UkBritish101918420001
    EVANS, Howard
    Charlton Park House
    Charlton Park Gate
    GL53 7DJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Charlton Park House
    Charlton Park Gate
    GL53 7DJ Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish56986700002
    EVANS, Robert Owen
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    Administrateur
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    British57011000002
    FARRIMOND, Nicholas Brian
    The Avenue
    Watford
    WD17 4NU Hertfordshire
    51
    England
    England
    Administrateur
    The Avenue
    Watford
    WD17 4NU Hertfordshire
    51
    England
    England
    EnglandBritish75357260001
    FLETCHER, Leonard James
    Long Cottage
    Compton Road
    RG20 7LH East Ilsley
    Berkshire
    Administrateur
    Long Cottage
    Compton Road
    RG20 7LH East Ilsley
    Berkshire
    EnglandBritish74416740002
    FULLELOVE, Glyn William
    Brook House
    Spout Lane Tansley
    DE4 5FH Matlock
    Derbyshire
    Administrateur
    Brook House
    Spout Lane Tansley
    DE4 5FH Matlock
    Derbyshire
    United KingdomBritish73026210001
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Administrateur
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish61733920001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish136433670001
    HAWKES, Joanna Marageret
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish136214800001
    JOHNSON, Russell Alan
    Worcester Avenue
    Kings Hill West Malling
    ME19 4FL Kent
    14
    England
    United Kingdom
    Administrateur
    Worcester Avenue
    Kings Hill West Malling
    ME19 4FL Kent
    14
    England
    United Kingdom
    British130788060001
    LEWIS, Richard
    Karisaro 50 Slade Avenue
    Lyppard Hanford
    WR4 0HB Worcester
    Administrateur
    Karisaro 50 Slade Avenue
    Lyppard Hanford
    WR4 0HB Worcester
    British71966870001
    MARSH, Howard Alexander David
    33 Rogers Way
    CV34 6PY Warwick
    Administrateur
    33 Rogers Way
    CV34 6PY Warwick
    United KingdomBritish111938620001
    MARTIN, Ivan
    90 Ranelagh Road
    Ealing
    W5 5RP London
    Administrateur
    90 Ranelagh Road
    Ealing
    W5 5RP London
    EnglandBritish123233030001
    MCMAHON, Jasper Philip
    Ground Floor Flat
    33 Warrington Crescent
    W9 1EJ London
    Administrateur
    Ground Floor Flat
    33 Warrington Crescent
    W9 1EJ London
    EnglandBritish45080250003
    O'LEARY, Michael Kevin
    Greenwood
    Wichenford
    WR6 6YB Worcester
    Worcestershire
    Administrateur
    Greenwood
    Wichenford
    WR6 6YB Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish129193560001
    PATEL, Bijal Mahendra
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    One
    Administrateur
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    One
    United KingdomBritish161424380001
    PATEL, Sanjay Surendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish147221810001
    SIMPSON, David Alan
    Draycott Cottage
    Draycott Lane
    WR5 3NY Kempsey
    Worcestershire
    Administrateur
    Draycott Cottage
    Draycott Lane
    WR5 3NY Kempsey
    Worcestershire
    EnglandBritish80817560001
    SUSSENS, John Gilbert
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    Administrateur
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    EnglandBritish1442450002
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Administrateur
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001

    MISYS GROUP HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 27 juil. 2012
    Livré le 06 août 2012
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All property,all the shares and investments and all corresponding related rights first fixed charge all other interests in any property and the benefit of all other agreements relating to land,all of its right title and interest in the charged intellectual property see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse Ag,Cayman Islands Branch
    Transactions
    • 06 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 12 sept. 2015L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off (olso) dated 3RD july 1995
    Créé le 19 déc. 2006
    Livré le 29 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 29 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995
    Créé le 17 sept. 2003
    Livré le 01 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 01 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995
    Créé le 11 sept. 2003
    Livré le 24 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 24 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and
    Créé le 29 juil. 2003
    Livré le 12 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 12 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 (the letter)
    Créé le 23 oct. 2002
    Livré le 13 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 13 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and
    Créé le 09 mai 2002
    Livré le 25 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 25 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    MISYS GROUP HOLDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    13 déc. 2017Dissolved on
    27 nov. 2015Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Hugh Francis Jesseman
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London
    practitioner
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0