SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED

SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03379663
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED ?

    • Autres activités d'édition de logiciels (58290) / Information et communication

    Où se situe SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    One Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DEMOABLE LIMITED02 juin 199702 juin 1997

    Quels sont les derniers comptes de SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mai 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    11 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 mai 2016

    28 pages4.68

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 27 mai 2015

    LRESSP

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 7

    5 pagesMR05

    Comptes annuels établis au 31 mai 2014

    15 pagesAA

    Nomination de Mr Andrew Paul Woodward en tant qu'administrateur le 05 sept. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Sanjay Patel en tant que directeur le 28 août 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr John Van Harken en tant qu'administrateur le 31 juil. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Elizabeth Mary Collins en tant que directeur le 31 juil. 2014

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 juin 2014

    État du capital au 04 juin 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mai 2013

    14 pagesAA

    Cessation de la nomination de Misys Corporate Director Limited en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Joanna Hawkes en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Misys Corporate Secretary Limited en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Sanjay Patel en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Elizabeth Mary Collins en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Bijal Patel en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Joanna Marageret Hawkes en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Bijal Mahendra Patel le 20 mai 2013

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 mai 2012

    15 pagesAA

    Nomination de Mr Bijal Mahendra Patel en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HARKEN, John Van
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomAmerican183654340001
    HOMER, Thomas Edward Timothy
    Maidenhead Road
    Cookham
    SL6 9DF Berkshire
    Rosedale
    United Kingdom
    Administrateur
    Maidenhead Road
    Cookham
    SL6 9DF Berkshire
    Rosedale
    United Kingdom
    EnglandBritish146605570001
    WOODWARD, Andrew Paul
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish100885620001
    BRAIN, Sarah Elizabeth Highton
    Portwood Cottage
    The Street Warninglid, Haywards Heath
    RH17 5SZ West Sussex
    No 1
    England
    Secrétaire
    Portwood Cottage
    The Street Warninglid, Haywards Heath
    RH17 5SZ West Sussex
    No 1
    England
    British147213550001
    DURRANT, Zoe Vivienne
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    Secrétaire
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    British68141090001
    GRAY, Elizabeth Andrea
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    Secrétaire
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    British98035800001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Secrétaire
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    British136433670001
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    Secrétaire
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    WILSON, Kevin Michael
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    10
    Secrétaire
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    10
    Other138835080001
    MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Secrétaire
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement07036299
    170449400001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BAULME, Herve
    23 Avenue De L'Obersavtoire
    75006 Paris
    France
    Administrateur
    23 Avenue De L'Obersavtoire
    75006 Paris
    France
    French98573020001
    BELLOUARD, Xavier Henry Marie
    14 Abinger Road
    W4 1EL London
    Administrateur
    14 Abinger Road
    W4 1EL London
    LondonFrench53755850003
    BRIODY, Dermot
    Palm Drive
    The Redhill Peninsula
    Tai Tam
    House 34
    Hong Kong
    Hong Kong
    Administrateur
    Palm Drive
    The Redhill Peninsula
    Tai Tam
    House 34
    Hong Kong
    Hong Kong
    Irish128090250001
    CAPPELL, Mark Stanley
    Woodruff
    South Munstead Lane
    GU8 4AG Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Woodruff
    South Munstead Lane
    GU8 4AG Godalming
    Surrey
    United KingdomAmerican103054980001
    COLLINS, Elizabeth Mary
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish180406780001
    DE FONTENAY, Jean
    440 East 62nd Street
    NY 10021 New York
    Usa
    Administrateur
    440 East 62nd Street
    NY 10021 New York
    Usa
    French53755800002
    EVANS, Robert Owen
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    Administrateur
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    British57011000002
    FARRIMOND, Nicholas Brian
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish75357260001
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Administrateur
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish61733920001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish136433670001
    HAWKES, Joanna Marageret
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish136214800001
    HELSBY, Frank Peter
    27 Park Green
    Great Bookham
    KT23 3NL Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    27 Park Green
    Great Bookham
    KT23 3NL Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritish34237710003
    HUGHES, Kevin Gerard
    31 Cromwell Avenue
    Billericay
    CM12 OAG Essex
    Administrateur
    31 Cromwell Avenue
    Billericay
    CM12 OAG Essex
    United KingdomBritish173214140001
    HUGHES, Kevin Gerard
    12 Linkdale
    CM12 9QW Billericay
    Essex
    Administrateur
    12 Linkdale
    CM12 9QW Billericay
    Essex
    British2659400001
    MARTIN, Ivan
    90 Ranelagh Road
    Ealing
    W5 5RP London
    Administrateur
    90 Ranelagh Road
    Ealing
    W5 5RP London
    EnglandBritish123233030001
    MOLONEY, Barry William
    Little Chantry Bull Lane
    SL9 8RH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Little Chantry Bull Lane
    SL9 8RH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish48187880001
    PATEL, Bijal Mahendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish161424380001
    PATEL, Sanjay Surendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish147221810001
    SARGANT, Murray
    10d, Block D, Grenville House
    No1 Magazine Gap Road
    Hong Kong
    Hong Kong
    Administrateur
    10d, Block D, Grenville House
    No1 Magazine Gap Road
    Hong Kong
    Hong Kong
    Australian113006830001
    SOAMES, Rupert Christopher
    Ridge Barn Farm House
    Ridgebarn Lane, Cuddington
    HP18 0AE Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Ridge Barn Farm House
    Ridgebarn Lane, Cuddington
    HP18 0AE Aylesbury
    Buckinghamshire
    ScotlandBritish86671010001
    STONELL, Keith Robert
    Tars Platt
    Cookham Dean Common
    SL6 9PY Cookham Dean
    Berkshire
    Administrateur
    Tars Platt
    Cookham Dean Common
    SL6 9PY Cookham Dean
    Berkshire
    EnglandBritish151579610001
    SUSSENS, John Gilbert
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    Administrateur
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    EnglandBritish1442450002
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Administrateur
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 27 juil. 2012
    Livré le 06 août 2012
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All property,all the shares and investments and all corresponding related rights first fixed charge all other interests in any property and the benefit of all other agreements relating to land,all of its right title and interest in the charged intellectual property see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse Ag,Cayman Islands Branch
    Transactions
    • 06 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 mai 2015L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off (olso) dated 3RD july 1995
    Créé le 19 déc. 2006
    Livré le 29 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 29 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995
    Créé le 17 sept. 2003
    Livré le 01 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 01 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995
    Créé le 11 sept. 2003
    Livré le 24 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 24 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and
    Créé le 29 juil. 2003
    Livré le 12 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 12 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 (the letter)
    Créé le 23 oct. 2002
    Livré le 13 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 13 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995
    Créé le 09 mai 2002
    Livré le 25 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 25 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    06 oct. 2017Dissolved on
    27 mai 2015Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Hugh Francis Jesseman
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London
    practitioner
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0