OAK FM LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéOAK FM LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03380201
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de OAK FM LIMITED ?

    • Radiodiffusion (60100) / Information et communication

    Où se situe OAK FM LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Kendal House
    41 Scotland Street
    S3 7BS Sheffield
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de OAK FM LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour OAK FM LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    27 pagesAM10

    Avis de transition de l'administration à la dissolution

    26 pagesAM23

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    27 pagesAM10

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    6 pages2.16B

    Résultat de la réunion des créanciers

    46 pages2.23B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    45 pages2.17B

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Changement d'adresse du siège social de 72 Wilson Street Derby DE1 1PL England à Kendal House 41 Scotland Street Sheffield S3 7BS le 23 nov. 2016

    2 pagesAD01

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Stephen Orchard en tant que directeur le 01 août 2015

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ralph Mitchell Bernard en tant que directeur le 01 août 2015

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Wendy Monica Pallot en tant que directeur le 01 août 2015

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Wendy Pallot en tant que secrétaire le 01 août 2015

    2 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de The Ideas Centre Holly Farm Business Park Honiley Kenilworth Warwickshire CV8 1NP à 72 Wilson Street Derby DE1 1PL le 23 janv. 2016

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Wendy Monica Pallot en tant que directeur le 01 août 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Stephen Orchard en tant que directeur le 01 août 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ralph Mitchell Bernard en tant que directeur le 01 août 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Wendy Pallot en tant que secrétaire le 01 août 2015

    1 pagesTM02

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2014

    6 pagesAA

    Nomination de Mr Paul Daniel Caplin en tant qu'administrateur le 01 août 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Stephen Tarpey en tant qu'administrateur le 01 août 2015

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 juin 2015

    État du capital au 15 juin 2015

    • Capital: GBP 297,000
    SH01

    Qui sont les dirigeants de OAK FM LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CAPLIN, Paul Daniel
    Shobnall Road
    DE14 2BB Burton-On-Trent
    8
    Staffordshire
    England
    Administrateur
    Shobnall Road
    DE14 2BB Burton-On-Trent
    8
    Staffordshire
    England
    EnglandBritish187909480001
    TARPEY, Stephen Stephen
    Shobnall Road
    DE14 2BB Burton-On-Trent
    8
    Staffordshire
    England
    Administrateur
    Shobnall Road
    DE14 2BB Burton-On-Trent
    8
    Staffordshire
    England
    United KingdomBritish201348620001
    ALLY, Bibi Rahima
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    Secrétaire
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    British38963210003
    CURTIS, Robert Scott
    73 Tiverton Road
    LE11 2RU Loughborough
    Leicestershire
    Secrétaire
    73 Tiverton Road
    LE11 2RU Loughborough
    Leicestershire
    British36414500002
    LOCKWOOD, John Trevor
    2 South Street
    Barrow-Upon-Soar
    LE12 8LZ Loughborough
    Leicestershire
    Secrétaire
    2 South Street
    Barrow-Upon-Soar
    LE12 8LZ Loughborough
    Leicestershire
    British9159330001
    PALLOT, Wendy
    Holly Farm Business Park
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    The Ideas Centre
    Warwickshire
    Secrétaire
    Holly Farm Business Park
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    The Ideas Centre
    Warwickshire
    169952460001
    RAWLINS, Nicholas David
    Badgers Holt Friesthorpe Road
    Buslingthorpe
    LN3 5AQ Lincoln
    Secrétaire
    Badgers Holt Friesthorpe Road
    Buslingthorpe
    LN3 5AQ Lincoln
    British44972500001
    SWANSTON, Andrew John
    12 Croft Road
    CA3 9AQ Carlisle
    Cumbria
    Secrétaire
    12 Croft Road
    CA3 9AQ Carlisle
    Cumbria
    British145364760001
    WATERHOUSE, Michael
    53 Spruce Avenue
    LA1 5LB Lancaster
    Secrétaire
    53 Spruce Avenue
    LA1 5LB Lancaster
    British24900900004
    BERNARD, Ralph Mitchell
    Holly Farm Business Park
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    The Ideas Centre
    Warwickshire
    Administrateur
    Holly Farm Business Park
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    The Ideas Centre
    Warwickshire
    EnglandBritish32493590003
    BETTON, Michael
    Hill House
    Barnes Lane, Wellingore
    LN5 0JB Lincoln
    Lincolnshire
    Administrateur
    Hill House
    Barnes Lane, Wellingore
    LN5 0JB Lincoln
    Lincolnshire
    United KingdomBritish31707450003
    BOND, Marc Daniel
    20 Alicia Close
    Cawston
    CV22 7GT Rugby
    Warwickshire
    Administrateur
    20 Alicia Close
    Cawston
    CV22 7GT Rugby
    Warwickshire
    British84852170001
    BURGESS, Robert Lawie Frederick
    Hall Flatt
    Scaleby
    CA6 4LE Carlisle
    Cumbria
    Administrateur
    Hall Flatt
    Scaleby
    CA6 4LE Carlisle
    Cumbria
    United KingdomBritish61711750001
    COLLETT, Brian
    254 Old Church Road
    Chingford
    E4 8BT London
    Administrateur
    254 Old Church Road
    Chingford
    E4 8BT London
    British32267100002
    CRAIG, Andrew Timms
    West Barn
    Manor Lane Oare
    RG18 9SB Hermitage
    Berkshire
    Administrateur
    West Barn
    Manor Lane Oare
    RG18 9SB Hermitage
    Berkshire
    EnglandBritish34714840003
    CURTIS, Robert Scott
    73 Tiverton Road
    LE11 2RU Loughborough
    Leicestershire
    Administrateur
    73 Tiverton Road
    LE11 2RU Loughborough
    Leicestershire
    British36414500002
    HAMMOND, Michael John
    25a Old Way
    Hathern
    LE12 5HN Loughborough
    Leicestershire
    Administrateur
    25a Old Way
    Hathern
    LE12 5HN Loughborough
    Leicestershire
    British66860170001
    HARPER, John Frederick
    5 Eden Close
    LE11 5RT Loughborough
    Leicestershire
    Administrateur
    5 Eden Close
    LE11 5RT Loughborough
    Leicestershire
    British62621340001
    HARWOOD, Jeffrey
    The Mount 14 Church Lane
    Coleby
    LN5 0AQ Lincoln
    Lincolnshire
    Administrateur
    The Mount 14 Church Lane
    Coleby
    LN5 0AQ Lincoln
    Lincolnshire
    United KingdomBritish57534730002
    HEWSON, Jonathan
    Ivy Cottage
    9 Park Road
    CV8 2GF Kenilworth
    Warwickshire
    Administrateur
    Ivy Cottage
    9 Park Road
    CV8 2GF Kenilworth
    Warwickshire
    British74013900002
    MARTIN, Margaret Grale
    The Brand Brand Hill
    Woodhouse Eaves
    LE12 8SS Loughborough
    Leicestershire
    Administrateur
    The Brand Brand Hill
    Woodhouse Eaves
    LE12 8SS Loughborough
    Leicestershire
    British55865130001
    MORTON, John David
    39 Sark Close
    Lowry Hill
    CA3 0DY Carlisle
    Cumbria
    Administrateur
    39 Sark Close
    Lowry Hill
    CA3 0DY Carlisle
    Cumbria
    United KingdomBritish1482950001
    OATES, Stephen Michael
    Cragg Bank
    Vicarage Lane
    LA6 1NW Burton-In-Kendal
    Lancashire
    Administrateur
    Cragg Bank
    Vicarage Lane
    LA6 1NW Burton-In-Kendal
    Lancashire
    British83498790001
    ORCHARD, Stephen
    Holly Farm Business Park
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    The Ideas Centre
    Warwickshire
    Administrateur
    Holly Farm Business Park
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    The Ideas Centre
    Warwickshire
    EnglandBritish46952160003
    PALLOT, Wendy Monica
    Holly Farm Business Park
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    The Ideas Centre
    Warwickshire
    Administrateur
    Holly Farm Business Park
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    The Ideas Centre
    Warwickshire
    United KingdomBritish74832570006
    PRINCE, Kelsall Ronnie Edward
    39 Wide Lane
    Hathern
    LE12 5LN Loughborough
    Leicestershire
    Administrateur
    39 Wide Lane
    Hathern
    LE12 5LN Loughborough
    Leicestershire
    British8172880001
    SWANSTON, Andrew John
    12 Croft Road
    CA3 9AQ Carlisle
    Cumbria
    Administrateur
    12 Croft Road
    CA3 9AQ Carlisle
    Cumbria
    EnglandBritish145364760001
    WAINE, David Michael
    54 Broad Oaks Road
    B91 1JB Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    54 Broad Oaks Road
    B91 1JB Solihull
    West Midlands
    British37293160001
    WATERHOUSE, Michael
    53 Spruce Avenue
    LA1 5LB Lancaster
    Administrateur
    53 Spruce Avenue
    LA1 5LB Lancaster
    British24900900004

    OAK FM LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 14 août 2012
    Livré le 16 août 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 16 août 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 18 nov. 2009
    Livré le 19 nov. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Advantage Transition Bridge Fund Limited
    Transactions
    • 19 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 05 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 24 janv. 2008
    Livré le 29 janv. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 29 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 avr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 13 déc. 1999
    Livré le 29 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    OAK FM LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    08 nov. 2016Administration started
    17 nov. 2017Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Gareth David Rusling
    Kendal House 41 Scotland Street
    S3 7BS Sheffield
    South Yorkshire
    practitioner
    Kendal House 41 Scotland Street
    S3 7BS Sheffield
    South Yorkshire
    Ashleigh William Fletcher
    Kendal House, 41 Scotland Street
    S3 7BS Sheffield
    South Yorkshire
    practitioner
    Kendal House, 41 Scotland Street
    S3 7BS Sheffield
    South Yorkshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0