VITAFLO (INTERNATIONAL) LIMITED

VITAFLO (INTERNATIONAL) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéVITAFLO (INTERNATIONAL) LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03380926
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de VITAFLO (INTERNATIONAL) LIMITED ?

    • Autres activités liées à la santé humaine (86900) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe VITAFLO (INTERNATIONAL) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Suite 1.11 South Harrington Building
    182 Sefton Street
    L3 4BQ Brunswick Business Park
    Liverpool
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de VITAFLO (INTERNATIONAL) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    NUTRACARE SYSTEMS LIMITED04 juin 199704 juin 1997

    Quels sont les derniers comptes de VITAFLO (INTERNATIONAL) LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour VITAFLO (INTERNATIONAL) LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au31 mai 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation14 juin 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au31 mai 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour VITAFLO (INTERNATIONAL) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2023

    39 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2022

    35 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2021

    36 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    35 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    31 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    27 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mrs Kate Montazeri en tant qu'administrateur le 28 nov. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Maura O'donnell en tant que directeur le 28 nov. 2018

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    27 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    25 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    25 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 juin 2016

    État du capital au 10 juin 2016

    • Capital: GBP 625,379
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Maura O'donnell le 30 sept. 2015

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    18 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 juin 2015

    État du capital au 03 juin 2015

    • Capital: GBP 625,379
    SH01

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    10 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    20 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de VITAFLO (INTERNATIONAL) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CHARLESWORTH, Caroline
    South Harrington Building
    182 Sefton Street
    L3 4BQ Brunswick Business Park
    Suite 1.11
    Liverpool
    Secrétaire
    South Harrington Building
    182 Sefton Street
    L3 4BQ Brunswick Business Park
    Suite 1.11
    Liverpool
    160295330001
    CHARLESWORTH, Caroline Francesca
    South Harrington Building
    182 Sefton Street
    L3 4BQ Brunswick Business Park
    Suite 1.11
    Liverpool
    Administrateur
    South Harrington Building
    182 Sefton Street
    L3 4BQ Brunswick Business Park
    Suite 1.11
    Liverpool
    United KingdomBritishDirector64567430002
    MONTAZERI, Kate Victoria
    South Harrington Building
    182 Sefton Street
    L3 4BQ Brunswick Business Park
    Suite 1.11
    Liverpool
    Administrateur
    South Harrington Building
    182 Sefton Street
    L3 4BQ Brunswick Business Park
    Suite 1.11
    Liverpool
    United KingdomBritishLegal Counsel And Director253280550001
    HEATON, Clare Lesley
    26 Turnpike Close
    LE16 7TJ Market Harborough
    Leicestershire
    Secrétaire
    26 Turnpike Close
    LE16 7TJ Market Harborough
    Leicestershire
    BritishChartered Accountant67690550003
    WATTS, Karen
    Victoria House South Road
    Waterloo
    L22 5PE Liverpool
    Merseyside
    Secrétaire
    Victoria House South Road
    Waterloo
    L22 5PE Liverpool
    Merseyside
    British57099580001
    C & M SECRETARIES LIMITED
    PO BOX 55
    7 Spa Road
    SE16 3QP London
    Secrétaire désigné
    PO BOX 55
    7 Spa Road
    SE16 3QP London
    900007640001
    MACNAB, William Thomas Don
    Darroch 15 Elder Road
    Killearn
    G63 9RX Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    Darroch 15 Elder Road
    Killearn
    G63 9RX Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritishCompany Director18956890001
    MCLACHLAN, Kenneth John
    25 Northfield Park
    KA30 8NZ Largs
    Ayrshire
    Administrateur
    25 Northfield Park
    KA30 8NZ Largs
    Ayrshire
    United KingdomBritishChartered Accountant53816210005
    MOBBS, Jeremy Bostock
    Meadow View Farm Crewe Lane South
    Crewe By Farndon
    CH3 6PH Chester
    Cheshire
    Administrateur
    Meadow View Farm Crewe Lane South
    Crewe By Farndon
    CH3 6PH Chester
    Cheshire
    BritishInvestment Manager60887280002
    O'DONNELL, Maura
    South Harrington Building
    182 Sefton Street
    L3 4BQ Brunswick Business Park
    Suite 1.11
    Liverpool
    Administrateur
    South Harrington Building
    182 Sefton Street
    L3 4BQ Brunswick Business Park
    Suite 1.11
    Liverpool
    EnglandBritishCompany Director63591610004
    PARTINGTON, Thomas Anthony
    293 South Ferry Quay
    L3 4EE Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    293 South Ferry Quay
    L3 4EE Liverpool
    Merseyside
    United KingdomBritishConsultant5571370002
    AFM NED'S LIMITED
    5th Floor
    Cunard Building Pier Head
    L3 1DS Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    5th Floor
    Cunard Building Pier Head
    L3 1DS Liverpool
    Merseyside
    81102390001
    C & M REGISTRARS LIMITED
    PO BOX 55
    7 Spa Road
    SE16 3QP London
    Administrateur désigné
    PO BOX 55
    7 Spa Road
    SE16 3QP London
    900007630001
    INNVOTEC MANAGERS LIMITED
    1 Castle Lane
    SW1E 6DR London
    Administrateur
    1 Castle Lane
    SW1E 6DR London
    70965110001
    MEDIFOOD SRI
    Via Balbi
    31 Int 1
    FOREIGN Genoa
    16126
    Italy
    Administrateur
    Via Balbi
    31 Int 1
    FOREIGN Genoa
    16126
    Italy
    95477160001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur VITAFLO (INTERNATIONAL) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Nestle Uk Ltd.
    Beehive Ring Road
    London Gatwick Airport
    RH6 0PA Gatwick
    1 City Place
    England
    06 avr. 2016
    Beehive Ring Road
    London Gatwick Airport
    RH6 0PA Gatwick
    1 City Place
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleEngland & Wales
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales Companies Registry
    Numéro d'enregistrement00051491
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    VITAFLO (INTERNATIONAL) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Memorandum of deposit
    Créé le 07 juil. 2008
    Livré le 12 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the present and future right title and interest of the depositor and all entitlements dividends,rights and other benefits in respect of each deposited security and each new security see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 12 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Pledge and security agreement
    Créé le 07 juil. 2008
    Livré le 12 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A security interest in and a right to set-off against the pledged collateral,the pledged interests see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 12 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Pledge over shares
    Créé le 07 juil. 2008
    Livré le 12 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A pledge over all of the shares see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 12 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 24 mai 2008
    Livré le 30 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Evelyn Bhatt, Clare Heaton, William Macnab, Maura O’Donnell, Thomas Anthony Partington, Susan Robinson, Mark Preizer (The Chargees)
    Transactions
    • 30 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 24 mai 2008
    Livré le 03 juin 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargees on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Merseyside Special Investment Venture Fund No.3 and Alliance Fund Managers Nominees Limited
    Transactions
    • 03 juin 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 24 mai 2008
    Livré le 03 juin 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 03 juin 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 déc. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Share pledge
    Créé le 24 mai 2008
    Livré le 03 juin 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right title and interest in the existing shares any further shares and the related rights derived therefrom. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 03 juin 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Créé le 10 nov. 2000
    Livré le 14 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 27 avr. 2000
    Livré le 04 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 04 mai 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 déc. 1998
    Livré le 02 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under and in relation to the debenture and in accordance with the terms of the agreement (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Merseyside Special Investment Mezzanine Fund Limited
    Transactions
    • 02 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0