A.E. SAFFER CHEMISTS LIMITED

A.E. SAFFER CHEMISTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéA.E. SAFFER CHEMISTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03385342
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de A.E. SAFFER CHEMISTS LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe A.E. SAFFER CHEMISTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o WELL
    Merchants Warehouse
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de A.E. SAFFER CHEMISTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BROOMCO (1295) LIMITED11 juin 199711 juin 1997

    Quels sont les derniers comptes de A.E. SAFFER CHEMISTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au11 janv. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour A.E. SAFFER CHEMISTS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour A.E. SAFFER CHEMISTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Changement d'adresse du siège social de 1 Angel Square Manchester M60 0AG à C/O Well Merchants Warehouse Castle Street Manchester M3 4LZ le 14 sept. 2015

    1 pagesAD01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 août 2015

    État du capital au 04 août 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré C/O Tlt Llp One Redcliff Street Bristol BS1 6TP

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à C/O Tlt Llp One Redcliff Street Bristol BS1 6TP

    1 pagesAD02

    Nomination de Miss Caroline Hilton en tant que secrétaire le 11 déc. 2014

    2 pagesAP03

    Période comptable actuelle prolongée du 11 janv. 2015 au 30 juin 2015

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Caroline Jane Sellers en tant que secrétaire le 30 sept. 2014

    1 pagesTM02

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Company business 11/08/2014
    RES13

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 août 2014

    État du capital au 04 août 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2014

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 août 2013

    État du capital après une attribution d'actions au 15 août 2013

    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2013

    3 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * New Century House Corporation Street Manchester M60 4ES* le 03 déc. 2012

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2012

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2011

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Anthony John Smith le 31 juil. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Branson Nuttall le 31 juil. 2010

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2010

    3 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de A.E. SAFFER CHEMISTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HILTON, Caroline
    c/o Well
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    Merchants Warehouse
    England
    Secrétaire
    c/o Well
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    Merchants Warehouse
    England
    193402920001
    NUTTALL, John Branson
    c/o Well
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    Merchants Warehouse
    England
    Administrateur
    c/o Well
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    Merchants Warehouse
    England
    United KingdomBritish44967060002
    SMITH, Anthony John
    c/o Well
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    Merchants Warehouse
    England
    Administrateur
    c/o Well
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    Merchants Warehouse
    England
    EnglandBritish137558680001
    ELDRIDGE, Katherine Elizabeth
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    Secrétaire
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    British110230860001
    JONES, Philip Robert
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    Secrétaire
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    English43686960001
    MARKS, Philip Louis Howard
    5 Wayside Crescent
    LS14 3BD Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    5 Wayside Crescent
    LS14 3BD Leeds
    West Yorkshire
    British55339760001
    SELLERS, Caroline Jane
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Secrétaire
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    150261920001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001
    UCL SECRETARY LIMITED
    United Co-Operatives Ltd
    Sandbrook House Sandbrook Way
    Rochdale
    Lancashire
    Secrétaire
    United Co-Operatives Ltd
    Sandbrook House Sandbrook Way
    Rochdale
    Lancashire
    110375350001
    BATTY, Peter David
    Church Hill
    Ingham
    LN1 2YE Lincoln
    2
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Church Hill
    Ingham
    LN1 2YE Lincoln
    2
    Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandBritish140380300001
    BROCKLEHURST, Jonathan David
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Administrateur
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British49108820004
    BROCKLEHURST, Jonathan David
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Administrateur
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British49108820004
    DAVIS, Estelle Denise
    41 The Mount
    LS17 7RH Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    41 The Mount
    LS17 7RH Leeds
    West Yorkshire
    British55339780001
    EVANS, Nia Haf
    6 Thorneyholme Drive
    WA16 8BT Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    6 Thorneyholme Drive
    WA16 8BT Knutsford
    Cheshire
    British85570730001
    FARQUHAR, Gordon Hillocks
    3 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    Administrateur
    3 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    United KingdomBritish125645380001
    JONES, Philip Robert
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    Administrateur
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    United KingdomEnglish43686960001
    MARKS, Peter Vincent
    The Old Barn Low House Farm
    Otley Road Eldwick
    BD16 3AZ Bingley
    West Yorkshire
    Administrateur
    The Old Barn Low House Farm
    Otley Road Eldwick
    BD16 3AZ Bingley
    West Yorkshire
    United KingdomBritish87486470001
    MARKS, Philip Louis Howard
    5 Wayside Crescent
    LS14 3BD Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    5 Wayside Crescent
    LS14 3BD Leeds
    West Yorkshire
    British55339760001
    MURRAY, James William Masterson
    30 Riversdale
    Woolston
    WA1 4PZ Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    30 Riversdale
    Woolston
    WA1 4PZ Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish106429280001
    NUTTALL, John Branson
    The Old Post Office Whitchurch Road
    Broomhall
    CW5 8BZ Nantwich
    Cheshire
    Administrateur
    The Old Post Office Whitchurch Road
    Broomhall
    CW5 8BZ Nantwich
    Cheshire
    British44967060001
    WATES, Martyn James
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish60114700001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003800001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001
    UCL DIRECTOR 1 LIMITED
    United Co-Operatives Ltd
    Sandbrook House Sandbrook Way
    Rochdale
    Lancashire
    Administrateur
    United Co-Operatives Ltd
    Sandbrook House Sandbrook Way
    Rochdale
    Lancashire
    110375270001

    A.E. SAFFER CHEMISTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage debenture
    Créé le 05 nov. 1997
    Livré le 12 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Legal mortgage over the f/h and l/h property of the company,including the property k/a 203 kirkstall lane,leeds and the proceeds of sale thereof together with all buildings,structures and fixtures from time to time thereon.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transactions
    • 12 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0