DIGITAL OFFICE SUPPLIES LTD.

DIGITAL OFFICE SUPPLIES LTD.

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDIGITAL OFFICE SUPPLIES LTD.
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03386388
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DIGITAL OFFICE SUPPLIES LTD. ?

    • Activités de photocopie, de préparation de documents et autres activités de soutien administratif spécialisées (82190) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe DIGITAL OFFICE SUPPLIES LTD. ?

    Adresse du siège social
    20 Trafalgar Way
    Bar Hill
    CB23 8SQ Cambridge
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de DIGITAL OFFICE SUPPLIES LTD. ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 sept. 2016
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2017
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour DIGITAL OFFICE SUPPLIES LTD. ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 juin 2016

    2 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 juin 2016

    État du capital au 17 juin 2016

    • Capital: GBP 1,050
    SH01

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Nomination de Mr David Campbell en tant que secrétaire le 30 oct. 2015

    2 pagesAP03

    Période comptable actuelle prolongée du 31 mars 2016 au 30 sept. 2016

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Anthony Benjamin Ford en tant que directeur le 30 oct. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Paul Bruce Derry en tant qu'administrateur le 30 oct. 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Mark Garius en tant qu'administrateur le 30 oct. 2015

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de 2nd Floor, Finance House 20/21 Aviation Way Southend on Sea Essex SS2 6UN à 20 Trafalgar Way Bar Hill Cambridge CB23 8SQ le 04 nov. 2015

    1 pagesAD01

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 juil. 2015

    État du capital au 08 juil. 2015

    • Capital: GBP 1,050
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2015

    8 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de C/O Barnes Roffe Llp Leytonstone House Hanbury Drive London E11 1GA à 2Nd Floor, Finance House 20/21 Aviation Way Southend on Sea Essex SS2 6UN le 16 févr. 2015

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2014

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 juin 2014

    État du capital au 12 juin 2014

    • Capital: GBP 1,050
    SH01

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 5

    2 pagesMR05

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2013

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    legacy

    6 pagesMG01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2012

    16 pagesAA

    legacy

    1 pagesSH20

    Qui sont les dirigeants de DIGITAL OFFICE SUPPLIES LTD. ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CAMPBELL, David
    Trafalgar Way
    Bar Hill
    CB23 8SQ Cambridge
    20
    England
    Secrétaire
    Trafalgar Way
    Bar Hill
    CB23 8SQ Cambridge
    20
    England
    202388930001
    DERRY, Paul Bruce
    Trafalgar Way
    Bar Hill
    CB23 8SQ Cambridge
    20
    England
    Administrateur
    Trafalgar Way
    Bar Hill
    CB23 8SQ Cambridge
    20
    England
    EnglandBritishCompany Director153131600002
    GARIUS, Mark
    Trafalgar Way
    Bar Hill
    CB23 8SQ Cambridge
    20
    England
    Administrateur
    Trafalgar Way
    Bar Hill
    CB23 8SQ Cambridge
    20
    England
    United KingdomSwiss,BritishDirector67448210001
    BATER, Richard James
    470 Sutton Road
    SS2 5PN Southend On Sea
    Essex
    Secrétaire
    470 Sutton Road
    SS2 5PN Southend On Sea
    Essex
    British55321500003
    HENSBY, Lucy Ann
    1a Post Office Cottages
    Halstead Road
    CO6 3QH Eight Ash Green
    Essex
    Secrétaire
    1a Post Office Cottages
    Halstead Road
    CO6 3QH Eight Ash Green
    Essex
    British86508100003
    KNIGHT, Toni Suzanne
    90a Bellhouse Lane
    SS9 4PQ Leigh On Sea
    Essex
    Secrétaire
    90a Bellhouse Lane
    SS9 4PQ Leigh On Sea
    Essex
    British64520590004
    ROBERTSON, Sheila Josephine
    276 Eastwood Road
    SS6 7LS Rayleigh
    Essex
    Secrétaire
    276 Eastwood Road
    SS6 7LS Rayleigh
    Essex
    BritishDirector Company Secretary4784580001
    SOPER, Steven Alan
    Rashleigh Court
    Horton Road Horton Kirby
    DA4 9BN Dartford
    Kent
    Secrétaire
    Rashleigh Court
    Horton Road Horton Kirby
    DA4 9BN Dartford
    Kent
    BritishAccountant105717820001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Secrétaire désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    BATER, Richard James
    146 Hainault Avenue
    SS0 9EX Westcliff On Sea
    Essex
    Administrateur
    146 Hainault Avenue
    SS0 9EX Westcliff On Sea
    Essex
    BritishAccountant55321500002
    FORD, Anthony Benjamin
    48 Gilhams Avenue
    SM7 1QR Banstead
    Surrey
    Administrateur
    48 Gilhams Avenue
    SM7 1QR Banstead
    Surrey
    EnglandBritishSalesman125413290001
    HENSBY, Adrian Trevor
    34 Temple Way
    SS6 9PP Rayleigh
    Essex
    Administrateur
    34 Temple Way
    SS6 9PP Rayleigh
    Essex
    United KingdomBritishDirector110016540002
    HENSBY, Lucy Ann
    Temple Way
    SS6 9PP Rayleigh
    34
    Essex
    Administrateur
    Temple Way
    SS6 9PP Rayleigh
    34
    Essex
    United KingdomBritishDirector86508100004
    LAWRENCE, Paul Andrew
    25 Watlington Road
    SS7 5DS Benfleet
    Essex
    Administrateur
    25 Watlington Road
    SS7 5DS Benfleet
    Essex
    BritishService Manager87791510001
    ROBERTSON, Alexander Clifford
    276 Eastwood Road
    SS6 7LS Rayleigh
    Essex
    Administrateur
    276 Eastwood Road
    SS6 7LS Rayleigh
    Essex
    United KingdomBritishDirector24291610001
    SOPER, Steven Alan
    Rashleigh Court
    Horton Road Horton Kirby
    DA4 9BN Dartford
    Kent
    Administrateur
    Rashleigh Court
    Horton Road Horton Kirby
    DA4 9BN Dartford
    Kent
    United KingdomBritishAccountant105717820001
    TURNBULL, Andrew Howard
    Yew Cottage Church Street
    Newport
    CB11 3RA Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    Yew Cottage Church Street
    Newport
    CB11 3RA Saffron Walden
    Essex
    BritishDirector16849010001
    WALLIS, Richard Owen
    77 Birchwood Avenue
    BR23PY Beckenham
    Kent
    Administrateur
    77 Birchwood Avenue
    BR23PY Beckenham
    Kent
    BritishSales Director69515430002
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Administrateur désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    DIGITAL OFFICE SUPPLIES LTD. a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Rent deposit deed
    Créé le 29 janv. 2013
    Livré le 01 févr. 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Its interest in the account and the deposit balance from time to time and all money withdrawn from the account.
    Personnes ayant droit
    • Segro Industrial Estates Limited
    Transactions
    • 01 févr. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 08 oct. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    All assets debenture
    Créé le 30 avr. 2012
    Livré le 02 mai 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 02 mai 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 11 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    All assets debenture
    Créé le 27 août 2008
    Livré le 29 août 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 29 août 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 oct. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Créé le 28 juil. 2005
    Livré le 29 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transactions
    • 29 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 04 mars 2014L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    • 26 oct. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 27 avr. 2005
    Livré le 29 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 29 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture deed
    Créé le 23 mai 2001
    Livré le 30 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 30 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 10 mai 2000
    Livré le 16 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance LTD
    Transactions
    • 16 mai 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 09 janv. 1998
    Livré le 23 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The whole and any part of the undertaking property and assets of the company.
    Personnes ayant droit
    • Canon (UK) Limited
    Transactions
    • 23 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0