IGROUP LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | IGROUP LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03389478 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe IGROUP LIMITED ?
| Adresse du siège social | No 1 Dorset Street SO15 2DP Southampton Hampshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de IGROUP LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 nov. 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour IGROUP LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Robert Henry King en tant que directeur le 01 oct. 2016 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 6 pages | 4.71 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Building 4 Hatters Lane Croxley Green Business Park Watford Hertfordshire WD18 8YF à No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP le 11 août 2016 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 2 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Manuel Uria-Fernandez en tant que directeur le 14 juin 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Richard William Bird en tant qu'administrateur le 14 juin 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 nov. 2015 | 6 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Manuel Uria-Fernandez le 17 déc. 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Mr Robert Henry King en tant qu'administrateur le 30 sept. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Steven Mark Pickering en tant que directeur le 11 sept. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Kalpna Shah en tant que secrétaire le 10 juil. 2015 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Fn Secretary Limited en tant que secrétaire le 10 juil. 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 juin 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 nov. 2014 | 8 pages | AA | ||||||||||
Divers Re sect 519 ca 2006 auditors resignation | 4 pages | MISC | ||||||||||
Divers Auditors resignation | 2 pages | MISC | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 juin 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 nov. 2013 | 11 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Manuel Uria-Fernandez le 10 sept. 2013 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Kimon De Ridder en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Steven Mark Pickering en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de IGROUP LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHAH, Kalpna | Secrétaire | Dorset Street SO15 2DP Southampton No 1 Hampshire | 199403660001 | |||||||
| BIRD, Richard William | Administrateur | Dorset Street SO15 2DP Southampton No 1 Hampshire | United Kingdom | British | 209298590001 | |||||
| BOGARD, Harvey Philip | Secrétaire | 90 Carlton Hill NW8 0ER London | British | 8542730001 | ||||||
| SHAH, Kalpna | Secrétaire | 18 Vicarage Road WD18 0EH Watford Hertfordshire | British | 80753870001 | ||||||
| FN SECRETARY LIMITED | Secrétaire | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | 88740300002 | |||||||
| RUTLAND SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Rutland House 148 Edmund Street B3 2JR Birmingham | 38851450001 | |||||||
| S&A SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Sidley & Austin Royal Exchange EC3V 3LE London | 49115520001 | |||||||
| AINSWORTH, Keith | Administrateur | 76 Howes Lane Finham CV3 6PJ Coventry Warwickshire | United Kingdom | British | 46161840001 | |||||
| BAKER, Robin Gregory | Administrateur | Doddinghurst Road CM15 9EH Brentwood Essex | United Kingdom | British | 35557610004 | |||||
| BELLORA, Michael Richard | Administrateur | Russet House 1a Latchmoor Avenue SL9 8LL Gerrards Cross Buckinghamshire | American | 98453650001 | ||||||
| BERRY, Duncan Gee | Administrateur | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 107695600022 | |||||
| BOAKES, Jeremy Edward | Administrateur | 41 Sherrards Park Road AL8 7LD Welwyn Garden City Herts | British | 106122240001 | ||||||
| BRENNAN, Peter | Administrateur | 10 Ardross Avenue HA6 3DS Northwood Middlesex | British | 84912240001 | ||||||
| BRESLAUER, Keith | Administrateur | 81 Elm Tree Road St Johns Wood NW8 9JX London | United Kingdom | American | 85096410001 | |||||
| CAMERON, Ewan Douglas | Administrateur | 13 Heathfield Gardens W4 4JU London | British | 122900270001 | ||||||
| CRICHTON, Susan Elizabeth | Administrateur | The Pheasantries Ley Hill HP5 3QR Chesham Buckinghamshire | England | British | 69358970001 | |||||
| DE RIDDER, Kimon Celicourt Macris, Dr | Administrateur | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131081660001 | |||||
| DEANE JOHNS, Simon Joshua | Administrateur | 61 Stanlake Road W12 7HG London | Australian | 80748330001 | ||||||
| DLUTOWSKI, Joseph Arthur | Administrateur | 13127 Silver Fox Lane Palm Beach Gardens Palm Beach County 33418 United States Of America | American | 66506120001 | ||||||
| ERBEY, William Charles | Administrateur | 110 Sunset Avenue Apartment 2b 3947 Palm Beach Florida 33480-3947 United Statesof America | American | 58072470001 | ||||||
| EVANS, Kellie Victoria | Administrateur | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 167417000001 | |||||
| FERGUSON, Ian George | Administrateur | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 133318850001 | |||||
| FLYNN, William John | Administrateur | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | British | 99330320002 | ||||||
| GARDEN, Robert James | Administrateur | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152764360001 | |||||
| GUNNIGLE, Clodagh | Administrateur | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | Irish | 138244630002 | |||||
| HARRIS, Jeffrey | Administrateur | 9 Northaw Place Coopers Lane EN6 4NQ Northaw Hertfordshire | American | 98233530002 | ||||||
| HARVEY, David | Administrateur | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 97086950001 | |||||
| HARVEY, John Alexander | Administrateur | Percevale 2 Mill Lane Blakedown DY10 3ND Kidderminster Worcestershire | British | 49929970001 | ||||||
| HARVEY, Richard John | Administrateur | 6 Heronsford West Hunsbury NN4 9XG Northampton Northamptonshire | British | 122892160001 | ||||||
| HUNKIN, Ricky David | Administrateur | 2 Hockeridge View Oakwood HP4 3NB Berkhamsted Hertfordshire | British | 115390900001 | ||||||
| JOHAR, Mandeep Singh | Administrateur | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | Indian | 127046380002 | |||||
| JOHNSON, Alec David | Administrateur | 12 The Witherings, Emerson Park RM11 2RA Hornchurch Essex | United Kingdom | British | 103446140001 | |||||
| KAGAN, Jeffrey Allan | Administrateur | 14 Norrice Lea N2 0RE London | Australian | 78535300001 | ||||||
| KING, Robert Henry | Administrateur | Dorset Street SO15 2DP Southampton No 1 Hampshire | United Kingdom | British | 201524530001 | |||||
| MILLWARD, Keith Roger | Administrateur | Le Marque Manor Close Penn HP10 8HZ High Wycombe Buckinghamshire | United Kingdom | British | 80388420001 |
IGROUP LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Security of shares agreement | Créé le 07 nov. 2000 Livré le 14 nov. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All obligations due or to become due from the obligor (as defined) to the chargee under or pursuant to the facility agreement (as defined) on any account whatsoever | |
Brèves mentions First fixed charge the charged portfolio,as defined, I.E.all dividends,interest and other monies payable and all benefits and proceeds thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Security over shares agreement | Créé le 27 juil. 2000 Livré le 02 août 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All obligations owing to the secured party by the obligor under or pursuant to the facility agreement whether present or future actual or contingent (and whether incurred by the obligor alone or jointly and whether as principal or surety or in some other capacity) | |
Brèves mentions The chargor charges by way of first fixed charge the charged portfolio. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Security over shares agreement | Créé le 29 juin 2000 Livré le 11 juil. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the facility agreement | |
Brèves mentions All of the shares in the share capital of igroup 4 limited, all dividends, interest and other monies payable in respect of the shares. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
IGROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0