RL MARKETING (CIS) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | RL MARKETING (CIS) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03390839 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe RL MARKETING (CIS) LIMITED ?
| Adresse du siège social | 80 Fenchurch Street EC3M 4BY London United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de RL MARKETING (CIS) LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour RL MARKETING (CIS) LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 25 juin 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 09 juil. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 25 juin 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour RL MARKETING (CIS) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Cessation de la nomination de Jon Scott Glen en tant que directeur le 25 mars 2026 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Ian Williams en tant qu'administrateur le 25 mars 2026 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2024 | 12 pages | AA | ||
legacy | 233 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
Déclaration de confirmation établie le 25 juin 2025 avec mises à jour | 3 pages | CS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 23 mai 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2023 | 12 pages | AA | ||
legacy | 223 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
Déclaration de confirmation établie le 23 mai 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jon Scott Glen le 26 juin 2023 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des détails de The Royal London Mutual Insurance Society Limied en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 26 juin 2023 | 2 pages | PSC05 | ||
Modification des coordonnées du secrétaire Royal London Management Services Limited le 26 juin 2023 | 1 pages | CH04 | ||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré 80 Fenchurch Street London EC3M 4BY | 1 pages | AD04 | ||
Déclaration de confirmation établie le 23 mai 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2022 | 18 pages | AA | ||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 55 Gracechurch Street London EC3V 0RL | 1 pages | AD03 | ||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 55 Gracechurch Street London EC3V 0RL | 1 pages | AD02 | ||
Changement d'adresse du siège social de 55 Gracechurch Street London EC3V 0RL à 80 Fenchurch Street London EC3M 4BY le 11 avr. 2023 | 1 pages | AD01 | ||
Cessation de la nomination de Martin Pierce Lewis en tant que directeur le 31 déc. 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2022 avec mises à jour | 3 pages | CS01 | ||
Deuxième dépôt de la déclaration de confirmation datée du 20 juin 2021 | 3 pages | RP04CS01 | ||
Qui sont les dirigeants de RL MARKETING (CIS) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL LONDON MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Secrétaire | Fenchurch Street EC3M 4BY London 80 United Kingdom |
| 106736010001 | ||||||||||
| WILLIAMS, Ian | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 4BY London 80 United Kingdom | United Kingdom | British | 293786500001 | |||||||||
| ELDRIDGE, Katherine Elizabeth | Secrétaire | 5 Stanley Avenue Hazel Grove SK7 4ED Stockport | British | 110230860001 | ||||||||||
| JONES, Ian Michael | Secrétaire | 37 Rosemary Drive WA12 0BQ Newton Le Willows Merseyside | British | 43978180001 | ||||||||||
| RUTTER, Mathew David | Secrétaire | 24 Gladys Road NW6 2PX London | British | 64949120001 | ||||||||||
| WADE, Patricia Anne | Secrétaire | 28 Hazel Road WA14 1JL Altrincham Cheshire | British | 35222860001 | ||||||||||
| WADE, Patricia Anne | Secrétaire | Hazel Road WA14 1JL Altrincham 28 Cheshire United Kingdom | 152972530001 | |||||||||||
| NORTON ROSE LIMITED | Secrétaire désigné | Kempson House P.O. Box 570, Camomile Street EC3A 7AN London | 900006420001 | |||||||||||
| BEAMISH, Phillip | Administrateur | Gracechurch Street EC3V 0RL London 55 England | United Kingdom | British | 180852470002 | |||||||||
| BEAMISH, Phillip | Administrateur | Gracechurch Street EC3V 0RL London 55 England | United Kingdom | British | 180852470002 | |||||||||
| BENNETT, Martyn Christopher | Administrateur | 24 Braemar Road Hazel Grove SK7 4QG Stockport Cheshire | British | 57876970001 | ||||||||||
| BULMER, Rodney Jensen | Administrateur | 9th Floor 1 Angel Square M60 0AG Manchester Corporate Governance United Kingdom | United Kingdom | British | 126018700001 | |||||||||
| BUNCH, Timothy Stephen | Administrateur | 21 Friars Garden SY8 1RX Ludlow Shropshire | British | 40570440002 | ||||||||||
| BURGESS, Rodney James | Administrateur | 31 Tandle Hill Road Royton OL2 5UX Oldham Lancashire | British | 63540550001 | ||||||||||
| CLARKE, Martin Gerald | Administrateur | South Beightons Shawclough Road OL12 7HL Rochdale Lancashire | United Kingdom | British | 73916370001 | |||||||||
| FAIRBAIRN, Michael David | Administrateur | 5th Floor, New Century House Corporation Street M60 4ES Manchester C/O Governance Department United Kingdom | United Kingdom | British | 73917950003 | |||||||||
| FRANKS, John | Administrateur | Pool Meadow South Park Drive SK12 1BS Poynton Cheshire | United Kingdom | British | 63264700002 | |||||||||
| FREELEY, Noel Anthony | Administrateur | Gracechurch Street EC3V 0RL London 55 | England | British | 213750360001 | |||||||||
| GLEN, Jon Scott | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 4BY London 80 United Kingdom | United Kingdom | British | 269660060001 | |||||||||
| GODDARD, Richard Thomas | Administrateur | 44 Woodlands Parkway Timperley WA15 7QU Altrincham Cheshire | England | British | 63087570001 | |||||||||
| GOSLING, Clare Louise | Administrateur | 5th Floor, New Century House Corporation Street M60 4ES Manchester C/O Governance Department United Kingdom | United Kingdom | British | 165618950001 | |||||||||
| GRATTAN, David | Administrateur | Holme Lea Stubley New Hall Littleborough OL15 Rochdale Lancashire | British | 78982530001 | ||||||||||
| GRIFFITH, Haydn | Administrateur | 275 Bolton Road Hawkshaw BL8 4JR Bury Lancashire | British | 73918010001 | ||||||||||
| HIRST, Christopher William Joseph | Administrateur | Kerridgeside Farm Hough Hole Rainow SK10 5UW Macclesfield Cheshire | British | 10291670001 | ||||||||||
| HOLLAS, David Stuart | Administrateur | 21 Beaufort Close SK9 7HU Alderley Edge Cheshire | England | British | 8500070001 | |||||||||
| HORSWELL, Michael Brian | Administrateur | 5 Cottesmore Gardens Hale Barnes WA15 8TS Altrincham Cheshire | British | 26879360001 | ||||||||||
| KOSLOWSKI, Alexander Rudolf Dieter | Administrateur | Gracechurch Street EC3V 0RL London 55 United Kingdom | United Kingdom | German | 187214120001 | |||||||||
| LEWIS, Barry Kenneth John | Administrateur | 210 Bramhall Moor Lane Hazel Grove SK7 5JJ Stockport Cheshire | British | 67170550001 | ||||||||||
| LEWIS, Martin Pierce | Administrateur | Gracechurch Street EC3V 0RL London 55 England | United Kingdom | British | 165812860001 | |||||||||
| MCKEOWN, Charles Francis | Administrateur | Wychwood Soss Moss SK10 4TU Nether Alderley Cheshire | England | British | 73918160001 | |||||||||
| NYAHASHA, Shingirai Thaddeus | Administrateur | Gracechurch Street EC3V 0RL London 55 | England | British | 190468580001 | |||||||||
| O'BOYLE, Finian | Administrateur | Ballimore Paddock Field SO20 6AU Chilbolton Hampshire | British | 85864520001 | ||||||||||
| O'REILLY, Anya Marjorie | Administrateur | Gracechurch Street EC3V 0RL London 55 England | United Kingdom | British | 175872320001 | |||||||||
| PATER, George Stephan, Mr. | Administrateur | Dalton House Carrwood Road SK9 5DL Wilmslow | United Kingdom | British | 105812250002 | |||||||||
| PORTMAN, Bryan Henry | Administrateur | Chesnam House Copthill Lane KT20 6HL Kingswood Surrey | British | 101234700001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur RL MARKETING (CIS) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Royal London Mutual Insurance Society Limied | 06 avr. 2016 | Fenchurch Street EC3M 4BY London 80 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0