GENIE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED

GENIE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGENIE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03391393
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GENIE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED ?

    • Crédit-bail (64910) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe GENIE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Maltings
    Wharf Road
    NG31 6BH Grantham
    Lincolnshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GENIE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MARCPRIME LIMITED24 juin 199724 juin 1997

    Quels sont les derniers comptes de GENIE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour GENIE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 24 juin 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Notification de Genie Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC02

    Nomination de John Daniel Sheehan en tant qu'administrateur le 27 févr. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kevin Patrick Bradley en tant que directeur le 27 févr. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Gerald Eugene Dougherty en tant que directeur le 20 oct. 2016

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 juil. 2016

    État du capital au 06 juil. 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cessation de la nomination de Ronald Matthew Defeo en tant que directeur le 11 déc. 2015

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 juin 2015

    État du capital au 25 juin 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2013

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 juil. 2014

    État du capital au 14 juil. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 juil. 2013

    État du capital après une attribution d'actions au 02 juil. 2013

    SH01

    Cessation de la nomination de Lawrence Lockwood en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Phillip Widman en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Lawrence Lockwood en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Kevin Patrick Bradley en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Matthew Sean Fearon en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Gerald Eugene Dougherty en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Lawrence Lockwood en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Timothy Ford en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de GENIE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COHEN, Eric I
    Burnham Hill Road
    Westport
    Connecticut, 06880
    32
    Fairfield
    Usa
    Secrétaire
    Burnham Hill Road
    Westport
    Connecticut, 06880
    32
    Fairfield
    Usa
    American65582430009
    COHEN, Eric I
    Burnham Hill Road
    Westport
    Connecticut, 06880
    32
    Fairfield
    Usa
    Administrateur
    Burnham Hill Road
    Westport
    Connecticut, 06880
    32
    Fairfield
    Usa
    United StatesAmerican65582430009
    FEARON, Matthew Sean
    Wharf Road
    NG31 6BH Grantham
    The Maltings
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Wharf Road
    NG31 6BH Grantham
    The Maltings
    Lincolnshire
    United Kingdom
    United StatesAmerican176771990001
    GEORGE, Joseph M.
    Bluff Road
    Eden Prairie
    10564
    Mn 55347
    Usa
    Administrateur
    Bluff Road
    Eden Prairie
    10564
    Mn 55347
    Usa
    United StatesAmerican156295130001
    JUNG, Matthias
    Ch-8260
    Stein Am Rhein
    Alte Zollstrasse 10
    Switzerland
    Administrateur
    Ch-8260
    Stein Am Rhein
    Alte Zollstrasse 10
    Switzerland
    SwitzerlandGerman159848410001
    SHEEHAN, John Daniel
    200 Nyala Farm Road
    06880 Westport
    C/O Terex Corporation
    Usa
    Administrateur
    200 Nyala Farm Road
    06880 Westport
    C/O Terex Corporation
    Usa
    United StatesAmerican226001330001
    DODEL, Craig
    3030 Ne 182nd
    98155 Seattle
    Wa
    Usa
    Secrétaire
    3030 Ne 182nd
    98155 Seattle
    Wa
    Usa
    U S Citizen61601480001
    LOCKWOOD, Lawrence Jay
    865 Lakewood Drive
    Rochester Hills
    Michigan 48309
    Usa
    Secrétaire
    865 Lakewood Drive
    Rochester Hills
    Michigan 48309
    Usa
    American109968340001
    MATUSCHAK, Stephen John
    6300 North Ridge Drive
    WA98290 Snohomish
    Washington
    Usa
    Secrétaire
    6300 North Ridge Drive
    WA98290 Snohomish
    Washington
    Usa
    Us Citizen54950900001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secrétaire désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    BENNETT, Mark
    22 Beech Drive
    NN13 6JH Brackley
    Northamptonshire
    Administrateur
    22 Beech Drive
    NN13 6JH Brackley
    Northamptonshire
    United KingdomBritish127744260001
    BRADLEY, Kevin Patrick
    Wharf Road
    NG31 6BH Grantham
    The Maltings
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Wharf Road
    NG31 6BH Grantham
    The Maltings
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Untied States Of AmericaAmerican176590390001
    BROWN, Frank Roger
    4155 143 Rd Ne
    Bellevue
    Wa 98155
    Administrateur
    4155 143 Rd Ne
    Bellevue
    Wa 98155
    American74340700001
    BUSHNELL, Sherman Ward
    4638 95th Avenue N E
    98004 Bellevue
    Wa
    Usa
    Administrateur
    4638 95th Avenue N E
    98004 Bellevue
    Wa
    Usa
    American61601390001
    CARTER, Jonathan David
    14 Terra Nova Circle
    Westport
    Ct 06880
    Usa
    Administrateur
    14 Terra Nova Circle
    Westport
    Ct 06880
    Usa
    British89145060001
    DEFEO, Ronald Matthew
    Beachside Avenue
    Westport
    45
    Connecticut 06880
    Usa
    Administrateur
    Beachside Avenue
    Westport
    45
    Connecticut 06880
    Usa
    United StatesAmerican94656950001
    DOUGHERTY, Gerald Eugene
    Wharf Road
    NG31 6BH Grantham
    The Maltings
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Wharf Road
    NG31 6BH Grantham
    The Maltings
    Lincolnshire
    United Kingdom
    UsaU.S. Citizen176771590001
    FEARON, Matthew Sean
    2609 226th Ave S E
    Sammamish
    Wa 98075
    Usa
    Administrateur
    2609 226th Ave S E
    Sammamish
    Wa 98075
    Usa
    United StatesAmerican176771990001
    FORD, Timothy
    6175 Sierra Circle
    Shorewood
    Mn 55331
    Usa
    Administrateur
    6175 Sierra Circle
    Shorewood
    Mn 55331
    Usa
    UsaAmerican116645520001
    KNOLL, Jerome C
    6051 78th Avenue N E
    NA98040 Mercer Island
    Washington
    Usa
    Administrateur
    6051 78th Avenue N E
    NA98040 Mercer Island
    Washington
    Usa
    Us Citizen54951090001
    LOCKWOOD, Lawrence Jay
    865 Lakewood Drive
    Rochester Hills
    Michigan 48309
    Usa
    Administrateur
    865 Lakewood Drive
    Rochester Hills
    Michigan 48309
    Usa
    UsaAmerican109968340001
    WIDMAN, Phillip Charles
    25 Old Stone Crossing
    West Simsbury
    Connecticut 06092
    Usa
    Administrateur
    25 Old Stone Crossing
    West Simsbury
    Connecticut 06092
    Usa
    UsaAmerican144249950001
    WILKERSON, Robert Ready
    4215 91st Ne
    Bellevue
    Wa 98004
    Usa
    Administrateur
    4215 91st Ne
    Bellevue
    Wa 98004
    Usa
    American59939290002
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Administrateur désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GENIE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Genie Uk Limited
    Wharf Road
    NG31 6BH Grantham
    The Maltings
    England
    06 avr. 2016
    Wharf Road
    NG31 6BH Grantham
    The Maltings
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement02452185
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    GENIE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security deed
    Créé le 15 août 2001
    Livré le 05 sept. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from powered access services limited (the company) to the chargee by virtue of its holding of "a" preference shares and/or "b" preference shares in the company pursuant to the company's articles of association adopted by special resolution passed on 15TH august 2001, in a maximum aggregate amount of not more than £400,000
    Brèves mentions
    Assignment by way of security of any receivables due to the assignor under clause 6.01(a) or (b) of the master hire purchase agreement in respect of goods identified in schedule 1 to the master hire purchase agreement dated 25TH may 2001.
    Personnes ayant droit
    • Fitzwise Limited
    Transactions
    • 05 sept. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Security deed
    Créé le 15 août 2001
    Livré le 31 août 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies becoming due and payable from time to time by powered access services limited (the "company") to the chargee by virtue of it's holding of "a" preference shares and/or "b" preference shares in the company pursuant to the company's articles of association adopted by a special resolution on 15TH august 2001 in a maximum aggregate of not more than £400,000 together with all proper costs charges and expenses of or incurred by the chargee pursuant to the debenture dated 15TH august 2001 and granted by the company to the mortgagee
    Brèves mentions
    All the company's right title and interest in and to the equipment and the relevant receivables and all benefits which may arise under the master hire agreement dated 25TH may 2001 between the company and genie financial services (europe) limited. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fitzwise Limited
    Transactions
    • 31 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Security assignment
    Créé le 29 déc. 1999
    Livré le 17 janv. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the master agreement dated 29TH december 1999 and funding schedules (being any documents described as a funding schedule and expressed to be supplementary to the master agreement) together with all other sums incuding costs and interest payable by the company pursuant to such master agreement and/or funding schedules
    Brèves mentions
    All the company's right title and interest in and to all equipment being the goods let under the terms of the agreements detailed under the charge between the company inclusive of all rights to claim all sums owing or to become owing by the hirer under or in respect of the hire agreements with the following references 1518,1519,1520,1521,1522,1523,1524,1525,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1540,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1526,1527,1516 and 1517 together with he proceeds of sale all rights under any licence and all other rights claims in respect of any equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Daimlerchrysler Capital Services (Debis) UK Limited
    Transactions
    • 17 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of assignment
    Créé le 16 déc. 1999
    Livré le 23 déc. 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of funding schedules and the master agreement dated 1 october 1999
    Brèves mentions
    The company assigns to heller the equipment and all the right title and interest of the company goods let under the terms of a funded hire agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Heller Global Vendor Finance UK Limited
    Transactions
    • 23 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of assignment
    Créé le 17 févr. 1999
    Livré le 08 mars 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the assignment and a master hire purchase agreement no.57854
    Brèves mentions
    All rights title and interest the contracts the contract earnings the insurances all moneys payable in respect of a totla loss all book and other debts due owing pauable or incurred to the company equipment hire agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lease Products Limited
    Transactions
    • 08 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0