GENIE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | GENIE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03391393 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GENIE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED ?
| Adresse du siège social | The Maltings Wharf Road NG31 6BH Grantham Lincolnshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GENIE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour GENIE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 juin 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Notification de Genie Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Nomination de John Daniel Sheehan en tant qu'administrateur le 27 févr. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Kevin Patrick Bradley en tant que directeur le 27 févr. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gerald Eugene Dougherty en tant que directeur le 20 oct. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 9 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Ronald Matthew Defeo en tant que directeur le 11 déc. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 juin 2015 avec liste complète des actionnaires | 9 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2013 | 11 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 juin 2014 avec liste complète des actionnaires | 9 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2012 | 13 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 juin 2013 avec liste complète des actionnaires | 9 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Lawrence Lockwood en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Phillip Widman en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Lawrence Lockwood en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Kevin Patrick Bradley en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Matthew Sean Fearon en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Gerald Eugene Dougherty en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Lawrence Lockwood en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Timothy Ford en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de GENIE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COHEN, Eric I | Secrétaire | Burnham Hill Road Westport Connecticut, 06880 32 Fairfield Usa | American | 65582430009 | ||||||
| COHEN, Eric I | Administrateur | Burnham Hill Road Westport Connecticut, 06880 32 Fairfield Usa | United States | American | 65582430009 | |||||
| FEARON, Matthew Sean | Administrateur | Wharf Road NG31 6BH Grantham The Maltings Lincolnshire United Kingdom | United States | American | 176771990001 | |||||
| GEORGE, Joseph M. | Administrateur | Bluff Road Eden Prairie 10564 Mn 55347 Usa | United States | American | 156295130001 | |||||
| JUNG, Matthias | Administrateur | Ch-8260 Stein Am Rhein Alte Zollstrasse 10 Switzerland | Switzerland | German | 159848410001 | |||||
| SHEEHAN, John Daniel | Administrateur | 200 Nyala Farm Road 06880 Westport C/O Terex Corporation Usa | United States | American | 226001330001 | |||||
| DODEL, Craig | Secrétaire | 3030 Ne 182nd 98155 Seattle Wa Usa | U S Citizen | 61601480001 | ||||||
| LOCKWOOD, Lawrence Jay | Secrétaire | 865 Lakewood Drive Rochester Hills Michigan 48309 Usa | American | 109968340001 | ||||||
| MATUSCHAK, Stephen John | Secrétaire | 6300 North Ridge Drive WA98290 Snohomish Washington Usa | Us Citizen | 54950900001 | ||||||
| HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||
| BENNETT, Mark | Administrateur | 22 Beech Drive NN13 6JH Brackley Northamptonshire | United Kingdom | British | 127744260001 | |||||
| BRADLEY, Kevin Patrick | Administrateur | Wharf Road NG31 6BH Grantham The Maltings Lincolnshire United Kingdom | Untied States Of America | American | 176590390001 | |||||
| BROWN, Frank Roger | Administrateur | 4155 143 Rd Ne Bellevue Wa 98155 | American | 74340700001 | ||||||
| BUSHNELL, Sherman Ward | Administrateur | 4638 95th Avenue N E 98004 Bellevue Wa Usa | American | 61601390001 | ||||||
| CARTER, Jonathan David | Administrateur | 14 Terra Nova Circle Westport Ct 06880 Usa | British | 89145060001 | ||||||
| DEFEO, Ronald Matthew | Administrateur | Beachside Avenue Westport 45 Connecticut 06880 Usa | United States | American | 94656950001 | |||||
| DOUGHERTY, Gerald Eugene | Administrateur | Wharf Road NG31 6BH Grantham The Maltings Lincolnshire United Kingdom | Usa | U.S. Citizen | 176771590001 | |||||
| FEARON, Matthew Sean | Administrateur | 2609 226th Ave S E Sammamish Wa 98075 Usa | United States | American | 176771990001 | |||||
| FORD, Timothy | Administrateur | 6175 Sierra Circle Shorewood Mn 55331 Usa | Usa | American | 116645520001 | |||||
| KNOLL, Jerome C | Administrateur | 6051 78th Avenue N E NA98040 Mercer Island Washington Usa | Us Citizen | 54951090001 | ||||||
| LOCKWOOD, Lawrence Jay | Administrateur | 865 Lakewood Drive Rochester Hills Michigan 48309 Usa | Usa | American | 109968340001 | |||||
| WIDMAN, Phillip Charles | Administrateur | 25 Old Stone Crossing West Simsbury Connecticut 06092 Usa | Usa | American | 144249950001 | |||||
| WILKERSON, Robert Ready | Administrateur | 4215 91st Ne Bellevue Wa 98004 Usa | American | 59939290002 | ||||||
| HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Administrateur désigné | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GENIE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genie Uk Limited | 06 avr. 2016 | Wharf Road NG31 6BH Grantham The Maltings England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
GENIE FINANCIAL SERVICES EUROPE LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Security deed | Créé le 15 août 2001 Livré le 05 sept. 2001 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from powered access services limited (the company) to the chargee by virtue of its holding of "a" preference shares and/or "b" preference shares in the company pursuant to the company's articles of association adopted by special resolution passed on 15TH august 2001, in a maximum aggregate amount of not more than £400,000 | |
Brèves mentions Assignment by way of security of any receivables due to the assignor under clause 6.01(a) or (b) of the master hire purchase agreement in respect of goods identified in schedule 1 to the master hire purchase agreement dated 25TH may 2001. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Security deed | Créé le 15 août 2001 Livré le 31 août 2001 | En cours | Montant garanti All monies becoming due and payable from time to time by powered access services limited (the "company") to the chargee by virtue of it's holding of "a" preference shares and/or "b" preference shares in the company pursuant to the company's articles of association adopted by a special resolution on 15TH august 2001 in a maximum aggregate of not more than £400,000 together with all proper costs charges and expenses of or incurred by the chargee pursuant to the debenture dated 15TH august 2001 and granted by the company to the mortgagee | |
Brèves mentions All the company's right title and interest in and to the equipment and the relevant receivables and all benefits which may arise under the master hire agreement dated 25TH may 2001 between the company and genie financial services (europe) limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Security assignment | Créé le 29 déc. 1999 Livré le 17 janv. 2000 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the master agreement dated 29TH december 1999 and funding schedules (being any documents described as a funding schedule and expressed to be supplementary to the master agreement) together with all other sums incuding costs and interest payable by the company pursuant to such master agreement and/or funding schedules | |
Brèves mentions All the company's right title and interest in and to all equipment being the goods let under the terms of the agreements detailed under the charge between the company inclusive of all rights to claim all sums owing or to become owing by the hirer under or in respect of the hire agreements with the following references 1518,1519,1520,1521,1522,1523,1524,1525,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1540,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1526,1527,1516 and 1517 together with he proceeds of sale all rights under any licence and all other rights claims in respect of any equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of assignment | Créé le 16 déc. 1999 Livré le 23 déc. 1999 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of funding schedules and the master agreement dated 1 october 1999 | |
Brèves mentions The company assigns to heller the equipment and all the right title and interest of the company goods let under the terms of a funded hire agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of assignment | Créé le 17 févr. 1999 Livré le 08 mars 1999 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the assignment and a master hire purchase agreement no.57854 | |
Brèves mentions All rights title and interest the contracts the contract earnings the insurances all moneys payable in respect of a totla loss all book and other debts due owing pauable or incurred to the company equipment hire agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0