HOLAW (403) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHOLAW (403) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03399040
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HOLAW (403) LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe HOLAW (403) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    5th Floor Leconfield House
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de HOLAW (403) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mai 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour HOLAW (403) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 04 juil. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mai 2019

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juil. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mai 2018

    17 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juil. 2018 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mai 2017

    16 pagesAA

    Nomination de Mr Michael David Watson en tant qu'administrateur le 13 nov. 2017

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 04 juil. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mai 2016

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juil. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Vincent Aziz Tchenguiz le 01 juil. 2016

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 mai 2015

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 juil. 2015

    État du capital au 20 juil. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mai 2014

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 juil. 2014

    État du capital au 30 juil. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mai 2013

    13 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Vincent Aziz Tchenguiz le 08 oct. 2013

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 juil. 2013

    État du capital après une attribution d'actions au 19 juil. 2013

    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mai 2012

    14 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de HOLAW (403) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TCHENGUIZ, Robert
    Royal College Of Organists
    26 Kensington Gore
    SW7 2ET London
    Administrateur
    Royal College Of Organists
    26 Kensington Gore
    SW7 2ET London
    EnglandBritish74322720004
    TCHENGUIZ, Vincent Aziz
    Floor Leconfield House
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    5th
    Administrateur
    Floor Leconfield House
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    5th
    United KingdomBritish,71890500005
    WATSON, Michael David
    Floor Leconfield House
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    5th
    Administrateur
    Floor Leconfield House
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    5th
    EnglandBritish63440350001
    INGHAM, Michael Harry Peter
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    Secrétaire
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    British2739650001
    BRECHIN PLACE SECRETARIES LIMITED
    31 Brechin Place
    SW7 4QD London
    Secrétaire
    31 Brechin Place
    SW7 4QD London
    55869520003
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secrétaire désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BRECHIN PLACE DIRECTORS LIMITED
    31 Brechin Place
    SW7 4QD London
    Administrateur
    31 Brechin Place
    SW7 4QD London
    83890670001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Administrateur désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HOLAW (403) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Rotch Properties Limited
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    Leconfield House
    England
    06 avr. 2016
    Curzon Street
    W1J 5JA London
    Leconfield House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement02384071
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    HOLAW (403) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Rental assignment
    Créé le 10 août 2004
    Livré le 13 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right title benefit and interest (whether present or future) in and to all rents. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Standard Life Assurance Company
    Transactions
    • 13 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental charge relating to an original charge dated 7TH june 1998
    Créé le 10 août 2004
    Livré le 13 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H land on the west side of ferrers road south woodham ferrers chelmsford essex t/no: EX465995.
    Personnes ayant droit
    • Standard Life Assurance Company
    Transactions
    • 13 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rental assignment
    Créé le 30 juin 1998
    Livré le 04 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement as defined
    Brèves mentions
    All its right title benefit and interest (whether present or future) in and to all rents as therein defined. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Standard Life Assurance Company
    Transactions
    • 04 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 30 juin 1998
    Livré le 04 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the west side of ferrers road south woodham ferrers chelmsford essex t/no: EX465995 floating charge over its present and future. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Standard Life Assurance Company
    Transactions
    • 04 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental deed
    Créé le 03 déc. 1997
    Livré le 16 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group member to the chargee as trustee for itself and any other lender supplemental to the legal charge dated 5TH september 1996
    Brèves mentions
    All the l/h land and buildings on the west side of ferrers road south woodham ferrers essex t/no.EX465995 also k/a eastern industrial estate together with all buildings erections fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery. By way of floating charge the whole of the company's undertaking.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 16 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment by way of charge
    Créé le 03 déc. 1997
    Livré le 13 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies obligations and liabilities whatsoever which may now or at any time in the future be due owing or incurred by rotch property group limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of rotch property group limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company (group member) to the chargee as trustee for itself and the other lenders (trustee) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies from time to time due owing or incurred to the company under the occupational lease/s in respect of l/h land and buildings on the west side of ferrers road south woodham ferrers essex t/no.EX465995 also k/a eastern industrial estate. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transactions
    • 13 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0