BMP ASSOCIATES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBMP ASSOCIATES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03399962
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BMP ASSOCIATES LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe BMP ASSOCIATES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Fore Royal
    Gorley Road
    BH24 3LD Ringwood
    Hampshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de BMP ASSOCIATES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour BMP ASSOCIATES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 30 nov. 2017

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2016

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 juil. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2015

    12 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 juil. 2016 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 juil. 2016

    État du capital au 06 juil. 2016

    • Capital: GBP 1,750,000
    SH01

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 25 janv. 2016

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 12 août 2015

    2 pages3.6

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    5 pagesRM02

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2014

    13 pagesAA

    Cessation de la nomination de David James Bull en tant que directeur le 06 nov. 2014

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    17 pagesAA

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 juil. 2014

    État du capital au 28 juil. 2014

    • Capital: GBP 1,750,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 août 2013

    État du capital après une attribution d'actions au 06 août 2013

    SH01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Qui sont les dirigeants de BMP ASSOCIATES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    IRESON, Christie Joelle
    Fore Royal Gorley Road
    Linbrook
    BH24 3LD Ringwood
    Hampshire
    Secrétaire
    Fore Royal Gorley Road
    Linbrook
    BH24 3LD Ringwood
    Hampshire
    British105296040001
    FANELLI, Nicola
    Fore Royal
    Gorley Road Rockford
    BH24 3LD Ringwood
    Hampshire
    Administrateur
    Fore Royal
    Gorley Road Rockford
    BH24 3LD Ringwood
    Hampshire
    EnglandItalian63908350002
    ANDERSON, Colin
    Beacon House
    15 Christchurch Road
    BH1 3LB Bournemouth
    Dorset
    Secrétaire
    Beacon House
    15 Christchurch Road
    BH1 3LB Bournemouth
    Dorset
    British80202100001
    BULL, David James
    40 Chilfrome Close
    BH17 9WE Poole
    Dorset
    Secrétaire
    40 Chilfrome Close
    BH17 9WE Poole
    Dorset
    British44811930002
    KEY LEGAL SERVICES (SECRETARIAL) LIMITED
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    Secrétaire désigné
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    900004240001
    BULL, David James
    40 Chilfrome Close
    BH17 9WE Poole
    Dorset
    Administrateur
    40 Chilfrome Close
    BH17 9WE Poole
    Dorset
    EnglandBritish44811930002
    CORTI, Massimo
    Via R Simen 9
    6830 Chiasso
    FOREIGN Switzerland
    Administrateur
    Via R Simen 9
    6830 Chiasso
    FOREIGN Switzerland
    Swiss46512650001
    SIA, Francesca
    Flat 42 Forest House
    1 Russell Cotes Road
    BN1 3UB Bournemouth
    Dorset
    Administrateur
    Flat 42 Forest House
    1 Russell Cotes Road
    BN1 3UB Bournemouth
    Dorset
    Italian60976240001
    CONSULTANCY AND ADVISORY BUREAU LIMITED
    Beacon House
    15 Christchurch Road
    BH1 3LB Bournemouth
    Dorset
    Administrateur
    Beacon House
    15 Christchurch Road
    BH1 3LB Bournemouth
    Dorset
    64583810001
    HELITING COMPANY ADMINISTRATION LIMITED
    Beacon House
    15 Christchurch Road
    BH1 3LB Bournemouth
    Administrateur
    Beacon House
    15 Christchurch Road
    BH1 3LB Bournemouth
    66523600001
    KEY LEGAL SERVICES (NOMINEES) LIMITED
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    Administrateur désigné
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    900004230001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BMP ASSOCIATES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Cesare Romiti
    Gorley Road
    BH24 3LD Ringwood
    Fore Royal
    Hampshire
    06 avr. 2016
    Gorley Road
    BH24 3LD Ringwood
    Fore Royal
    Hampshire
    Non
    Nationalité: Italian
    Pays de résidence: Italy
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    BMP ASSOCIATES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture deed
    Créé le 18 nov. 2009
    Livré le 19 nov. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    Mortgage
    Créé le 13 mars 2008
    Livré le 15 mars 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a miller house 43-51 lower stone street maidstone kent together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 15 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 120 août 2014Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
    • 105 févr. 2016Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
    • 105 févr. 2016Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
      • Numéro de dossier 1
    Legal charge
    Créé le 22 juin 2007
    Livré le 04 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £250,000 due or to become due from the company to
    Brèves mentions
    F/H miller house 43/51 lower stone street maidstone kent.
    Personnes ayant droit
    • Dansk-Europaeisk Finansiering Aps
    Transactions
    • 04 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 06 juin 2005
    Livré le 07 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    A maximum of £1,000,000 due or to become due from the company to
    Brèves mentions
    Property k/a miller house, 43/51 lower stone street, maidstone, kent. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • Dansk-Europaeisk Finansiering Aps
    Transactions
    • 07 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 29 sept. 1997
    Livré le 14 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement
    Brèves mentions
    F/H property k/a 64-94 (even) attleborough road nuneaton warwickshire t/no WK327343 by way of floating charge all chattels fittings and other property ands assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Finzak Bv
    Transactions
    • 14 oct. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 09 sept. 1997
    Livré le 11 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property known as unit 2 meadowcourt phase 2 meadowhall road sheffie ld t/n syk 338705. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 11 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 28 juil. 1997
    Livré le 30 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a 149/165 victoria road aldershot hampshire t/n hp 353912. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 30 juil. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    BMP ASSOCIATES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Stephen Michael Skinner
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    receiver manager
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Chris Wakeman
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    receiver manager
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0