BLUE FRAME LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBLUE FRAME LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03407555
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BLUE FRAME LIMITED ?

    • (1730) /
    • (5142) /

    Où se situe BLUE FRAME LIMITED ?

    Adresse du siège social
    No 1 Whitehall Riverside
    LS1 4BN Leeds
    West Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BLUE FRAME LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DESIGNDOCK LIMITED23 juil. 199723 juil. 1997

    Quels sont les derniers comptes de BLUE FRAME LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au01 sept. 2006

    Quels sont les derniers dépôts pour BLUE FRAME LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    10 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 11 juin 2013

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 11 déc. 2012

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 11 juin 2012

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 11 déc. 2011

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 11 juin 2011

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 11 déc. 2010

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 11 juin 2010

    5 pages4.68

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 10 juin 2009

    9 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    9 pages2.34B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 19 déc. 2008

    7 pages2.24B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    9 pages2.16B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    20 pages2.17B

    Certificat de changement de nom

    Company name changed designdock LIMITED\certificate issued on 29/07/08
    2 pagesCERTNM

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Comptes complets modifiés jusqu'au 01 sept. 2006

    19 pagesAAMD

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages287

    Qui sont les dirigeants de BLUE FRAME LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FLEMING, Niall Patrick
    1 Silver Birch Drive
    Wythall
    B47 5RB Birmingham
    Wentworth Cottage
    West Midlands
    Administrateur
    1 Silver Birch Drive
    Wythall
    B47 5RB Birmingham
    Wentworth Cottage
    West Midlands
    EnglandBritishDirector68523330001
    LEE, Denzil, Mr.
    Old Rectory
    Station Road
    LU7 0SG Cheddington
    Bedfordshire
    Administrateur
    Old Rectory
    Station Road
    LU7 0SG Cheddington
    Bedfordshire
    United KingdomBritishDirector78382650001
    BELL, Douglas Frank Anthony
    8 Linnet Hill
    Mickleover
    DE3 0SJ Derby
    Secrétaire
    8 Linnet Hill
    Mickleover
    DE3 0SJ Derby
    BritishCompany Secretary58998430003
    MORRIS, Daniel Ian
    2 Cedar Crescent
    OX9 2AU Thame
    Oxfordshire
    Secrétaire
    2 Cedar Crescent
    OX9 2AU Thame
    Oxfordshire
    BritishDirector54334310002
    WHITING, Clare Elizabeth
    71 Derby Road
    Duffield
    DE56 4FL Belper
    Derbyshire
    Secrétaire
    71 Derby Road
    Duffield
    DE56 4FL Belper
    Derbyshire
    BritishAccountant57297680001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BELL, Douglas Frank Anthony
    8 Linnet Hill
    Mickleover
    DE3 0SJ Derby
    Administrateur
    8 Linnet Hill
    Mickleover
    DE3 0SJ Derby
    BritishCompany Secretary58998430003
    JONES, John Martin
    Apartment 2 Norwood Ely Road
    Llandaff
    CF5 2JE Cardiff
    Administrateur
    Apartment 2 Norwood Ely Road
    Llandaff
    CF5 2JE Cardiff
    United KingdomBritishCompany Director79493970002
    MELLOR, Sarah
    21 Mallory Close
    S41 9EW Chesterfield
    Derbyshire
    Administrateur
    21 Mallory Close
    S41 9EW Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritishCompany Director117779400001
    MORRIS, Daniel Ian
    2 Cedar Crescent
    OX9 2AU Thame
    Oxfordshire
    Administrateur
    2 Cedar Crescent
    OX9 2AU Thame
    Oxfordshire
    EnglandBritishC E O54334310002
    ROBERTSON, Nicole
    97 Burnham Way
    Ealing
    W13 9YB London
    Administrateur
    97 Burnham Way
    Ealing
    W13 9YB London
    BritishDirector115658000001
    THALMANN, Aaron Frank
    63 Arthur Street
    DE1 3EJ Derby
    Administrateur
    63 Arthur Street
    DE1 3EJ Derby
    BritishCompany Director82610260002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    BLUE FRAME LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture and guarantee
    Créé le 09 sept. 2006
    Livré le 19 sept. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or the principal to the chargee and/or any of the other investors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Octopus Investments Limited
    Transactions
    • 19 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture & guarantee
    Créé le 09 sept. 2006
    Livré le 19 sept. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or the principal to the chargee and/or any of the other investors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aaron Thalmann
    Transactions
    • 19 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 09 sept. 2006
    Livré le 15 sept. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 15 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 13 juin 2006
    Livré le 20 juin 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 juin 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 23 déc. 2003
    Livré le 30 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Venture Finance PLC
    Transactions
    • 30 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juin 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 15 avr. 2003
    Livré le 28 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 26 mars 2003
    Livré le 01 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Business tracker account, no: 30138940. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    BLUE FRAME LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    12 juin 2009Administration ended
    20 juin 2008Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Keith Hinds
    Grant Thornton Uk Llp
    No 1 Whitehall Riverside,Whitehall Road
    LS1 4BN Leeds
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    No 1 Whitehall Riverside,Whitehall Road
    LS1 4BN Leeds
    Joseph Peter Francis Mclean
    Grant Thornton Uk Llp
    1 Whitehall Riverside,Whitehall Road
    LS1 4BN Leeds
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    1 Whitehall Riverside,Whitehall Road
    LS1 4BN Leeds
    2
    DateType
    12 déc. 2013Dissolved on
    12 juin 2009Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Keith Hinds
    Grant Thornton Uk Llp
    No 1 Whitehall Riverside,Whitehall Road
    LS1 4BN Leeds
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    No 1 Whitehall Riverside,Whitehall Road
    LS1 4BN Leeds
    Joseph Peter Francis Mclean
    Grant Thornton Uk Llp
    1 Whitehall Riverside,Whitehall Road
    LS1 4BN Leeds
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    1 Whitehall Riverside,Whitehall Road
    LS1 4BN Leeds

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0